PAPER PEOPLE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPAPER PEOPLE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00133171
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PAPER PEOPLE LIMITED ?

    • (7499) /
    • (9999) /

    Où se situe PAPER PEOPLE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PAPER PEOPLE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PROTALIS LIMITED08 juil. 200308 juil. 2003
    POLLOCK & SEARBY LIMITED02 juin 191402 juin 1914

    Quels sont les derniers comptes de PAPER PEOPLE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour PAPER PEOPLE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 févr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    14 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur James Henry Arrowsmith le 01 janv. 2010

    3 pagesCH01

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    État du capital au 17 févr. 2010

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Cessation de la nomination de Martine Coiquaud en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Edouard Charles Maxime Maruani en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2008

    4 pagesAA

    legacy

    5 pages363a

    legacy

    2 pages353a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages287

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    4 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 31 déc. 2006

    4 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Qui sont les dirigeants de PAPER PEOPLE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ABOGADO NOMINEES LIMITED
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    Secrétaire
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    73539350001
    ARROWSMITH, James Henry
    7 Windermere Gardens
    SO24 9NL Alresford
    Hampshire
    Administrateur
    7 Windermere Gardens
    SO24 9NL Alresford
    Hampshire
    United KingdomBritishDirector Of Strategic Projects78416160001
    MARUANI, Edouard Charles Maxime
    12 Rue Des Crocheteurs
    Antony
    92160
    France
    Administrateur
    12 Rue Des Crocheteurs
    Antony
    92160
    France
    FranceFrenchLawyer148232930001
    BENNETT, Jonathan Gregory
    11 Hall Dale Close
    Hall Green
    B28 0XH Birmingham
    West Midlands
    Secrétaire
    11 Hall Dale Close
    Hall Green
    B28 0XH Birmingham
    West Midlands
    British101111560001
    BIRCHALL, Arthur James
    13 Normanhurst Drive
    St Margarets
    TW1 1NA Twickenham
    Middlesex
    Secrétaire
    13 Normanhurst Drive
    St Margarets
    TW1 1NA Twickenham
    Middlesex
    BritishCompany Secretary40911100002
    FILMER, Colin Booth
    Holly House Duke Street
    Micheldever
    SO21 3DF Winchester
    Hampshire
    Secrétaire
    Holly House Duke Street
    Micheldever
    SO21 3DF Winchester
    Hampshire
    British3103300001
    PORTER, Margaret Ann
    The Zurich Centre
    3000 Parkway, Whiteley
    PO15 7JZ Fareham
    Hampshire
    Secrétaire
    The Zurich Centre
    3000 Parkway, Whiteley
    PO15 7JZ Fareham
    Hampshire
    British63664390003
    BEYLIER, Philippe Rene Marie Joseph
    42 Rue De L'Yvette
    Paris 75016
    France
    Administrateur
    42 Rue De L'Yvette
    Paris 75016
    France
    FrenchCompany Director21760150001
    BITTNER, Thomas Wolfgang Nicholas
    10 Rue De Franqueville
    FOREIGN Paris 75116
    France
    Administrateur
    10 Rue De Franqueville
    FOREIGN Paris 75116
    France
    GermanDivisional Ceo17501130001
    CANDLER, Courtney
    Lyburn House
    Darnford Lane
    WS14 9LB Whittington
    Staffordshire
    Administrateur
    Lyburn House
    Darnford Lane
    WS14 9LB Whittington
    Staffordshire
    United KingdomBritishCompany Director80147160001
    CANT, Lynda
    28 Lomond Close
    Oakley
    RG23 7NA Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    28 Lomond Close
    Oakley
    RG23 7NA Basingstoke
    Hampshire
    EnglandBritishDirector Of Human Resources63420930001
    COIQUAUD, Martine Francine
    24 Rue Keller
    FOREIGN Paris (11)
    75011
    France
    Administrateur
    24 Rue Keller
    FOREIGN Paris (11)
    75011
    France
    FrenchGeneral Counsel126665590001
    COOPER, Malcolm Alexander
    11 Chattis Hill Stables
    Spitfire Lane
    SO20 6JS Stockbridge
    Hampshire
    Administrateur
    11 Chattis Hill Stables
    Spitfire Lane
    SO20 6JS Stockbridge
    Hampshire
    BritishBuisness Development Director40948650001
    CUBBON, James Henry
    The Coach House
    Hammer Lane, Grayshott
    GU26 6JD Hindhead
    Surrey
    Administrateur
    The Coach House
    Hammer Lane, Grayshott
    GU26 6JD Hindhead
    Surrey
    EnglandBritishOperations Director Uk And Ire47485650002
    DAVIES, Robin Peter Drury
    Meadow Rise
    Hunton Sutton Scotney
    SO21 3PS Winchester
    Hampshire
    Administrateur
    Meadow Rise
    Hunton Sutton Scotney
    SO21 3PS Winchester
    Hampshire
    BritishSolicitor & Company Secretary1330380001
    FOX, Michael John Dundas
    Copper Beaches Brislands Lane
    Four Marks
    GU34 5AE Alton
    Hants
    Administrateur
    Copper Beaches Brislands Lane
    Four Marks
    GU34 5AE Alton
    Hants
    BritishPaper Merchant4779950001
    GILLIE, Martin Calder
    Towngate Farmhouse
    Wield Road Medstead
    GU34 5LY Alton
    Hampshire
    Administrateur
    Towngate Farmhouse
    Wield Road Medstead
    GU34 5LY Alton
    Hampshire
    EnglandBritishAccountant25571210001
    GRIFFITHS, Graham John
    29 Bullimore Grove
    CV8 2QF Kenilworth
    Warwickshire
    Administrateur
    29 Bullimore Grove
    CV8 2QF Kenilworth
    Warwickshire
    BritishCompany Director11155440001
    HARRISON, Giles Alastair
    43 Curtis Road
    GU34 2SD Alton
    Hampshire
    Administrateur
    43 Curtis Road
    GU34 2SD Alton
    Hampshire
    EnglandBritishFinance Director64505750002
    JONES, Richard Charles Toogood
    29 Crofton Close
    Highfield
    SO17 1XB Southampton
    Hampshire
    Administrateur
    29 Crofton Close
    Highfield
    SO17 1XB Southampton
    Hampshire
    United KingdomBritishAccountant26233040002
    KNAPP, Peter John Richard
    9 Angel Meadows
    Odiham
    RG29 1AR Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    9 Angel Meadows
    Odiham
    RG29 1AR Basingstoke
    Hampshire
    BritishInformation & Budget Manager40963970001
    MINNS, Richard John
    Roseacre Bighton Road
    Medstead
    GU34 5ND Alton
    Hampshire
    Administrateur
    Roseacre Bighton Road
    Medstead
    GU34 5ND Alton
    Hampshire
    BritishLogistics Directors145955400001
    SPRINGALL, Keith John
    6 Mizen Close
    KT11 2RJ Cobham
    Surrey
    Administrateur
    6 Mizen Close
    KT11 2RJ Cobham
    Surrey
    BritishChartered Accountant67065490001
    SWAINSTON, Anthony Henry
    207 Woodstock Road
    OX2 7AB Oxford
    Oxfordshire
    Administrateur
    207 Woodstock Road
    OX2 7AB Oxford
    Oxfordshire
    BritishAccountant294920001

    PAPER PEOPLE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Dead of subsitution
    Créé le 18 sept. 1987
    Livré le 21 sept. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Sterling pounds 50000 and all all monies due or to become due from the company to the chargee which is supplemental its the principal deeds (as defixed)
    Brèves mentions
    F/H property k/a 38 edgar street hereford.
    Personnes ayant droit
    • Eagle Star Insurance Company Limited
    Transactions
    • 21 sept. 1987Enregistrement d'une charge
    • 18 déc. 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 25 mars 1987
    Livré le 10 avr. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit 9B brick knoll park st albans hertfordshire t/n hd 171201.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 avr. 1987Enregistrement d'une charge
    • 12 nov. 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 24 juin 1983
    Livré le 06 juil. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold unit 9B brick knoll park, st albans herts.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Merchant Bank Limited
    Transactions
    • 06 juil. 1983Enregistrement d'une charge
    • 12 nov. 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Further guarantee and debenture
    Créé le 09 sept. 1981
    Livré le 17 sept. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named terein to the charge onany account whatsoever.
    Brèves mentions
    All the property undertaking and assets charged by the principal deed and further deed.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 17 sept. 1981Enregistrement d'une charge
    • 12 nov. 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Further guarantee debenture
    Créé le 15 avr. 1977
    Livré le 04 mai 1977
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from and/or all or anyofthhe other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that property undertaking and assets charged by the principal deed and further deed.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 04 mai 1977Enregistrement d'une charge
    • 12 nov. 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Further charge
    Créé le 28 mars 1977
    Livré le 01 avr. 1977
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Sterling pounds 50000 & all other monies due or to become due from the company to the chargee secured by a charge dated 01/06/66
    Brèves mentions
    46 and 48 webber street london SE1.
    Personnes ayant droit
    • Eagle Star Insurance Comapny LTD
    Transactions
    • 01 avr. 1977Enregistrement d'une charge
    • 18 déc. 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 25 juil. 1975
    Livré le 11 août 1975
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or all or any of the other companies named therein
    Brèves mentions
    Units 9 and 10 on the industrial estate mill lane alton hampshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 août 1975Enregistrement d'une charge
    • 12 nov. 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 31 janv. 1975
    Livré le 11 févr. 1975
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or other companies named therein on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge on the undertaking and all property and assets prescent and future including goodwill uncalled capital. (Please see doc 110).
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 févr. 1975Enregistrement d'une charge
    • 12 nov. 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 01 juin 1966
    Livré le 03 juin 1966
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Sterling pounds 28000 and way other moneys due etc
    Brèves mentions
    46 x 48 webbes st, london SE1.
    Personnes ayant droit
    • Eagle Star Insurance Company LTD
    Transactions
    • 03 juin 1966Enregistrement d'une charge
    • 18 déc. 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0