SOUTHDOWN MOTOR SERVICES LIMITED

SOUTHDOWN MOTOR SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSOUTHDOWN MOTOR SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00140534
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SOUTHDOWN MOTOR SERVICES LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe SOUTHDOWN MOTOR SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Stagecoach Services Limited One Stockport Exchange
    20 Railway Road
    SK1 3SW Stockport
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SOUTHDOWN MOTOR SERVICES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SUSSEX COASTLINE BUSES LIMITED02 avr. 199202 avr. 1992
    SOUTHDOWN MOTOR SERVICES LIMITED02 juin 191502 juin 1915

    Quels sont les derniers comptes de SOUTHDOWN MOTOR SERVICES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au01 mai 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour SOUTHDOWN MOTOR SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 09 mai 2022

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes pour une société dormante établis au 01 mai 2021

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 22 sept. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 02 mai 2020

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 22 sept. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2019

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 22 sept. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Bruce Dingwall en tant qu'administrateur le 31 mai 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Colin Brown en tant que directeur le 31 mai 2019

    1 pagesTM01

    Nomination de Karen Rosaleen Robbins en tant qu'administrateur le 31 mai 2019

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2018

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 22 sept. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2017

    4 pagesAA

    Modification des détails de West Sussex Buses Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 16 nov. 2017

    2 pagesPSC05

    Changement d'adresse du siège social de C/O Stagecoach Services Ltd Daw Bank Stockport Cheshire SK3 0DU à C/O Stagecoach Services Limited One Stockport Exchange 20 Railway Road Stockport SK1 3SW le 16 nov. 2017

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 22 sept. 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2016

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 16 sept. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2015

    4 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de SOUTHDOWN MOTOR SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    VAUX, Michael John
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    British137383880001
    DINGWALL, Bruce Maxwell
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Administrateur
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant185252790001
    ROBBINS, Karen Rosaleen
    Chendre Close
    Hayfield
    SK22 2PH High Peak
    8
    Derbyshire
    England
    Administrateur
    Chendre Close
    Hayfield
    SK22 2PH High Peak
    8
    Derbyshire
    England
    EnglandBritishCompany Director73518280001
    HEAD, Michael Edward
    19 Felbridge Avenue
    RH10 7BD Crawley
    West Sussex
    Secrétaire
    19 Felbridge Avenue
    RH10 7BD Crawley
    West Sussex
    British59161160002
    REEVE, Michael John
    Yewcroft 28 Hammerwood Road
    Ashurst Wood
    RH19 3TG East Grinstead
    West Sussex
    Secrétaire
    Yewcroft 28 Hammerwood Road
    Ashurst Wood
    RH19 3TG East Grinstead
    West Sussex
    EnglishFinancial Controller2521430001
    STOGGELL, Martin Herbert
    119 Blackborough Road
    RH2 7DA Reigate
    Surrey
    Secrétaire
    119 Blackborough Road
    RH2 7DA Reigate
    Surrey
    BritishAccountant27504200001
    TYLER, Christopher Michael
    12 Delves Close
    Ringmer
    BN8 5JW Lewes
    East Sussex
    Secrétaire
    12 Delves Close
    Ringmer
    BN8 5JW Lewes
    East Sussex
    British54790510001
    WEBB, Forbes Waddington
    7 Firle Grange
    BN25 2HD Seaford
    East Sussex
    Secrétaire
    7 Firle Grange
    BN25 2HD Seaford
    East Sussex
    BritishFinance Director84060000001
    WHITNALL, Alan Leonard
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    Secrétaire
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    British54184420002
    WHITNALL, Alan Leonard
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    Secrétaire
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    British54184420002
    BROWN, Colin
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Administrateur
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant85970020003
    COCHRANE, Keith Robertson
    Glen Hall
    Belwood Park
    PH2 7AJ Perth
    Administrateur
    Glen Hall
    Belwood Park
    PH2 7AJ Perth
    BritishFinance Director47574960002
    COX, Anthony Geoffrey
    4 Keats Close
    Great Houghton
    NN4 7NX Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    4 Keats Close
    Great Houghton
    NN4 7NX Northampton
    Northamptonshire
    BritishCompany Director70180950001
    COX, Brian John
    Kirknewton House
    Kirknewton
    NE71 6XF Wooler
    Northumberland
    Administrateur
    Kirknewton House
    Kirknewton
    NE71 6XF Wooler
    Northumberland
    EnglandBritishExecutive Director1436830002
    COX, Brian John
    Little Crede Crede Lane
    Bosham
    PO18 8NX Chichester
    West Sussex
    Administrateur
    Little Crede Crede Lane
    Bosham
    PO18 8NX Chichester
    West Sussex
    BritishCompany Director1436830001
    DYER, Andrew William
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Administrateur
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director62948690004
    GLOAG, Ann Heron
    Kinfauns Castle
    PH2 7JZ Perth
    Perthshire
    Administrateur
    Kinfauns Castle
    PH2 7JZ Perth
    Perthshire
    ScotlandBritishCompany Director141120003
    GRIFFITHS, Martin Andrew
    Upland
    2 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    Administrateur
    Upland
    2 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    ScotlandBritishFinance Director61722690002
    HINKLEY, William Barry
    Mandalay
    Bassenthwaite
    CA12 4QG Keswick
    Cumbria
    Administrateur
    Mandalay
    Bassenthwaite
    CA12 4QG Keswick
    Cumbria
    EnglandBritishExecutive Director2268190002
    KINSKI, Michael John
    Cherry Tree House 268 Dunchurch Road
    CV22 6HX Rugby
    Warwickshire
    Administrateur
    Cherry Tree House 268 Dunchurch Road
    CV22 6HX Rugby
    Warwickshire
    United KingdomBritishGroup Chief Executive58643710001
    SOUTER, Brian
    Murrayfield House
    St Magdalenes Road
    PH2 0BT Perth
    Perthshire
    Administrateur
    Murrayfield House
    St Magdalenes Road
    PH2 0BT Perth
    Perthshire
    BritishCompany Director1436810001
    STOGGELL, Martin Herbert
    119 Blackborough Road
    RH2 7DA Reigate
    Surrey
    Administrateur
    119 Blackborough Road
    RH2 7DA Reigate
    Surrey
    BritishCompany Director27504200001
    TOPLIFF, Debra
    5 Warrenwood
    BN8 4JR North Chailey
    East Sussex
    Administrateur
    5 Warrenwood
    BN8 4JR North Chailey
    East Sussex
    BritishCompany Director119755060001
    WARNEFORD, Leslie Brian
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Administrateur
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishManaging Director49771140004
    WHITNALL, Alan Leonard
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    Administrateur
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    BritishCompany Director54184420002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SOUTHDOWN MOTOR SERVICES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    One Stockport Exchange
    20 Railway Road
    SK1 3SW Stockport
    C/O Stagecoach Services Limited
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    One Stockport Exchange
    20 Railway Road
    SK1 3SW Stockport
    C/O Stagecoach Services Limited
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleUnited Kingdom (England)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement01961491
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    SOUTHDOWN MOTOR SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 22 mai 1993
    Livré le 05 juin 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 05 juin 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 avr. 1998Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 10 mars 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Letter of offset
    Créé le 19 août 1991
    Livré le 09 sept. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the northern scottish omnibuses limited to chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    The balances at credit in any account held with the bank in name of the company.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 09 sept. 1991Enregistrement d'une charge
    • 10 mars 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 29 janv. 1990
    Livré le 02 févr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from stage- coach (holdings) limited to the chargee under the terms of a term loan agreement dated 26/1/90 and all monies due or to become due from stage-coach (holdings) limited to the chargee under the terms of a revolving credit and overdraft facility agreement dated 26/01/90 and all monies due or to become due from stage-coach (holdings) limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    (Including trade & tenants fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governer and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 02 févr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 10 mars 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 02 oct. 1987
    Livré le 14 oct. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Office premises fronting walvers lane school hill lewes sussex.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 oct. 1987Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 02 oct. 1987
    Livré le 14 oct. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Office premises 10 east street littlehampton west sussex.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 oct. 1987Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 02 oct. 1987
    Livré le 14 oct. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    1/1A market parade havant hampshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 oct. 1987Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 02 oct. 1987
    Livré le 14 oct. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit 10 charterhouse lord montgomery way portsmouth hampshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 oct. 1987Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 02 oct. 1987
    Livré le 14 oct. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Bus station fronting elm lane havant hampshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 oct. 1987Enregistrement d'une charge
    Guarantee & debenture
    Créé le 02 oct. 1987
    Livré le 14 oct. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 oct. 1987Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0