LRUK (DORMANT NO.2) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | LRUK (DORMANT NO.2) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00142234 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe LRUK (DORMANT NO.2) LIMITED ?
| Adresse du siège social | 2 Holdsworth Street BD1 4AH Bradford West Yorkshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de LRUK (DORMANT NO.2) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2022 |
Quels sont les derniers dépôts pour LRUK (DORMANT NO.2) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||
La procédure de radiation volontaire a été suspendue. | 1 pages | SOAS(A) | ||
Cessation de la nomination de Michael Paul Truluck en tant que directeur le 06 juil. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2022 | 8 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 22 oct. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2021 | 8 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 22 oct. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020 | 8 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 22 oct. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019 | 8 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 22 oct. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018 | 8 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 22 oct. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Michael Truluck le 14 sept. 2018 | 2 pages | CH01 | ||
Notification de Ginette Moulin en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 10 avr. 2018 | 2 pages | PSC01 | ||
Cessation de Eric Yvon Courteille en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 10 avr. 2018 | 1 pages | PSC07 | ||
Cessation de Nathalie Catherine Balla en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 10 avr. 2018 | 1 pages | PSC07 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2017 | 11 pages | AA | ||
Modification des détails de Lruk (Holdings) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 07 nov. 2017 | 2 pages | PSC05 | ||
Notification de Nathalie Catherine Balla en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016 | 2 pages | PSC01 | ||
Notification de Eric Yvon Courteille en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016 | 2 pages | PSC01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 22 oct. 2017 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2016 | 10 pages | AA | ||
Qui sont les dirigeants de LRUK (DORMANT NO.2) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURKE, Richard | Administrateur | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire | England | British | 197432680001 | |||||
| MCLAUGHLIN, Ellen | Secrétaire | 6 Wharfe Grove LS22 6HA Wetherby West Yorkshire | British | 125588610001 | ||||||
| OAKES, Frederick William, Mr. | Secrétaire | Tithe House Way HD2 1RD Huddersfield 18 West Yorkshire | British | 2304400001 | ||||||
| ATKINSON, Neil Gareth | Administrateur | The Old Chapel Knaresborough Road Follifoot HG3 1DT Harrogate North Yorkshire | British | 72405410002 | ||||||
| BALLA, Nathalie Catherine | Administrateur | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire United Kingdom | France | French | 179486450001 | |||||
| BAZIN, Pascal | Administrateur | 43 Bis, Avenue De La Marne Tourcoing 59200 France | French | 79523170001 | ||||||
| BOTT, Richard | Administrateur | 49 Henley Avenue WF12 0LN Dewsbury West Yorkshire | British | 49293190001 | ||||||
| CAMPBELL, William James | Administrateur | 2 Heather Gardens Scarcroft LS14 3HU Leeds West Yorkshire | British | 2303760001 | ||||||
| CHESHIRE, Mark | Administrateur | Crossroads Farm Barton Le Willows YO60 7PD York North Yorkshire | United Kingdom | British | 149554830001 | |||||
| DEVE, Francoise Suzanne Marcelle | Administrateur | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire United Kingdom | France | French | 164987810001 | |||||
| FAINTRENY, Eric Robert | Administrateur | 40 Woodvale Crescent BD16 4AL Bingley West Yorkshire | French | 46646970001 | ||||||
| GREEN, Marianne Mckenzie | Administrateur | The Owl House 19 Eagle Row WA13 0PY Lymm Cheshire | British | 118854820001 | ||||||
| HARRIS, Michael John Charles | Administrateur | The Deri Bramhope Manor Moor Road Bramhope LS16 9HJ Leeds West Yorkshire | British | 2307700001 | ||||||
| HAWKER, Michael Leslie | Administrateur | Monkshorn East Boldre SO42 7WT Brockenhurst Hampshire | United Kingdom | British | 114261580001 | |||||
| HEAVISIDES, Henry John | Administrateur | High Clere Villas 20 Margerison Road Ben Rhydding LS29 8QU Ilkley West Yorkshire | British | 57422610004 | ||||||
| HILL, Andrew Ratcliffe | Administrateur | 43 Park Lane Roundhay LS8 2EH Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 69640030001 | |||||
| IZARD, Olivier Jacques Georges | Administrateur | Creskeld House Creskeld Lane Arthington LS21 1NU Otley West Yorkshire | French | 87658610002 | ||||||
| JONES, Robert Glyn | Administrateur | 17 Wellington Lodge North Street Winkfield SL4 4TA Windsor Berkshire | British | 116871110002 | ||||||
| JONVILLE, Jean-Luc | Administrateur | 594 Bois D'Achelles Bondues 59910 France | French | 65053520001 | ||||||
| MADELEY, Jane Elisabeth | Administrateur | 102 Leeds Road Bramhope LS16 9AN Leeds West Yorkshire | England | British | 105516350002 | |||||
| MCAULAY, Janet | Administrateur | Pavilion House Coldbath Road HG2 0PB Harrogate North Yorkshire | British | 87365970001 | ||||||
| OHLSSON, Hans | Administrateur | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | Swedish | 133656790001 | |||||
| PALICH, Peter | Administrateur | 33 Borrowdale Drive BB10 2SG Burnley Lancashire | British | 58037440001 | ||||||
| ROBERTS, Andrew William | Administrateur | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire United Kingdom | England | British | 68177770002 | |||||
| ROCHE, Stephane Marie Marcel | Administrateur | Hilly Ridge Grosvenor Road Headingley Leeds West Yorkshire | French | 116192560002 | ||||||
| SKELSEY, Alistair James | Administrateur | Bluebill Lodge 79 Lower Mill Bank Triangle HX6 3ED Sowerby Bridge Halifax West Yorkshire | British | 74013420001 | ||||||
| SMITH, Peter James | Administrateur | Melville Margaret Avenue Bardsey LS17 9AT Leeds West Yorkshire | England | British | 17125140001 | |||||
| THOMSON, Alan | Administrateur | Flat 3 Hamilton House, 4 Park Avenue HG2 9BQ Harrogate | United Kingdom | British | 122421940001 | |||||
| TRULUCK, Michael Paul | Administrateur | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire | England | British | 153010590002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur LRUK (DORMANT NO.2) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mrs Ginette Moulin | 10 avr. 2018 | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire | Non | ||||||||||
Nationalité: French Pays de résidence: France | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Monsieur Eric Yvon Courteille | 06 avr. 2016 | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire | Oui | ||||||||||
Nationalité: French Pays de résidence: France | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Madame Nathalie Catherine Balla | 06 avr. 2016 | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire | Oui | ||||||||||
Nationalité: French Pays de résidence: Belgium | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Lruk (Holdings) Limited | 06 avr. 2016 | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
LRUK (DORMANT NO.2) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Northern ireland deed of charge and assignment | Créé le 28 oct. 2003 Livré le 12 nov. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions By way of first fixed charge all its right title and interest in and to the applicable charged monies and to the originator collection accounts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of charge and assignment | Créé le 28 oct. 2003 Livré le 12 nov. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the chargor to the participant under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All its right title and interest in and to the applicable charged monies; the originator collection accounts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 27 nov. 1990 Livré le 11 déc. 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement and or facility letter both dated 27/11/90 | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A fourth supplemental trust deed | Créé le 27 nov. 1990 Livré le 06 déc. 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti Securing 6 3/8 per cent debenture stock 1985 90, 8 3/4 per cent debenture stock 1991/96 and 9 1/4 per cent debenture stock 1994/99 created under the various trust deeds and all other moneys due or to become due form the company and/or all or any of the other companies named therein to royal exchange trust company limited as secured by this deed. | |
Brèves mentions See doc M93 for further details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Second supplemental trust deed | Créé le 06 juin 1972 Livré le 06 juin 1972 | Totalement satisfaite | Montant garanti Debenture stock of empire stores (bradford) LTD. Amounting to £4,202,615 outstanding under and secured by a trust deed dated 5TH may 1965 and deeds supplemental thereto | |
Brèves mentions Floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Supplemental trust deed for securing debenture stock | Créé le 29 janv. 1969 Livré le 05 févr. 1969 | Totalement satisfaite | Montant garanti Debenture stock of empire stores (bradford) LTD. Amounting to £2,250,000 including £1,000,000 secured by a trust deed dated 5TH may 1965 | |
Brèves mentions Floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Trust deed | Créé le 05 mai 1965 Livré le 14 mai 1965 | Totalement satisfaite | Montant garanti £1,000,000 debenture stock of empire stores (bradford) LTD | |
Brèves mentions Floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Equitable charge without instrument | Créé le 31 mars 1965 Livré le 14 avr. 1965 | Totalement satisfaite | Montant garanti £1,000,000 debenture stock of empire stores (bradford) LTD. | |
Brèves mentions Floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0