SOCIETY OF BRITISH AEROSPACE COMPANIES (THE)

SOCIETY OF BRITISH AEROSPACE COMPANIES (THE)

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSOCIETY OF BRITISH AEROSPACE COMPANIES (THE)
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité illimitée
    Numéro de société 00143447
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SOCIETY OF BRITISH AEROSPACE COMPANIES (THE) ?

    • Activités des organisations d'employeurs et des organisations professionnelles (94110) / Autres activités de services

    Où se situe SOCIETY OF BRITISH AEROSPACE COMPANIES (THE) ?

    Adresse du siège social
    Salamanca Square
    9 Albert Embankment
    SE1 7SP London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SOCIETY OF BRITISH AEROSPACE COMPANIES (THE) ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SOCIETY OF BRITISH AEROSPACE COMPANIES (THE) LIMITED10 sept. 201010 sept. 2010

    Quels sont les derniers comptes de SOCIETY OF BRITISH AEROSPACE COMPANIES (THE) ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour SOCIETY OF BRITISH AEROSPACE COMPANIES (THE) ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration de confirmation établie le 13 juil. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 13 juil. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 13 juil. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 13 juil. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 13 juil. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    5 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    10 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 13 juil. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 juil. 2015

    État du capital au 27 juil. 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital30 juil. 2014

    État du capital au 30 juil. 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 juil. 2013 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital18 juil. 2013

    État du capital après une attribution d'actions au 18 juil. 2013

    SH01

    Nomination de Ms Beth Porter en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Robert Sayers en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Ian Godden en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Paul Brian Alfred Everitt en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 juil. 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Ian Adam Godden le 16 juil. 2012

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    15 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    18 pagesAA

    Nomination de Mr Ian Adam Godden en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de SOCIETY OF BRITISH AEROSPACE COMPANIES (THE) ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PORTER, Beth
    E T P S Road
    GU14 6FD Farnborough
    Showcentre
    Hampshire
    England
    Secrétaire
    E T P S Road
    GU14 6FD Farnborough
    Showcentre
    Hampshire
    England
    179916010001
    EVERITT, Paul Brian Alfred
    Salamanca Square
    9 Albert Embankment
    SE1 7SP London
    Administrateur
    Salamanca Square
    9 Albert Embankment
    SE1 7SP London
    EnglandBritish127067280001
    BATTEN, Kenneth Henry
    1 Welbeck Avenue
    Highfield
    SO17 1SW Southampton
    Hampshire
    Secrétaire
    1 Welbeck Avenue
    Highfield
    SO17 1SW Southampton
    Hampshire
    British14410550001
    BIRD, Katherine Evendra
    42 Baldock Road
    Stotfold
    SG5 4PB Hitchin
    Hertfordshire
    Secrétaire
    42 Baldock Road
    Stotfold
    SG5 4PB Hitchin
    Hertfordshire
    British79431470001
    CHAPMAN, Ian
    2 Palmerston House
    126 Westminster Bridge Rd
    SE1 7UW London
    Secrétaire
    2 Palmerston House
    126 Westminster Bridge Rd
    SE1 7UW London
    British73385590002
    SAYERS, Robert
    26 Dorian Drive
    Cheapside
    SL5 7QL Ascot
    Berkshire
    Secrétaire
    26 Dorian Drive
    Cheapside
    SL5 7QL Ascot
    Berkshire
    British30546490002
    SIDEBOTTOM, Trevor George
    7 The Wheatridge
    GL4 4DQ Gloucester
    Secrétaire
    7 The Wheatridge
    GL4 4DQ Gloucester
    British54601040001
    ANNETT, Richard John
    Nallers Farm Askerswell
    DT2 9EJ Dorchester
    Dorset
    Administrateur
    Nallers Farm Askerswell
    DT2 9EJ Dorchester
    Dorset
    British63294730001
    ARENDT, Axel
    801 Westminster Green
    8 Dean Ryle Street Westminster
    SW1P 4DA London
    Administrateur
    801 Westminster Green
    8 Dean Ryle Street Westminster
    SW1P 4DA London
    German113562590001
    BANHAM, Stephen James
    42 West Street
    RG26 3SX Tadley
    Hampshire
    Administrateur
    42 West Street
    RG26 3SX Tadley
    Hampshire
    United KingdomBritish54822030002
    BARBER, Norman Victor
    Greylands 17 Merrow Croft
    Merrow
    GU1 2XH Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Greylands 17 Merrow Croft
    Merrow
    GU1 2XH Guildford
    Surrey
    EnglandBritish6210060001
    BEECH, Simon William
    9 Greytree Crescent
    Dorridge
    B93 8SL Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    9 Greytree Crescent
    Dorridge
    B93 8SL Solihull
    West Midlands
    British73297190001
    BELISARIO, Anthony Alfredo
    24 Coronation Road
    Prestbury
    GL52 3DA Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    24 Coronation Road
    Prestbury
    GL52 3DA Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritish19258750001
    BENNETT, Katherine Susan
    Grovewood Cottage
    Horton
    BS37 6QN Bristol
    Avon
    Administrateur
    Grovewood Cottage
    Horton
    BS37 6QN Bristol
    Avon
    British107026600001
    BLOGH, Julian, Doctor
    Malvern 83 Green Lane
    SL1 8EG Burnham Beeches
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Malvern 83 Green Lane
    SL1 8EG Burnham Beeches
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish36783690003
    BLUNDELL, Charles Edward
    Buckingham Gate
    SW1E 6AT London
    65
    Administrateur
    Buckingham Gate
    SW1E 6AT London
    65
    British44158000002
    BROADHURST, Martin Tilston
    5 Chancellery Mews
    IP33 3EG Bury St Edmunds
    Suffolk
    Administrateur
    5 Chancellery Mews
    IP33 3EG Bury St Edmunds
    Suffolk
    British26365720002
    BROWN, David Robert
    2 Wildwood Close
    GU22 8PL Woking
    Surrey
    Administrateur
    2 Wildwood Close
    GU22 8PL Woking
    Surrey
    British70823740001
    BRUNDLE, Kenneth Sydney
    Carigullian Cottage
    27a Killyleagh Road
    BT23 6TD Newtownards
    County Down
    Administrateur
    Carigullian Cottage
    27a Killyleagh Road
    BT23 6TD Newtownards
    County Down
    Northern IrelandBritish163918190001
    BRYSON, Marcus James Stirling
    1 Jura Close
    Cosham
    PO6 3UG Portsmouth
    Hampshire
    Administrateur
    1 Jura Close
    Cosham
    PO6 3UG Portsmouth
    Hampshire
    EnglandBritish82769940001
    BUNDRED, David George
    31 Lindsey Crescent
    CV8 1FL Kenilworth
    Warwickshire
    Administrateur
    31 Lindsey Crescent
    CV8 1FL Kenilworth
    Warwickshire
    United KingdomBritish70291370001
    BURNS, Christopher Robert, Dr
    66 Fairmile Lane
    Doonside
    KT11 2DE Cobham
    Surrey
    Administrateur
    66 Fairmile Lane
    Doonside
    KT11 2DE Cobham
    Surrey
    British77008070001
    BURRIDGE, Harold James
    15 Oakley Road
    BH21 1QJ Wimborne
    Dorset
    Administrateur
    15 Oakley Road
    BH21 1QJ Wimborne
    Dorset
    EnglandBritish72691890001
    BURROWS, Peter John
    Paddock Cottage
    East Coker
    BA22 9JP Yeovil
    Somerset
    Administrateur
    Paddock Cottage
    East Coker
    BA22 9JP Yeovil
    Somerset
    British5107210001
    BURTON, Philip Frederick Jocelyn
    Meadowcroft Miz Maze
    Leigh
    DT9 6JJ Sherborne
    Dorset
    Administrateur
    Meadowcroft Miz Maze
    Leigh
    DT9 6JJ Sherborne
    Dorset
    EnglandBritish65588520001
    BUSUTTIL, Walter Gerard Paul
    48 Fernside
    M26 1EQ Radcliffe
    Lancashire
    Administrateur
    48 Fernside
    M26 1EQ Radcliffe
    Lancashire
    Maltese82769840001
    BUSUTTIL, Walter Gerard Paul
    Robecq Painswick Road
    Brockworth
    GL3 4RP Gloucester
    Administrateur
    Robecq Painswick Road
    Brockworth
    GL3 4RP Gloucester
    Maltese58388590001
    CASE, Richard Ian
    Melchester House
    Horsington
    BA8 0EG Templecombe
    Somerset
    Administrateur
    Melchester House
    Horsington
    BA8 0EG Templecombe
    Somerset
    EnglandBritish3618430001
    CASSIDY, Michael John
    De-Mar
    Aspen Holt Bassett Wood
    SO16 3QE Southampton
    Administrateur
    De-Mar
    Aspen Holt Bassett Wood
    SO16 3QE Southampton
    British14410560001
    CHEFFINS, John Patrick
    65 Buckingham Gate
    SW1E 6AT London
    Administrateur
    65 Buckingham Gate
    SW1E 6AT London
    British Canadian43529390003
    CHISHOLM, John Alexander Raymond, Sir
    Batchworth Hill House London Road
    WD3 1JS Rickmansworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    Batchworth Hill House London Road
    WD3 1JS Rickmansworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritish52854760001
    CHISNALL, Graham
    10 Pear Tree Lane
    GU10 4DW Rowledge
    Little Orchard
    Surrey
    Administrateur
    10 Pear Tree Lane
    GU10 4DW Rowledge
    Little Orchard
    Surrey
    United KingdomBritish135061600001
    CHOW, Chung Kong, Sir
    Flat 10
    20 Lowndes Square
    SW1X 9HD London
    Administrateur
    Flat 10
    20 Lowndes Square
    SW1X 9HD London
    British37736600002
    CLARK, Robin Hartley Ledgerd
    Glebe Cottage
    Rockbourne
    SP6 3NA Fordingbridge
    Hampshire
    Administrateur
    Glebe Cottage
    Rockbourne
    SP6 3NA Fordingbridge
    Hampshire
    British73934900001
    CLARK, Robin Hartley Ledgerd
    Glebe Cottage
    Rockbourne
    SP6 3NA Fordingbridge
    Hampshire
    Administrateur
    Glebe Cottage
    Rockbourne
    SP6 3NA Fordingbridge
    Hampshire
    British73934900001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SOCIETY OF BRITISH AEROSPACE COMPANIES (THE) ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    9 Albert Embankment
    SE1 7SP London
    Salamanca Square
    England
    06 avr. 2016
    9 Albert Embankment
    SE1 7SP London
    Salamanca Square
    England
    Non
    Forme juridiqueRegistered Legal Entity
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleEngland And Wales
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement07016635
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    SOCIETY OF BRITISH AEROSPACE COMPANIES (THE) a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Security agreement
    Créé le 04 juil. 2007
    Livré le 25 juil. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    L/H property k/a 9G albert embankment london (formerly k/a unit 7 9 albert embankment london) all buildings,fixtures,fittings and fixed plant and machienry. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • William Kenneth Maciver and Gordon Francis Page and Charles Nicholas Hall (Being Trustees Ofthe Society of British Aerospace Companies Limited Pension and Life Assurance Plan "the Scheme")
    Transactions
    • 25 juil. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage
    Créé le 01 févr. 2006
    Livré le 04 févr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a suite 7 salamanca square albert embankment london. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 04 févr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 nov. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage deed
    Créé le 12 févr. 2003
    Livré le 21 févr. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The freehold property known as duxbury house 60 petty france victoria london SW1H 9EU title number NGL641010. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 21 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Créé le 24 avr. 2002
    Livré le 08 mai 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The deposit (as defined) and all such rights to the repayment thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 08 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0