CAKEBREAD ROBEY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCAKEBREAD ROBEY LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00146714
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CAKEBREAD ROBEY LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe CAKEBREAD ROBEY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Saint-Gobain House
    Binley Business Park
    CV3 2TT Coventry
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CAKEBREAD ROBEY LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CAKEBREAD ROBEY PLC13 déc. 199913 déc. 1999
    CAKEBREAD, ROBEY & CO., P.L.C.21 mars 191721 mars 1917

    Quels sont les derniers comptes de CAKEBREAD ROBEY LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2007

    Quels sont les derniers dépôts pour CAKEBREAD ROBEY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    2 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    3 pages4.71

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 09 oct. 2009

    LRESSP

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages287

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    6 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288c

    Comptes établis au 31 déc. 2006

    6 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    Comptes établis au 31 déc. 2005

    6 pagesAA

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    4 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de CAKEBREAD ROBEY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    OXENHAM, Alun Roy
    Park Lane
    Tilehurst
    RG31 4DU Reading
    98
    Berkshire
    Secrétaire
    Park Lane
    Tilehurst
    RG31 4DU Reading
    98
    Berkshire
    British72478560002
    LAMBERT, Thierry
    Fiery Hill
    Barnt Green
    B45 8LB Bromsgrove
    5
    United Kingdom
    Administrateur
    Fiery Hill
    Barnt Green
    B45 8LB Bromsgrove
    5
    United Kingdom
    FrenchDeputy General Delegate136578380002
    OXENHAM, Alun Roy
    Park Lane
    Tilehurst
    RG31 4DU Reading
    98
    Berkshire
    Administrateur
    Park Lane
    Tilehurst
    RG31 4DU Reading
    98
    Berkshire
    United KingdomBritishSecretary72478560002
    DAVIES, Kenneth Russell
    Greenacres Wick Crescent
    SS12 9HQ Wickford
    Essex
    Secrétaire
    Greenacres Wick Crescent
    SS12 9HQ Wickford
    Essex
    British29205180001
    MATTHEWS, William Paul
    2 Twentyman Close
    IG8 0EW Woodford Green
    Essex
    Secrétaire
    2 Twentyman Close
    IG8 0EW Woodford Green
    Essex
    BritishChartered Accountant3660080001
    BUYS, William Frederick
    Brawns
    Bix
    RG9 4RY Henley On Thames
    Oxfordshire
    Administrateur
    Brawns
    Bix
    RG9 4RY Henley On Thames
    Oxfordshire
    BritishDirector97730001
    DAVIES, Kenneth Russell
    Greenacres Wick Crescent
    SS12 9HQ Wickford
    Essex
    Administrateur
    Greenacres Wick Crescent
    SS12 9HQ Wickford
    Essex
    BritishCompany Secretary29205180001
    DE CHALENDAR, Pierre Andre
    15 Avenue Robert-Schumann
    FOREIGN Paris
    75007
    France
    Administrateur
    15 Avenue Robert-Schumann
    FOREIGN Paris
    75007
    France
    FrenchChief Executive63509130002
    EARLE, Martin Stewart
    Carramore House
    50 Vineyards Road, Northaw
    EN6 4PD Potters Bar
    Hertfordshire
    Administrateur
    Carramore House
    50 Vineyards Road, Northaw
    EN6 4PD Potters Bar
    Hertfordshire
    EnglandBritishChairman105947910002
    HINDLE MBE, Peter, Dr
    Woodside
    3 Linden Green
    FY5 2QN Thornton Cleveleys
    Lancashire
    Administrateur
    Woodside
    3 Linden Green
    FY5 2QN Thornton Cleveleys
    Lancashire
    EnglandBritishChief Executive Officer142989910002
    KENWARD, Christopher Gabriel
    Avonside
    Welford Road South Kilworth
    LE17 6EA Lutterworth
    Leicestershire
    Administrateur
    Avonside
    Welford Road South Kilworth
    LE17 6EA Lutterworth
    Leicestershire
    United KingdomBritishFinance Director265627840001
    LANGDALE, Peter Barry
    5 Caddington Close
    New Barnet
    EN4 9QH Barnet
    Hertfordshire
    Administrateur
    5 Caddington Close
    New Barnet
    EN4 9QH Barnet
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChief Executive11083180001
    LAZARD, Roland, Mr.
    Aldwych House
    81 Aldwych
    WC2B 4HQ London
    Administrateur
    Aldwych House
    81 Aldwych
    WC2B 4HQ London
    FrenchGeneral Delegate Uk Ireland An105253300003
    MATTHEWS, William Paul
    2 Twentyman Close
    IG8 0EW Woodford Green
    Essex
    Administrateur
    2 Twentyman Close
    IG8 0EW Woodford Green
    Essex
    BritishChartered Accountant3660080001
    MAYNARD, Kenneth Edward
    Lindenbrook Crooked Way
    Nazeing
    EN9 2LE Waltham Abbey
    Essex
    Administrateur
    Lindenbrook Crooked Way
    Nazeing
    EN9 2LE Waltham Abbey
    Essex
    BritishDirector53905090001
    POSTON, Lindsay
    5 Wavel Mews
    West Hampstead
    NW6 3AB London
    Administrateur
    5 Wavel Mews
    West Hampstead
    NW6 3AB London
    EnglandBritishChief Operating Officer70173330001
    WILMOT, Hugh Edward
    17 Burkett Way
    CB4 9XU Histon
    Cambridgeshire
    Administrateur
    17 Burkett Way
    CB4 9XU Histon
    Cambridgeshire
    BritishDirector92600930001

    CAKEBREAD ROBEY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal mortgage
    Créé le 13 déc. 1993
    Livré le 16 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/as land in southey street penge and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 16 déc. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 29 juil. 1993
    Livré le 12 août 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property fronting glebe way histon cambridgeshire and the proceeds of sale thereof an assignment of the goodwill and the connection of any business and the full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 12 août 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 29 juil. 1993
    Livré le 10 août 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property land and buildings on the east side of bardolph road trinity road richmond surrey t/n SY296781 and the proceeds of sale thereof an assignment of the goodwill and the connection of any business and the full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 10 août 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 29 juil. 1993
    Livré le 10 août 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property 318-326 southbury road enfield t/n EGL307621 and the proceeds of sale thereof an assignment of the goodwill and the connection of any business and the full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 10 août 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 29 juil. 1993
    Livré le 10 août 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property unit 2 the firs business park aspenden road buntingford east hertfordshire t/n HD268134 and the proceeds of sale thereof an assignment of the goodwill and the connection of any business and the full benefit of all licences. The entry in col.6 Above has this day been amended please see doc.M58L.R.M.groves 11/11/93. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 10 août 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 29 juil. 1993
    Livré le 10 août 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property 9 high street histon cambridgeshire and the proceeds of sale thereof an assignment of the goodwill and the connection of any business and the full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 10 août 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 29 juil. 1993
    Livré le 10 août 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property 27 the vale acton london borough of ealing t/n MX199405 and the proceeds of sale thereof an assignment of the goodwill and the connection of any business and the full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 10 août 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 22 oct. 1992
    Livré le 30 oct. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 30 oct. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    CAKEBREAD ROBEY LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    09 oct. 2009Commencement of winding up
    13 juil. 2010Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Nigel Heath Sinclair
    Mazars Llp Tower Bridge House
    St Katharine'S Way
    E1W 1DD London
    practitioner
    Mazars Llp Tower Bridge House
    St Katharine'S Way
    E1W 1DD London
    Guy Robert Thomas Hollander
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    practitioner
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0