CARILLION CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | CARILLION CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Liquidation |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00156617 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CARILLION CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED ?
| Adresse du siège social | PWC 8th Floor Central Square 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds West Yorkshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CARILLION CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED ?
| En retard | Oui |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2017 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2018 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2016 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour CARILLION CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED ?
| En retard | Oui |
|---|---|
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 21 déc. 2018 |
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 04 janv. 2019 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 21 déc. 2017 |
| En retard | Oui |
Quels sont les derniers dépôts pour CARILLION CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Changement d'adresse du siège social de , Crown House Birch Street, Wolverhampton, WV1 4JX, United Kingdom à 8th Floor Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL le 22 juil. 2019 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Modification des détails de Carillion Construction Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 oct. 2018 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de , Carillion House 84 Salop Street, Wolverhampton, WV3 0SR à 8th Floor Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL le 01 oct. 2018 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Ordonnance du tribunal pour liquider | 2 pages | COCOMP | ||||||||||
Cessation de la nomination de Westley Maffei en tant que directeur le 09 août 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Lee James Mills en tant que directeur le 08 août 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Francis Tapp en tant que secrétaire le 08 août 2018 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 déc. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr Westley Maffei en tant qu'administrateur le 01 juil. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Timothy Francis George en tant que directeur le 30 juin 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 déc. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 21 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014 | 3 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Lee James Mills le 02 mars 2015 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Timothy Francis George le 02 mars 2015 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mr Richard Francis Tapp le 02 mars 2015 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de , Carillion House 84 Salop Street, Wolverhampton, WV3 0SR, United Kingdom à 8th Floor Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL le 02 mars 2015 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de , 24 Birch Street, Wolverhampton, WV1 4HY à 8th Floor Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL le 02 mars 2015 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 21 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 21 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 21 déc. 2012 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de CARILLION CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORT, Stefan Edward | Secrétaire | 126 Grove Park SE5 8LD London | British | 32824200005 | ||||||
| FITZHUGH, Dirk Olaf | Secrétaire | Beesdau House Mount Road Tettenhall Wood WV6 8HT Wolverhampton | British | 612090001 | ||||||
| INGRAM, Peter William Irving | Secrétaire | 40 Landford Road SW15 1AG London | British | 1359100001 | ||||||
| MCCORMACK, James Joseph | Secrétaire | Broome House Chapel Lane Knockin Heath SY10 8EB Oswestry Shropshire | British | 678610003 | ||||||
| MCEWAN, Euan | Secrétaire | 2 Bradshaw Close The Fairways PE28 4UZ Brampton Cambridgeshire | British | 110597480001 | ||||||
| TAPP, Richard Francis | Secrétaire | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | British | 173852420001 | ||||||
| ANDERSON, David Joseph Alfred | Administrateur | 9 Tithe Meadows GU25 4EU Virgina Water Surrey | England | British | 92518640001 | |||||
| BATES, Kenneth Frank | Administrateur | 6 Bramwell Drive Highfields WS6 7PQ Cheslyn Hay West Midlands | British | 25969700002 | ||||||
| BEAUPREZ, Richard Joseph | Administrateur | 16 Dale Close SG4 9AS Hitchin Hertfordshire | British | 4079700001 | ||||||
| BENSON, Richard George | Administrateur | Halston House Lea Cross SY5 8JQ Ne Shrewsbury Salop | British | 103405290001 | ||||||
| BERNARD, Peter David | Administrateur | 16 Avenue Road TW11 0BT Teddington Middlesex | United Kingdom | British | 34673830001 | |||||
| BLACKER, Michael | Administrateur | 46 Ridgeway RG10 8AS Wargrave Berkshire | England | British | 120377750001 | |||||
| BRANT, Dennis | Administrateur | 11 Ranelagh Drive North Grassenoale L19 9DS Liverpool | British | 79472910001 | ||||||
| CASEBOURNE, Michael Victor | Administrateur | The Boundary Ballards Farm Road CR2 7JA South Croydon Surrey | British | 3792090001 | ||||||
| CLARKE, Michael Charles | Administrateur | Heron Lodge 3 Barrington Park Gardens HP8 4SS Chalfont St Giles Bucks | British | 71837170001 | ||||||
| FARMER, Arthur George | Administrateur | 17 Larkspur Close RG11 2NA Wokingham Berkshire | British | 8015630001 | ||||||
| GEORGE, Timothy Francis | Administrateur | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | 24075160004 | |||||
| GREY, Peter John | Administrateur | Hameldown Higham RG7 5UJ Reading Berkshire | British | 35824520001 | ||||||
| HAIGH, Allan Johnson | Administrateur | 404 Finchampstead Road Finchampstead RG40 3RA Wokingham Berkshire | United Kingdom | British | 63056350001 | |||||
| HORNER, David John | Administrateur | Mingary The Dell SP11 0LF Vernham Dean Hants | British | 32837390001 | ||||||
| KENNEDY, Francis Milne | Administrateur | Aughton 36 St Albans Road RH2 9LN Reigate Surrey | British | 3792110001 | ||||||
| KING, John Ernest | Administrateur | 1 Blades Close KT22 7JY Leatherhead Surrey | British | 427680001 | ||||||
| LOVELL, Anthony Brian | Administrateur | Windygates 40 Four Oaks Road B74 2TL Sutton Coldfield West Midlands | British | 47038900001 | ||||||
| MACIVER, Roderick David | Administrateur | 81 Esher Road KT8 0AQ East Molesey Surrey | England | British | 8015650001 | |||||
| MAFFEI, Westley Anthony | Administrateur | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | United Kingdom | British | 189962560002 | |||||
| MARTIN, William Roy | Administrateur | 19 Lancaster Road TW1 1HR Twickenham Middlesex | British | 7681870001 | ||||||
| MCEWAN, Euan | Administrateur | 2 Bradshaw Close The Fairways PE28 4UZ Brampton Cambridgeshire | British | 110597480001 | ||||||
| MILLS, Lee James | Administrateur | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | United Kingdom | British | 53951880001 | |||||
| NICOLETTI, Bernard Rene Hughes | Administrateur | 357 Avenue De Fabron Nice F-06200 France | French | 56047920001 | ||||||
| PELLARD, Brian | Administrateur | 33 Wyvern Road B74 2PS Sutton Coldfield West Midlands | British | 33408310001 | ||||||
| ROSS, Ian Malcolm | Administrateur | 29 Mount Pleasant Close GU18 5TR Lightwater Surrey | British | 1116930001 | ||||||
| SMOUT, Martin John | Administrateur | Greatfield Isington GU34 4PJ Near Alton Hampshire | United Kingdom | British | 117017210001 | |||||
| TOMAN, Lewis David | Administrateur | Old Orchard The Street Ubley BS18 8PJ Bristol Avon | British | 32828350001 | ||||||
| TURNER, Gary Harold | Administrateur | 1 Mclean Drive Priorslee TF2 9RT Telford Shropshire | England | British | 92534020001 | |||||
| WOOD, Michael James | Administrateur | 2 Autumn Walk Wargrave RG10 8BS Reading | United Kingdom | British | 62934890001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CARILLION CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carillion Construction Limited | 06 avr. 2016 | Birch Street WV1 4JX Wolverhampton Crown House United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
CARILLION CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Créé le 21 févr. 1990 Livré le 01 mars 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a sub-contract dated 21ST february 1990. | |
Brèves mentions All rights, benefits and interests of the company under a building contract dated 21ST february 1990 between boundary post limited and the company. (See form 395 for full details). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 21 sept. 1989 Livré le 05 oct. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement dated 16TH may 1989 | |
Brèves mentions By way of first legal mortgage all its estate or interest in the f/h property k/a land at mansfield road & fulforth street nottingham. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal mortgage | Créé le 16 mai 1989 Livré le 31 mai 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti £5,000,000 and all other monies due or to become due from the company to banque indosuez under the terms of a facility agreement of even date and the charge | |
Brèves mentions Legal mortgage over property known as all that land and buildings thereon encompassed by mansfield road, woodborough road and huntingdon street, nottingham, together with all buildings fixtures and fittings and fixed plant and machinery by way of assignment the benefit of all contracts agreements etc (see M89C for details). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 20 nov. 1985 Livré le 05 déc. 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti £150,000 | |
Brèves mentions F/H land situate on the west & east sides of lingham lane moreton merseyside title ms 89249. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage | Créé le 11 août 1980 Livré le 26 août 1980 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Several plots of land situate at wallasey in the county of chester and formerly k/a moreton brick works. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security presented for registration at the register of sasines on the 13TH jan 76. | Créé le 17 déc. 1975 Livré le 29 janv. 1976 | Totalement satisfaite | Montant garanti £377,325 | |
Brèves mentions Area of ground at raith kirkcaldy, county of fife. Extending to 43 acres or thereby. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage registered in australia | Créé le 16 déc. 1974 Livré le 13 nov. 1975 | Totalement satisfaite | Montant garanti Us $ 86,442 australian dollars & all other monies due or to become due | |
Brèves mentions Lot 2, plan of subdivision 113348, parish of haree loorran, county of mornington. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage registered in australia | Créé le 24 avr. 1974 Livré le 13 nov. 1975 | Totalement satisfaite | Montant garanti Us $ 240,000 australian dollars & all other monies due or to become due | |
Brèves mentions Land pt of crown allotment a sect 22 parish of mooroolbark, county of evelyn. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage registered in australia | Créé le 01 avr. 1974 Livré le 13 nov. 1975 | Totalement satisfaite | Montant garanti Us $ 114,943 australian dollars & all other monies due or to become due | |
Brèves mentions Lot 1 & 2 on plan of subdivision 113573 parish of harree loorran, county of mornington. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 26 nov. 1973 Livré le 28 nov. 1973 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions 146.5 acres at west hove sussex as described in an conveyance dated 31.8.59 and or transfer dated 16.4.73. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Memorandum of mortgage | Créé le 10 oct. 1973 Livré le 13 nov. 1975 | Totalement satisfaite | Montant garanti Us $ 254,000 australian dollars & all other monies due or to become due | |
Brèves mentions Land in the county of cumberland parish of minto city of cambelltown. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage registered in australia | Créé le 09 oct. 1973 Livré le 13 nov. 1975 | Totalement satisfaite | Montant garanti Us $ 70,436 australian dollars & all other monies due or to become due | |
Brèves mentions Lot 2 of plan of subdivision 85290, parish of scoresby, county of mornington. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage registered in australia | Créé le 01 oct. 1973 Livré le 13 nov. 1975 | Totalement satisfaite | Montant garanti Us $ 96,309 australian dollars and all other monies due or to become due | |
Brèves mentions Lot 2 on plan of subdivision 8661, pt of crown allotment 42, parish of scoresby, county of mornington. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage registered in australia | Créé le 14 mai 1973 Livré le 13 nov. 1975 | Totalement satisfaite | Montant garanti UK $ 147,468.75 australian dollars and all monies due or to become due | |
Brèves mentions Pt of lot 6,7 & 8 on plan sub division 4287 pt of crown allotment 48 parish of mooroobark county of mornington. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Memorandum of mortgage registered in australia | Créé le 02 oct. 1970 Livré le 13 nov. 1975 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions Land in parish of botany, county of cumberland vol 8274 folio 199. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
CARILLION CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Compulsory liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0