CARILLION CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED

CARILLION CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCARILLION CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED
    Statut de la sociétéLiquidation
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00156617
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CARILLION CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe CARILLION CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    PWC
    8th Floor Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CARILLION CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TARMAC CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED15 mars 199615 mars 1996
    WIMPEY CONSTRUCTION LIMITED03 févr. 198803 févr. 1988
    WIMPEY CONSTRUCTION UK LIMITED31 déc. 197931 déc. 1979
    GEORGE WIMPEY & CO LIMITED02 juil. 191902 juil. 1919

    Quels sont les derniers comptes de CARILLION CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2017
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2018
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour CARILLION CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au21 déc. 2018
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation04 janv. 2019
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au21 déc. 2017
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour CARILLION CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Changement d'adresse du siège social de , Crown House Birch Street, Wolverhampton, WV1 4JX, United Kingdom à 8th Floor Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL le 22 juil. 2019

    2 pagesAD01

    Modification des détails de Carillion Construction Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 oct. 2018

    2 pagesPSC05

    Changement d'adresse du siège social de , Carillion House 84 Salop Street, Wolverhampton, WV3 0SR à 8th Floor Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL le 01 oct. 2018

    1 pagesAD01

    Ordonnance du tribunal pour liquider

    2 pagesCOCOMP

    Cessation de la nomination de Westley Maffei en tant que directeur le 09 août 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Lee James Mills en tant que directeur le 08 août 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Richard Francis Tapp en tant que secrétaire le 08 août 2018

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 21 déc. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Westley Maffei en tant qu'administrateur le 01 juil. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Timothy Francis George en tant que directeur le 30 juin 2017

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 21 déc. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital21 déc. 2015

    État du capital au 21 déc. 2015

    • Capital: GBP 64,000,000
    • Capital: USD 2,560,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    3 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Lee James Mills le 02 mars 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Timothy Francis George le 02 mars 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Richard Francis Tapp le 02 mars 2015

    1 pagesCH03

    Changement d'adresse du siège social de , Carillion House 84 Salop Street, Wolverhampton, WV3 0SR, United Kingdom à 8th Floor Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL le 02 mars 2015

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de , 24 Birch Street, Wolverhampton, WV1 4HY à 8th Floor Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL le 02 mars 2015

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital22 déc. 2014

    État du capital au 22 déc. 2014

    • Capital: GBP 64,000,000
    • Capital: USD 2,560,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 déc. 2013

    État du capital au 23 déc. 2013

    • Capital: GBP 64,000,000
    • Capital: USD 2,560,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 déc. 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de CARILLION CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BORT, Stefan Edward
    126 Grove Park
    SE5 8LD London
    Secrétaire
    126 Grove Park
    SE5 8LD London
    British32824200005
    FITZHUGH, Dirk Olaf
    Beesdau House Mount Road
    Tettenhall Wood
    WV6 8HT Wolverhampton
    Secrétaire
    Beesdau House Mount Road
    Tettenhall Wood
    WV6 8HT Wolverhampton
    British612090001
    INGRAM, Peter William Irving
    40 Landford Road
    SW15 1AG London
    Secrétaire
    40 Landford Road
    SW15 1AG London
    British1359100001
    MCCORMACK, James Joseph
    Broome House
    Chapel Lane Knockin Heath
    SY10 8EB Oswestry
    Shropshire
    Secrétaire
    Broome House
    Chapel Lane Knockin Heath
    SY10 8EB Oswestry
    Shropshire
    British678610003
    MCEWAN, Euan
    2 Bradshaw Close
    The Fairways
    PE28 4UZ Brampton
    Cambridgeshire
    Secrétaire
    2 Bradshaw Close
    The Fairways
    PE28 4UZ Brampton
    Cambridgeshire
    British110597480001
    TAPP, Richard Francis
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Secrétaire
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    British173852420001
    ANDERSON, David Joseph Alfred
    9 Tithe Meadows
    GU25 4EU Virgina Water
    Surrey
    Administrateur
    9 Tithe Meadows
    GU25 4EU Virgina Water
    Surrey
    EnglandBritish92518640001
    BATES, Kenneth Frank
    6 Bramwell Drive
    Highfields
    WS6 7PQ Cheslyn Hay
    West Midlands
    Administrateur
    6 Bramwell Drive
    Highfields
    WS6 7PQ Cheslyn Hay
    West Midlands
    British25969700002
    BEAUPREZ, Richard Joseph
    16 Dale Close
    SG4 9AS Hitchin
    Hertfordshire
    Administrateur
    16 Dale Close
    SG4 9AS Hitchin
    Hertfordshire
    British4079700001
    BENSON, Richard George
    Halston House
    Lea Cross
    SY5 8JQ Ne Shrewsbury
    Salop
    Administrateur
    Halston House
    Lea Cross
    SY5 8JQ Ne Shrewsbury
    Salop
    British103405290001
    BERNARD, Peter David
    16 Avenue Road
    TW11 0BT Teddington
    Middlesex
    Administrateur
    16 Avenue Road
    TW11 0BT Teddington
    Middlesex
    United KingdomBritish34673830001
    BLACKER, Michael
    46 Ridgeway
    RG10 8AS Wargrave
    Berkshire
    Administrateur
    46 Ridgeway
    RG10 8AS Wargrave
    Berkshire
    EnglandBritish120377750001
    BRANT, Dennis
    11 Ranelagh Drive North
    Grassenoale
    L19 9DS Liverpool
    Administrateur
    11 Ranelagh Drive North
    Grassenoale
    L19 9DS Liverpool
    British79472910001
    CASEBOURNE, Michael Victor
    The Boundary Ballards Farm Road
    CR2 7JA South Croydon
    Surrey
    Administrateur
    The Boundary Ballards Farm Road
    CR2 7JA South Croydon
    Surrey
    British3792090001
    CLARKE, Michael Charles
    Heron Lodge
    3 Barrington Park Gardens
    HP8 4SS Chalfont St Giles
    Bucks
    Administrateur
    Heron Lodge
    3 Barrington Park Gardens
    HP8 4SS Chalfont St Giles
    Bucks
    British71837170001
    FARMER, Arthur George
    17 Larkspur Close
    RG11 2NA Wokingham
    Berkshire
    Administrateur
    17 Larkspur Close
    RG11 2NA Wokingham
    Berkshire
    British8015630001
    GEORGE, Timothy Francis
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Administrateur
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    EnglandBritish24075160004
    GREY, Peter John
    Hameldown
    Higham
    RG7 5UJ Reading
    Berkshire
    Administrateur
    Hameldown
    Higham
    RG7 5UJ Reading
    Berkshire
    British35824520001
    HAIGH, Allan Johnson
    404 Finchampstead Road
    Finchampstead
    RG40 3RA Wokingham
    Berkshire
    Administrateur
    404 Finchampstead Road
    Finchampstead
    RG40 3RA Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritish63056350001
    HORNER, David John
    Mingary
    The Dell
    SP11 0LF Vernham Dean
    Hants
    Administrateur
    Mingary
    The Dell
    SP11 0LF Vernham Dean
    Hants
    British32837390001
    KENNEDY, Francis Milne
    Aughton
    36 St Albans Road
    RH2 9LN Reigate
    Surrey
    Administrateur
    Aughton
    36 St Albans Road
    RH2 9LN Reigate
    Surrey
    British3792110001
    KING, John Ernest
    1 Blades Close
    KT22 7JY Leatherhead
    Surrey
    Administrateur
    1 Blades Close
    KT22 7JY Leatherhead
    Surrey
    British427680001
    LOVELL, Anthony Brian
    Windygates
    40 Four Oaks Road
    B74 2TL Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    Windygates
    40 Four Oaks Road
    B74 2TL Sutton Coldfield
    West Midlands
    British47038900001
    MACIVER, Roderick David
    81 Esher Road
    KT8 0AQ East Molesey
    Surrey
    Administrateur
    81 Esher Road
    KT8 0AQ East Molesey
    Surrey
    EnglandBritish8015650001
    MAFFEI, Westley Anthony
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Administrateur
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    United KingdomBritish189962560002
    MARTIN, William Roy
    19 Lancaster Road
    TW1 1HR Twickenham
    Middlesex
    Administrateur
    19 Lancaster Road
    TW1 1HR Twickenham
    Middlesex
    British7681870001
    MCEWAN, Euan
    2 Bradshaw Close
    The Fairways
    PE28 4UZ Brampton
    Cambridgeshire
    Administrateur
    2 Bradshaw Close
    The Fairways
    PE28 4UZ Brampton
    Cambridgeshire
    British110597480001
    MILLS, Lee James
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Administrateur
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    United KingdomBritish53951880001
    NICOLETTI, Bernard Rene Hughes
    357 Avenue De Fabron
    Nice F-06200
    France
    Administrateur
    357 Avenue De Fabron
    Nice F-06200
    France
    French56047920001
    PELLARD, Brian
    33 Wyvern Road
    B74 2PS Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    33 Wyvern Road
    B74 2PS Sutton Coldfield
    West Midlands
    British33408310001
    ROSS, Ian Malcolm
    29 Mount Pleasant Close
    GU18 5TR Lightwater
    Surrey
    Administrateur
    29 Mount Pleasant Close
    GU18 5TR Lightwater
    Surrey
    British1116930001
    SMOUT, Martin John
    Greatfield
    Isington
    GU34 4PJ Near Alton
    Hampshire
    Administrateur
    Greatfield
    Isington
    GU34 4PJ Near Alton
    Hampshire
    United KingdomBritish117017210001
    TOMAN, Lewis David
    Old Orchard
    The Street Ubley
    BS18 8PJ Bristol
    Avon
    Administrateur
    Old Orchard
    The Street Ubley
    BS18 8PJ Bristol
    Avon
    British32828350001
    TURNER, Gary Harold
    1 Mclean Drive
    Priorslee
    TF2 9RT Telford
    Shropshire
    Administrateur
    1 Mclean Drive
    Priorslee
    TF2 9RT Telford
    Shropshire
    EnglandBritish92534020001
    WOOD, Michael James
    2 Autumn Walk
    Wargrave
    RG10 8BS Reading
    Administrateur
    2 Autumn Walk
    Wargrave
    RG10 8BS Reading
    United KingdomBritish62934890001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CARILLION CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Birch Street
    WV1 4JX Wolverhampton
    Crown House
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Birch Street
    WV1 4JX Wolverhampton
    Crown House
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland & Wales
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement594581
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    CARILLION CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 21 févr. 1990
    Livré le 01 mars 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a sub-contract dated 21ST february 1990.
    Brèves mentions
    All rights, benefits and interests of the company under a building contract dated 21ST february 1990 between boundary post limited and the company. (See form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Bfu (Contractors) Limited
    Transactions
    • 01 mars 1990Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 21 sept. 1989
    Livré le 05 oct. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement dated 16TH may 1989
    Brèves mentions
    By way of first legal mortgage all its estate or interest in the f/h property k/a land at mansfield road & fulforth street nottingham.
    Personnes ayant droit
    • Banque Indosuez
    Transactions
    • 05 oct. 1989Enregistrement d'une charge
    • 10 juil. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 16 mai 1989
    Livré le 31 mai 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £5,000,000 and all other monies due or to become due from the company to banque indosuez under the terms of a facility agreement of even date and the charge
    Brèves mentions
    Legal mortgage over property known as all that land and buildings thereon encompassed by mansfield road, woodborough road and huntingdon street, nottingham, together with all buildings fixtures and fittings and fixed plant and machinery by way of assignment the benefit of all contracts agreements etc (see M89C for details).
    Personnes ayant droit
    • Banque Indosuez
    Transactions
    • 31 mai 1989Enregistrement d'une charge
    • 10 juil. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 20 nov. 1985
    Livré le 05 déc. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £150,000
    Brèves mentions
    F/H land situate on the west & east sides of lingham lane moreton merseyside title ms 89249.
    Personnes ayant droit
    • Ashton and Mccaul Limited
    Transactions
    • 05 déc. 1985Enregistrement d'une charge
    • 05 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 11 août 1980
    Livré le 26 août 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Several plots of land situate at wallasey in the county of chester and formerly k/a moreton brick works.
    Personnes ayant droit
    • Barker & Jones LTD
    Transactions
    • 26 août 1980Enregistrement d'une charge
    • 05 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security presented for registration at the register of sasines on the 13TH jan 76.
    Créé le 17 déc. 1975
    Livré le 29 janv. 1976
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £377,325
    Brèves mentions
    Area of ground at raith kirkcaldy, county of fife. Extending to 43 acres or thereby.
    Personnes ayant droit
    • Abbotshall Builders Limited
    Transactions
    • 29 janv. 1976Enregistrement d'une charge
    • 05 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage registered in australia
    Créé le 16 déc. 1974
    Livré le 13 nov. 1975
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Us $ 86,442 australian dollars & all other monies due or to become due
    Brèves mentions
    Lot 2, plan of subdivision 113348, parish of haree loorran, county of mornington.
    Personnes ayant droit
    • F G Fordham
    • C V Fordham
    Transactions
    • 13 nov. 1975Enregistrement d'une charge
    • 08 mars 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage registered in australia
    Créé le 24 avr. 1974
    Livré le 13 nov. 1975
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Us $ 240,000 australian dollars & all other monies due or to become due
    Brèves mentions
    Land pt of crown allotment a sect 22 parish of mooroolbark, county of evelyn.
    Personnes ayant droit
    • Taunton Developments Pty LTD
    Transactions
    • 13 nov. 1975Enregistrement d'une charge
    • 05 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage registered in australia
    Créé le 01 avr. 1974
    Livré le 13 nov. 1975
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Us $ 114,943 australian dollars & all other monies due or to become due
    Brèves mentions
    Lot 1 & 2 on plan of subdivision 113573 parish of harree loorran, county of mornington.
    Personnes ayant droit
    • E J Faulds.
    • W Faulds
    Transactions
    • 13 nov. 1975Enregistrement d'une charge
    • 08 mars 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 26 nov. 1973
    Livré le 28 nov. 1973
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    146.5 acres at west hove sussex as described in an conveyance dated 31.8.59 and or transfer dated 16.4.73.
    Personnes ayant droit
    • Javstry Investments LTD
    Transactions
    • 28 nov. 1973Enregistrement d'une charge
    • 05 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Memorandum of mortgage
    Créé le 10 oct. 1973
    Livré le 13 nov. 1975
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Us $ 254,000 australian dollars & all other monies due or to become due
    Brèves mentions
    Land in the county of cumberland parish of minto city of cambelltown.
    Personnes ayant droit
    • N W Harris
    • E P Blain
    Transactions
    • 13 nov. 1975Enregistrement d'une charge
    • 08 mars 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage registered in australia
    Créé le 09 oct. 1973
    Livré le 13 nov. 1975
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Us $ 70,436 australian dollars & all other monies due or to become due
    Brèves mentions
    Lot 2 of plan of subdivision 85290, parish of scoresby, county of mornington.
    Personnes ayant droit
    • H E Moffatt
    Transactions
    • 13 nov. 1975Enregistrement d'une charge
    Mortgage registered in australia
    Créé le 01 oct. 1973
    Livré le 13 nov. 1975
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Us $ 96,309 australian dollars and all other monies due or to become due
    Brèves mentions
    Lot 2 on plan of subdivision 8661, pt of crown allotment 42, parish of scoresby, county of mornington.
    Personnes ayant droit
    • E a Voigt
    Transactions
    • 13 nov. 1975Enregistrement d'une charge
    Mortgage registered in australia
    Créé le 14 mai 1973
    Livré le 13 nov. 1975
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    UK $ 147,468.75 australian dollars and all monies due or to become due
    Brèves mentions
    Pt of lot 6,7 & 8 on plan sub division 4287 pt of crown allotment 48 parish of mooroobark county of mornington.
    Personnes ayant droit
    • G M Chandler
    Transactions
    • 13 nov. 1975Enregistrement d'une charge
    • 08 mars 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Memorandum of mortgage registered in australia
    Créé le 02 oct. 1970
    Livré le 13 nov. 1975
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Land in parish of botany, county of cumberland vol 8274 folio 199.
    Personnes ayant droit
    • Rural Bank of New South Wales
    Transactions
    • 13 nov. 1975Enregistrement d'une charge
    • 08 mars 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    CARILLION CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    18 juin 2018Petition date
    08 août 2018Commencement of winding up
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    The Official Receiver Or London
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    practitioner
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0