SELECTA REFRESHMENTS LIMITED

SELECTA REFRESHMENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSELECTA REFRESHMENTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00157122
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SELECTA REFRESHMENTS LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe SELECTA REFRESHMENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 Finway Road Finway Road
    Hemel Hempstead Industrial Estate
    HP2 7PT Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SELECTA REFRESHMENTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SELECTA UK LIMITED20 janv. 200320 janv. 2003
    VENDEPAC LIMITED01 mai 199801 mai 1998
    TM GROUP LIMITED12 mai 198612 mai 1986
    MAYFAIR GROUP LIMITED31 déc. 198131 déc. 1981
    STANDARD TOBACCO COMPANY LIMITED16 juil. 191916 juil. 1919

    Quels sont les derniers comptes de SELECTA REFRESHMENTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2022

    Quels sont les derniers dépôts pour SELECTA REFRESHMENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2022

    12 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 28 mars 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de Apollo House, Odyssey Business Park West End Road Ruislip HA4 6QD England à 1 Finway Road Finway Road Hemel Hempstead Industrial Estate Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 7PT le 15 nov. 2022

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 28 mars 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2021

    12 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020

    12 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 28 mars 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Anthony Michael Leon en tant que directeur le 01 avr. 2021

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Paul Nathaniel Ian Hearne en tant qu'administrateur le 01 avr. 2021

    2 pagesAP01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2019

    16 pagesAA

    legacy

    68 pagesPARENT_ACC

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    Nomination de Mr Anthony Michael Leon en tant qu'administrateur le 20 oct. 2020

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Marta Schwartz en tant que directeur le 20 oct. 2020

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 28 mars 2020 avec mises à jour

    3 pagesCS01

    Période comptable actuelle prolongée du 30 sept. 2019 au 31 déc. 2019

    1 pagesAA01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2018

    25 pagesAA

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Nomination de Marta Schwartz en tant qu'administrateur le 01 sept. 2019

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de SELECTA REFRESHMENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HEARNE, Paul Nathaniel Ian, Mr.
    Finway Road
    Hemel Hempstead Industrial Estate
    HP2 7PT Hemel Hempstead
    1 Finway Road
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    Finway Road
    Hemel Hempstead Industrial Estate
    HP2 7PT Hemel Hempstead
    1 Finway Road
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish124527170003
    VRIJLANDT, Jan Marck
    Finway Road
    Hemel Hempstead Industrial Estate
    HP2 7PT Hemel Hempstead
    1 Finway Road
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    Finway Road
    Hemel Hempstead Industrial Estate
    HP2 7PT Hemel Hempstead
    1 Finway Road
    Hertfordshire
    England
    NetherlandsDutch201873380001
    BAKER, Roger Owen
    Ampfield House
    Blackheath
    GU4 8RD Guildford
    Surrey
    Secrétaire
    Ampfield House
    Blackheath
    GU4 8RD Guildford
    Surrey
    British18801330003
    BARNES, Christopher Howard
    11 Hepplewhite Close
    Baughurst
    RG26 5HD Basingstoke
    Hampshire
    Secrétaire
    11 Hepplewhite Close
    Baughurst
    RG26 5HD Basingstoke
    Hampshire
    British25597650001
    BUCKNALL, Christopher David
    51 Brackendale Road
    GU15 2JS Camberley
    Surrey
    Secrétaire
    51 Brackendale Road
    GU15 2JS Camberley
    Surrey
    British32104690001
    MASON, Timothy Charles
    231 Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    Secrétaire
    231 Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    British12314170002
    MERCER, Roderick
    Charvil Lane
    Sonning
    RG4 6TH Reading
    Slipe
    Berkshire
    Secrétaire
    Charvil Lane
    Sonning
    RG4 6TH Reading
    Slipe
    Berkshire
    British129465490001
    MILLER, Simon Jonathan
    Crabtrees
    CB11 3BH Saffron Walden
    12
    Essex
    Secrétaire
    Crabtrees
    CB11 3BH Saffron Walden
    12
    Essex
    British88269280001
    PAYNE, Michael John
    Unit 2 Cartel Business Centre
    Wade Road
    RG24 8FW Basingstoke
    Selecta Uk Ltd
    Hampshire
    Secrétaire
    Unit 2 Cartel Business Centre
    Wade Road
    RG24 8FW Basingstoke
    Selecta Uk Ltd
    Hampshire
    British147336500001
    SNEYD, Ian Nicholas
    Oakleigh Swan Lane
    Marlpit Hill
    TN8 6BA Edenbridge
    Kent
    Secrétaire
    Oakleigh Swan Lane
    Marlpit Hill
    TN8 6BA Edenbridge
    Kent
    British31342250001
    ABRAHAMS, Daniel Henry
    Odyssey Business Park
    West End Road
    HA4 6QD Ruislip
    Apollo House
    Middlesex
    England
    Administrateur
    Odyssey Business Park
    West End Road
    HA4 6QD Ruislip
    Apollo House
    Middlesex
    England
    EnglandBritish183822370001
    BATE, David Martin
    9 Harptree Close
    BS48 4YT Nailsea
    Morgan's View
    North Somerset
    United Kingdom
    Administrateur
    9 Harptree Close
    BS48 4YT Nailsea
    Morgan's View
    North Somerset
    United Kingdom
    British130717000002
    BUCKNALL, Christopher David
    51 Brackendale Road
    GU15 2JS Camberley
    Surrey
    Administrateur
    51 Brackendale Road
    GU15 2JS Camberley
    Surrey
    British32104690001
    BULPITT, Nigel Peter
    The Old School
    Upper Froyle
    GU34 4LB Alton
    Hampshire
    Administrateur
    The Old School
    Upper Froyle
    GU34 4LB Alton
    Hampshire
    EnglandBritish451080002
    BURCHELL, Philip Raymond
    123 Tolmers Road
    EN6 4JW Cuffley Potters Bar
    Hertfordshire
    Administrateur
    123 Tolmers Road
    EN6 4JW Cuffley Potters Bar
    Hertfordshire
    British36622820001
    BURROWS, Helen
    Cartel Business Centre
    Wade Road
    RG24 8FW Basingstoke
    Unit 2
    Hampshire
    England
    Administrateur
    Cartel Business Centre
    Wade Road
    RG24 8FW Basingstoke
    Unit 2
    Hampshire
    England
    EnglandBritish171865220001
    COWING, Helen
    c/o Selecta Management Ag
    Hinterbergstrasse
    6330 Cham
    20
    Switzerland
    Administrateur
    c/o Selecta Management Ag
    Hinterbergstrasse
    6330 Cham
    20
    Switzerland
    NetherlandsBritish156849560001
    COX, Allister Russell
    The Small House Mynthurst
    Leigh
    RH2 8RJ Reigate
    Surrey
    Administrateur
    The Small House Mynthurst
    Leigh
    RH2 8RJ Reigate
    Surrey
    EnglandBritish31500810002
    CULLENS, Alan
    Candleford
    Colville Gardens
    GU18 5QQ Lightwater
    Surrey
    Administrateur
    Candleford
    Colville Gardens
    GU18 5QQ Lightwater
    Surrey
    British6875310001
    HUGHES, Geraint
    Lime Tree Way, Hampshire Int Business Park
    Chineham
    RG24 8GG Basingstoke
    1st Floor Spinnaker House
    Hampshire
    England
    Administrateur
    Lime Tree Way, Hampshire Int Business Park
    Chineham
    RG24 8GG Basingstoke
    1st Floor Spinnaker House
    Hampshire
    England
    SwitzerlandBritish169470320001
    JONES, Dylan Glynn
    Lime Tree Way, Hampshire Int Business Park
    Chineham
    RG24 8GG Basingstoke
    1st Floor Spinnaker House
    Hampshire
    England
    Administrateur
    Lime Tree Way, Hampshire Int Business Park
    Chineham
    RG24 8GG Basingstoke
    1st Floor Spinnaker House
    Hampshire
    England
    EnglandBritish153523810001
    KEEN, David John
    33 Richmond Drive
    Mapperley
    NG3 5EL Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    33 Richmond Drive
    Mapperley
    NG3 5EL Nottingham
    Nottinghamshire
    British56997350002
    LANCASTER, James
    Upper Childown
    Accomodation Road
    KT16 0EJ Longcross
    Surrey
    Administrateur
    Upper Childown
    Accomodation Road
    KT16 0EJ Longcross
    Surrey
    EnglandBritish147052660001
    LEON, Anthony Michael
    West End Road
    HA4 6QD Ruislip
    Apollo House, Odyssey Business Park
    England
    Administrateur
    West End Road
    HA4 6QD Ruislip
    Apollo House, Odyssey Business Park
    England
    EnglandBritish242255050001
    MASON, Timothy Charles
    231 Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    231 Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritish12314170002
    MAUGUY, Philippe Francis Robert
    Lime Tree Way, Hampshire Int Business Park
    Chineham
    RG24 8GG Basingstoke
    1st Floor Spinnaker House
    Hampshire
    England
    Administrateur
    Lime Tree Way, Hampshire Int Business Park
    Chineham
    RG24 8GG Basingstoke
    1st Floor Spinnaker House
    Hampshire
    England
    EnglandBritish, French179402830001
    MCFARLANE, Ian Douglas
    Shirenewton
    NP16 6RL Chepstow
    The Cayo
    Gwent
    Administrateur
    Shirenewton
    NP16 6RL Chepstow
    The Cayo
    Gwent
    British130747750001
    MEE, Andy Edward
    Loughglynn
    Bunstrux
    HP23 4HT Tring
    Herts
    Administrateur
    Loughglynn
    Bunstrux
    HP23 4HT Tring
    Herts
    EnglandBritish177086470001
    MITCHELL, Philip
    3 White House Drive
    Merrow
    GU1 2SU Guildford
    Surrey
    Administrateur
    3 White House Drive
    Merrow
    GU1 2SU Guildford
    Surrey
    British6907290001
    MORTIMER, David Grant
    86 Frenchay Road
    OX2 6TF Oxford
    Oxfordshire
    Administrateur
    86 Frenchay Road
    OX2 6TF Oxford
    Oxfordshire
    British47770480002
    MORTIMER, David Grant
    86 Frenchay Road
    OX2 6TF Oxford
    Oxfordshire
    Administrateur
    86 Frenchay Road
    OX2 6TF Oxford
    Oxfordshire
    British47770480002
    PAYNE, Michael John
    Unit 2 Cartel Business Centre
    Wade Road
    RG24 8FW Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    Unit 2 Cartel Business Centre
    Wade Road
    RG24 8FW Basingstoke
    Hampshire
    EnglandBritish124498400001
    PORTER, Andrew Graham
    16 Alderwood Avenue
    Chandlers Ford
    SO53 4TH Eastleigh
    Hampshire
    Administrateur
    16 Alderwood Avenue
    Chandlers Ford
    SO53 4TH Eastleigh
    Hampshire
    EnglandBritish64331540001
    SCHWAB, Martin
    Eebrunnestrasse 26
    Hausen Bei Brugg
    5212
    Switzerland
    Administrateur
    Eebrunnestrasse 26
    Hausen Bei Brugg
    5212
    Switzerland
    SwitzerlandSwiss123132130001
    SCHWARTZ, Marta
    West End Road
    HA4 6QD Ruislip
    Apollo House, Odyssey Business Park
    England
    Administrateur
    West End Road
    HA4 6QD Ruislip
    Apollo House, Odyssey Business Park
    England
    United KingdomPolish262359470001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SELECTA REFRESHMENTS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Odyssey Business Park
    West End Road
    HA4 6QD Ruislip
    Apollo House
    Middlesex
    England
    19 déc. 2017
    Odyssey Business Park
    West End Road
    HA4 6QD Ruislip
    Apollo House
    Middlesex
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland & Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement00209116
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Kkr & Co.L.P
    West 57th Street
    Suite 4200
    NY10019 New York
    9
    New York
    United States
    06 avr. 2016
    West 57th Street
    Suite 4200
    NY10019 New York
    9
    New York
    United States
    Oui
    Forme juridiqueLimited Partnership
    Pays d'enregistrementDelaware
    Autorité légaleDelaware
    Lieu d'enregistrementRegistered In Delaware
    Numéro d'enregistrementState File No. 4378294
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    SELECTA REFRESHMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 27 févr. 2017
    Livré le 01 mars 2017
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Factofrance
    Transactions
    • 01 mars 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 20 juin 2014
    Livré le 26 juin 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Leasehold property k/a unit J6 forge lane minworth industrial estate sutton coldfield west midlands title no WM947521. Certain intellectual property listed in schedule 1 of the instrument for more details please see the image.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transactions
    • 26 juin 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 07 févr. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 13 janv. 2012
    Livré le 27 janv. 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The sum of £72,000 the interest accrued and any sums deposited in respect of value added tax see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Wgtc Nominees Limited
    • British Overseas Bank Nominees Limited
    Transactions
    • 27 janv. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Fixed and floating secuirty document
    Créé le 28 sept. 2007
    Livré le 10 oct. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Assigns all its present and future right,title and interest in and to the assigned contract,all insurance and all proceeds in respect of insurance and all benef. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank Pls as Security Agent for the Benefit of the Finance Parties
    Transactions
    • 10 oct. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 janv. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge over deposit
    Créé le 08 déc. 2000
    Livré le 19 déc. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and or all or any of the other companies named therein to the chargee under or pursuant to the financing documents
    Brèves mentions
    1), the consideration payable to mayfair vending limited pursuant to the offer letter and the advertising panel agreement and 2). the consideration payable to the company and the other chargors pursuant to the property sale agreement deposited by the company and the other chargors with the agent together with all interest accrued and accruing thereon and all other rights of the company and the other chargors in relation to such deposit in whichever account such deposit may, from time to time, be held.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 19 déc. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 août 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 28 nov. 1998
    Livré le 08 déc. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from company to the chargee (as agent and trustee for the secured parties (as therein defined) pursuant to the terms of a credit agreement (as therein defined)) under or pursuant to any of the financing documents (as therein defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 déc. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juil. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over deposit account
    Créé le 10 juil. 1998
    Livré le 27 juil. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the credit agreement (as defined) in relation to or arising out of any target 3 vendor loan stock guarantee (as defined)
    Brèves mentions
    The monies from time to time standing to the credit of the charged account (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC; As Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transactions
    • 27 juil. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 août 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental deed
    Créé le 10 juil. 1998
    Livré le 27 juil. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The actual contingent present and/or future obligations due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to any of the financing documents (as defined) which obligations are more particularly contained in the guarantee and debenture dated 24TH july 1995
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland P.L.C.; As Agent and Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transactions
    • 27 juil. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 août 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental deed
    Créé le 17 avr. 1998
    Livré le 23 avr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The actual contingent present and/or future obligations and liabilities of the company to any of the secured parties under or pursuant to any of the financing documents (as defined) which obligations are more particularly contained in the guarantee and debenture dated 24 july 1995
    Brèves mentions
    Assigns all rights title and interest in and to the target 4 acquisition agreement (as defined) and proceeds of any claim or action under the target 4 acquisition agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC(Security Trustee)
    Transactions
    • 23 avr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 août 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental legal charge
    Créé le 06 déc. 1996
    Livré le 09 déc. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee or to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to all or any of the secured documents (as defined) which obligations are more particularly contained in the debenture dated 24TH july 1995
    Brèves mentions
    L/H property k/a unit 7 stockton close, minworth industrial park, sutton coldfield, west midlands t/no: WM350132. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 09 déc. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 août 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Share pledge
    Créé le 24 juil. 1995
    Livré le 02 août 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and the borrowers (as defined) to the chargee and to any of the secured parties under or pursuant to any of the financing documents (as defined)
    Brèves mentions
    Any and all rights deriving from the 20,993 shares of a nominal value of 100 francs I.E. 99.96% of the company's capital and all rights that may arise. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC(As Agent and Trustee for the Secured Parties)
    Transactions
    • 02 août 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juil. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Share pledge
    Créé le 24 juil. 1995
    Livré le 02 août 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and the borrowers (as defined) to the chargee and to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to any of the financing documents (as defined)
    Brèves mentions
    Any and all rights deriving from 2,493 shares of nominal value of a 100 francs I.E. 99.72% of the company's capital or any and all rights that may arise. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC(As Agent and Trustee for the Secured Parties)
    Transactions
    • 02 août 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juil. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 24 juil. 1995
    Livré le 31 juil. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the secured parties and to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to any of the financing documents (as defined) including this guarantee and debenture
    Brèves mentions
    L/H property k/a unit A4 nugent industrial estate cray avenue st mary cray orpington kent l/h property k/a units E7,E8 and E9 central park trading estate trafford park manchester (and various other properties please see form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 31 juil. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 avr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0