GODFREY DAVIS (CONTRACT HIRE) LIMITED

GODFREY DAVIS (CONTRACT HIRE) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGODFREY DAVIS (CONTRACT HIRE) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00159020
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GODFREY DAVIS (CONTRACT HIRE) LIMITED ?

    • Octroi de crédit par les établissements financiers non-dépositaires et autres octroyeurs spécialisés de crédit à la consommation (64921) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe GODFREY DAVIS (CONTRACT HIRE) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de GODFREY DAVIS (CONTRACT HIRE) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    GODFREY DAVIS (LEASING) LIMITED 31 déc. 197731 déc. 1977
    UNITED SERVICES TRANSPORT COMPANY LIMITED22 sept. 191922 sept. 1919

    Quels sont les derniers comptes de GODFREY DAVIS (CONTRACT HIRE) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour GODFREY DAVIS (CONTRACT HIRE) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    9 pagesLIQ13

    Modification des coordonnées de l'administrateur Bertil Derrick Bos le 24 janv. 2019

    2 pagesCH01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN

    2 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de , Charterhall House, Charterhall Drive, Chester, Cheshire, CH88 3AN à 1 More London Place London SE1 2AF le 19 oct. 2018

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    6 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    4 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 28 sept. 2018

    LRESSP

    Cessation de la nomination de Richard Geoffrey Warnes en tant que directeur le 10 sept. 2018

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 01 févr. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Philip Robert Grant en tant que directeur le 28 juin 2017

    1 pagesTM01

    Nomination de Bertil Derrick Bos en tant qu'administrateur le 28 juin 2017

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Richard Geoffrey Warnes en tant qu'administrateur le 28 juin 2017

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    15 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 févr. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Paul Gittins en tant que secrétaire le 11 janv. 2017

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr David Dermot Hennessey en tant que secrétaire le 11 janv. 2017

    2 pagesAP03

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    17 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 févr. 2016

    État du capital au 01 févr. 2016

    • Capital: GBP 9,000,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    17 pagesAA

    Cessation de la nomination de David John Wills en tant que directeur le 09 sept. 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Philip Robert Grant en tant qu'administrateur le 13 août 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Richard Geoffrey Warnes en tant que directeur le 12 août 2015

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 févr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 févr. 2015

    État du capital au 04 févr. 2015

    • Capital: GBP 9,000,000
    SH01

    Qui sont les dirigeants de GODFREY DAVIS (CONTRACT HIRE) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HENNESSEY, David Dermot
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower House
    United Kingdom
    Secrétaire
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower House
    United Kingdom
    222327800001
    BOS, Bertil Derrick
    De Entree 254
    1011ee
    Amsterdam
    Lloyds Bank Gmbh
    Netherlands
    Administrateur
    De Entree 254
    1011ee
    Amsterdam
    Lloyds Bank Gmbh
    Netherlands
    NetherlandsDutchDirector234633010001
    GITTINS, Paul
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    Secrétaire
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    British45660860003
    NIXON, Raymond
    Holly House The Steadings
    Wicker Lane, Guilden Sutton
    CH3 7EL Chester
    Cheshire
    Secrétaire
    Holly House The Steadings
    Wicker Lane, Guilden Sutton
    CH3 7EL Chester
    Cheshire
    British36433110016
    BALLINGALL, Stuart James
    39 Craigleith Drive
    EH4 3JU Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    39 Craigleith Drive
    EH4 3JU Edinburgh
    Midlothian
    BritishChartered Accountant118506820001
    BARCLAY, William Gordon
    The Coulin
    122 Stanstead Road
    CR3 6AE Caterham
    Surrey
    Administrateur
    The Coulin
    122 Stanstead Road
    CR3 6AE Caterham
    Surrey
    BritishDirector33196560002
    BOCHENSKI, Anthony Joseph John
    Greenacres
    Bryn Offa Lane
    CH7 6RQ Mold
    Flintshire
    Administrateur
    Greenacres
    Bryn Offa Lane
    CH7 6RQ Mold
    Flintshire
    United KingdomBritishCompany Solicitor145644720001
    CHESSMAN, Mark Francis
    Hatchford Way
    B26 3RZ Birmingham
    Blake House
    United Kingdom
    Administrateur
    Hatchford Way
    B26 3RZ Birmingham
    Blake House
    United Kingdom
    EnglandBritishGeneral Manager196385070001
    DINGLEY, Leslie George
    5 Riverbank Court
    East Whitburn
    EH47 0FD Bathgate
    West Lothian
    Scotland
    Administrateur
    5 Riverbank Court
    East Whitburn
    EH47 0FD Bathgate
    West Lothian
    Scotland
    ScotlandBritishDirector85397020003
    FRANCIS, Rick
    Hatchford Way
    B26 3RZ Birmingham
    Blake House
    United Kingdom
    Administrateur
    Hatchford Way
    B26 3RZ Birmingham
    Blake House
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector180380320001
    GRANT, George Alexander
    131 Morningside Drive
    EH10 5NR Edinburgh
    Administrateur
    131 Morningside Drive
    EH10 5NR Edinburgh
    BritishCompany Director71010760002
    GRANT, Philip Robert
    Chiswell Street
    EC1Y 4XX London
    47-48
    United Kingdom
    Administrateur
    Chiswell Street
    EC1Y 4XX London
    47-48
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director136035750002
    HALLIWELL, Christopher Roger
    3 Hough Green
    CH4 8JG Chester
    Administrateur
    3 Hough Green
    CH4 8JG Chester
    BritishDivisional Director4254150002
    HARE, Robert Brown
    13 Balgreen Avenue
    EH12 5SX Edinburgh
    Lothian
    Administrateur
    13 Balgreen Avenue
    EH12 5SX Edinburgh
    Lothian
    BritishDirector64474720003
    LATTO, David Harry
    35 Palace Road
    HG4 1EZ Ripon
    North Yorkshire
    Administrateur
    35 Palace Road
    HG4 1EZ Ripon
    North Yorkshire
    BritishBanker113070380001
    LYONS, John Anthony
    14 Millhedge Close
    KT11 3BE Cobham
    Surrey
    Administrateur
    14 Millhedge Close
    KT11 3BE Cobham
    Surrey
    BritishDirector33232160003
    MERCER, John Alexander
    Llwyn-Y-Cyll
    Lixwm
    CH8 8LY Holywell
    Clwyd
    Administrateur
    Llwyn-Y-Cyll
    Lixwm
    CH8 8LY Holywell
    Clwyd
    BritishManaging Director4672880001
    MORRISON, Edward James
    50 Foresters Lea Crescent
    KY12 7TF Dunfermline
    Fife
    Administrateur
    50 Foresters Lea Crescent
    KY12 7TF Dunfermline
    Fife
    BritishBanker79242190001
    MORRISSEY, John Michael
    66 Selborne Road
    Southgate
    N14 7DG London
    Administrateur
    66 Selborne Road
    Southgate
    N14 7DG London
    EnglandBritishChartered Accountant94094650001
    PARKES, Carol Ann
    Heathside Park Road
    SK3 0RB Stockport
    Heathside
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Heathside Park Road
    SK3 0RB Stockport
    Heathside
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director139996590027
    STEAD, Nigel Cleator
    Blake House
    Hatchford Way
    B26 3RZ Birmingham
    Lex Autolease
    England
    England
    Administrateur
    Blake House
    Hatchford Way
    B26 3RZ Birmingham
    Lex Autolease
    England
    England
    EnglandBritishDirector47582470001
    TOWN, Lindsay John
    10 Ferndale
    TN2 3PB Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    10 Ferndale
    TN2 3PB Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandBritishManaging Director64287260001
    WALDEN, Jonathan Kim
    Hyatt Lodge
    Long Walk
    HP8 4AW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    England
    Administrateur
    Hyatt Lodge
    Long Walk
    HP8 4AW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritishCompany Director3809630002
    WARNES, Richard Geoffrey
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    United Kingdom
    Administrateur
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector193543370001
    WARNES, Richard Geoffrey
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    United Kingdom
    Administrateur
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector193543370001
    WILLS, David John
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Administrateur
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector193543410001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GODFREY DAVIS (CONTRACT HIRE) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    EH1 1YZ Edinburgh
    The Mound
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    EH1 1YZ Edinburgh
    The Mound
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiquePublic Limited Company
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleUnited Kingdom (Scotland)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrementSc327000
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    GODFREY DAVIS (CONTRACT HIRE) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Letter of charge
    Créé le 19 juin 1996
    Livré le 10 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All monies standing to the credit of any account or accounts in the banks books.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mai 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of charge
    Créé le 20 févr. 1995
    Livré le 22 févr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from capital incentives PLC and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the bank's books.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 22 févr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 août 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of charge
    Créé le 13 déc. 1994
    Livré le 23 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from capital incentives PLC and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the bank's books.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 févr. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of charge
    Créé le 12 août 1993
    Livré le 20 août 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the banks books.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 août 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 janv. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Certificate of assignment pursuant to a master assignment dated 21 september 1988
    Créé le 16 juin 1992
    Livré le 17 juin 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a master assignment dated 21 september 1988
    Brèves mentions
    Assignment by way of security of:- all monies due and to become due to the company under the sub-hire agreements specified in the schedule to the certificate of assignment.
    Personnes ayant droit
    • Ibos Finance Limited
    Transactions
    • 17 juin 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Certificate of assignment pursuant to a master assignment dated 21 september 1989
    Créé le 16 juin 1992
    Livré le 17 juin 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a master assignment dated 21 september 1989
    Brèves mentions
    Assignment by way of security of:- all monies due and to become due to the company under the sub-hire agreements specified in the schedule to the certificate of assignment.(see form 395 and attached schedule for full details).
    Personnes ayant droit
    • Nws 4 Limited
    Transactions
    • 17 juin 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Certificate of assignment pursuant to a master assignment dated 21 september 1988
    Créé le 13 juin 1992
    Livré le 13 juin 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a master assignment dated 21 september 1988
    Brèves mentions
    Assignment by way of security of:- 1)all monies due or to become due to the company under the sub hire agreements specified in the schedule to the certificate of assignment(see form 395 and attached schedule for full details).
    Personnes ayant droit
    • Nws 7 Limited
    Transactions
    • 13 juin 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Certificate of assignment pursuant to a master assignment dated 21 september 1988
    Créé le 12 juin 1992
    Livré le 13 juin 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become to from the company to the chargee pursuant to a master assignment dated 21 september 1988
    Brèves mentions
    Assignment by way of security of:- 1)all monies due and to become due from the company under the sub-hire agreements specified in the schedule to the certificate of assignment(see form 395 and attached schedule for full details).
    Personnes ayant droit
    • Nws 3 Limited
    Transactions
    • 13 juin 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Certificate of assignment pursuant to a master assignment dated 21 september 1989
    Créé le 12 juin 1992
    Livré le 13 juin 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a master assignment dated 21 september 1989
    Brèves mentions
    Assignment by way of security of 1)all monies due and to become due to the company under the sub-hire agreements specified in the schedule to the certificate of assignment (see form 395 and attached schedule for full details).
    Personnes ayant droit
    • Ibos Finance Limited
    Transactions
    • 13 juin 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Certificate of assignment
    Créé le 28 avr. 1992
    Livré le 30 avr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a master assignment dated 21-9-1988.
    Brèves mentions
    Assignment by way of security of :- all monies due and to become due to the company under the sub hire agreements specified in the schedule to the certificate of assignment. The benefit of all guarantees indemnities negotiable instruments and securities taken by the company in connection with the assigned agreements. Please see doc for further details.
    Personnes ayant droit
    • Nws 2
    Transactions
    • 30 avr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Certificate of assignment
    Créé le 23 avr. 1992
    Livré le 29 avr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the company to nws 3 limited pursuant to the terms of a master assignment dated 21-9-1989.
    Brèves mentions
    Assignment by way of security all monies due and to become due to the company under the sub hire agreements specified in the schedule to the certificate of assignment. The benefit of all guarantees indemnities negotiable instruments and securities taken by the company in connection with the assigned agreements. Please see doc 395 for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nws 3 Limited
    Transactions
    • 29 avr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Certificate of assignment
    Créé le 23 avr. 1992
    Livré le 29 avr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the company to ibos finance limited pursuant to the terms of a master assignment dated 21 -9- 1989.
    Brèves mentions
    Assignment by way of security all moneys due and to become due to the company under the sub hire agreements specified in the schedule to the certificate of assignment. The benefit of all guarantees indemnities negotiable instruments and securities taken by the company in connection with the assigned agreements. Please see doc 395 for further details.
    Personnes ayant droit
    • Ibos Finance Limited
    Transactions
    • 29 avr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Certificate of master asignment
    Créé le 14 avr. 1992
    Livré le 15 avr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the company to ibos finance limited pursuant to the terms of a master agreement dated 21ST september 1989 and this charge.
    Brèves mentions
    Assignment by way of security of: all monies due or to become due to the company under the sub hire agreements specified in the schedule to the certificate of assignment. Please see doc for further details.
    Personnes ayant droit
    • Ibos Finance Limited
    Transactions
    • 15 avr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge agreement
    Créé le 27 mars 1992
    Livré le 04 avr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £12,606.77 and all other money's due or to become due from the company to lloyds bowmaker limited under the terms of the charge agreement
    Brèves mentions
    A specified fixed charge over the rights and interests of the company under the hire agreements as specified in the schedule attached to form 395 . please see doc 395 for further details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transactions
    • 04 avr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 avr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge agreement
    Créé le 27 mars 1992
    Livré le 04 avr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £28,476.88 and all other moneys due or to become due from the company to lloyds bowmaker limited under the terms of the charge agreement
    Brèves mentions
    A specified fixed charge over the rights and interests of the company under the hire agreements as specified in the schedule attached to form 395. please see doc 395 for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transactions
    • 04 avr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 avr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge agreemnet
    Créé le 27 mars 1992
    Livré le 04 avr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £61,207.43 and any other money due or to become due from the company to lloyds bowmaker limited under the terms of the charge aggreement.
    Brèves mentions
    A specified fixed charge over all the rights and interests of the company under the hire agreements as specified in the schedule attached to form 395. please see form 395 for further details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transactions
    • 04 avr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 avr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge agreement
    Créé le 27 mars 1992
    Livré le 04 avr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £11,902.90 and all other monies due or to become due from the company to lloyds bowmaker limited under the terms of the charge agreement.
    Brèves mentions
    A specific fixed charge over all the rights and interests of the company under the hire agreements as specified in the schedule attached to form 395 please see form 395 for further details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transactions
    • 04 avr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 avr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge agreement
    Créé le 27 mars 1992
    Livré le 04 avr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £213,612.15 and all other monies due or to become due from the company to lloyds bowmaker limited under the terms of the charge agreement.
    Brèves mentions
    A specific fixed charge over all the rights and interests of the company under the hire agreements as specified in the schedule attached to form 395. please see form for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transactions
    • 04 avr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 avr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge agreement
    Créé le 27 mars 1992
    Livré le 04 avr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £33,581.23 and all other monies due or to become due from the company to lloyds bowmaker limited. Under the terms of the charge agreement.
    Brèves mentions
    A specific fixed charge over all the rights and interests of the hire agreements as specified in the schedule attached to form 395. please see doc 395 for further details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transactions
    • 04 avr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 avr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge agreement
    Créé le 20 mars 1992
    Livré le 31 mars 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £75,344.50 and all other monies due or to become due from the company to lloyds bowmaker limited under the terms of the charge.
    Brèves mentions
    Fixed charge over the company's rights and interest under the hire agreements as defined in the schedule attached to form 395 . please see doc 395 for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transactions
    • 31 mars 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 avr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge agreement
    Créé le 20 mars 1992
    Livré le 31 mars 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £28,072.27 and all other monies due or to become due from the company to the llods bowmaker limited under the terms of the charge.
    Brèves mentions
    Fixed charge over all the company's rights and interests under the hire agreements as specified in the schedule attached to form 395 . please see doc 395 for further details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transactions
    • 31 mars 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 avr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge agreement
    Créé le 20 mars 1992
    Livré le 31 mars 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £8,858.15 and all other monies due or to become due from the company to lloyds bowmaker limited under the terms of the charge.
    Brèves mentions
    Fixed charge over the company's rights and interests under the hire agreements as specified in the schedule attached to form 395. please see doc 395 for further details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transactions
    • 31 mars 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 avr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge agreement
    Créé le 20 mars 1992
    Livré le 31 mars 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £9,773.23 and all other monies due or to become due from the company to lloyds bowmaker limited under the terms of the charge.
    Brèves mentions
    Fixed charge over the company's right and interests under the hire agreements as specified in the schedule attached to form 395. please see form 395 for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transactions
    • 31 mars 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 avr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge agreement
    Créé le 20 mars 1992
    Livré le 31 mars 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £19,448.09 and all other monies due or to become due from the company to lloyds bowmaker limited under the terms of the charge.
    Brèves mentions
    Fixed charge over the company's rights and interests under the hire agreements as specified in the schedule attached to form 395. please see form 395 for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transactions
    • 31 mars 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 avr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge agreement
    Créé le 20 mars 1992
    Livré le 31 mars 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £11,287.14 and all other monies due or to become due from the company to lloyds bowmaker limited under the terms of the charge.
    Brèves mentions
    Fixed charge over the rights and interest of the company under the hire agreements as specified in the schedule attached to form 395. please see doc 395 for further details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transactions
    • 31 mars 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 avr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    GODFREY DAVIS (CONTRACT HIRE) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    28 sept. 2018Commencement of winding up
    24 oct. 2019Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0