FIRES NUMBER 2 LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | FIRES NUMBER 2 LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Liquidation |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00163557 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe FIRES NUMBER 2 LIMITED ?
Adresse du siège social | Brooks House Coventry Road CV34 4LL Warwick Warwickshire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de FIRES NUMBER 2 LIMITED ?
En retard | Oui |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2011 |
Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2012 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2010 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour FIRES NUMBER 2 LIMITED ?
En retard | Oui |
---|---|
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 30 sept. 2016 |
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 14 oct. 2016 |
En retard | Oui |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour FIRES NUMBER 2 LIMITED ?
Bilan annuel |
|
---|
Quels sont les derniers dépôts pour FIRES NUMBER 2 LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Restauration par ordonnance du tribunal | 3 pages | AC92 | ||||||||||
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 6 pages | 4.71 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 08 déc. 2013 | 7 pages | 4.68 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 08 déc. 2012 | 6 pages | 4.68 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 2 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de solvabilité | 3 pages | 4.70 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2011 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed valor newhome LIMITED\certificate issued on 07/10/11 | 4 pages | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Avis de changement de nom" | 2 pages | CONNOT | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010 | 1 pages | AA | ||||||||||
legacy | 2 pages | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009 | 1 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Adrian Egerton Darling le 28 sept. 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur John Mcfaull le 28 sept. 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Karen Roberts le 27 sept. 2010 | 2 pages | CH03 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de , 16 Stanier Way, Wyvern Business Park, Derby, Derbyshire, DE21 6BF, England le 27 sept. 2010 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Adrian Egerton Darling le 13 janv. 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur John Mcfaull le 13 janv. 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Karen Roberts le 13 janv. 2010 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2008 | 1 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2009 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de FIRES NUMBER 2 LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERTS, Karen Dawn | Secrétaire | Coventry Road CV34 4LL Warwick Brooks House Warwickshire England | British | 126457090001 | ||||||
DARLING, Adrian Egerton | Administrateur | Coventry Road CV34 4LL Warwick Brooks House Warwickshire England | United Kingdom | British | Group Finance Director | 13813980005 | ||||
MCFAULL, John | Administrateur | Coventry Road CV34 4LL Warwick Brooks House Warwickshire | British | Financial Controller | 83628430003 | |||||
BOND, Sarah Caroline | Secrétaire | Hillside 37 Rise End, Middleton DE4 4LS Wirksworth Derbyshire | British | 90181180006 | ||||||
CHAPMAN, Christopher John | Secrétaire | 5 The Willows Walmley B76 2PX Sutton Coldfield West Midlands | British | 50769680003 | ||||||
LOWE, Tracey | Secrétaire | 149 Smalley Drive Oakwood DE21 2SQ Derby Derbyshire | British | 86697030001 | ||||||
PERKINS, Michael William | Secrétaire | 38 Cubbington Road CV32 7AB Leamington Spa Warwickshire | British | 30958650001 | ||||||
STRATTON, Malcolm | Secrétaire | Flat 40 Manor Park Court, Uttoxeter New Road DE22 3NG Derby Derbyshire | British | 30601260018 | ||||||
STRATTON, Malcolm | Secrétaire | White Rose Grange Hollington Road Stubwood ST14 5HY Uttoxeter Staffordshire | British | 30601260002 | ||||||
DAVIES, Michael Thomas | Administrateur | 11 The Rills LE10 1NA Hinckley Leicestershire | British | Manager | 50770000001 | |||||
EDWARDS, Mark John | Administrateur | The Glen 35 Hazelwood Road DE56 4DP Duffield Derby | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 56562210001 | ||||
NASH, Robert Leslie | Administrateur | 12 Manor Fields Drive DE7 5FA Ilkeston Derbyshire | United Kingdom | British | Group Financial Controller | 83397580001 | ||||
PERKINS, Michael William | Administrateur | 38 Cubbington Road CV32 7AB Leamington Spa Warwickshire | United Kingdom | British | Accountant | 30958650001 | ||||
NEWMOND ADMINISTRATION LIMITED | Administrateur | Pentagon House Sir Frank Whittle Road DE21 4XA Derby Derbyshire | 57363930002 | |||||||
NEWMOND ADMINISTRATION LIMITED | Administrateur | Pentagon House Sir Frank Whittle Road DE21 4XA Derby Derbyshire | 57363930002 | |||||||
NEWMOND MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Administrateur | Pentagon House Sir Frank Whittle Road DE21 4XA Derby Derbyshire | 57363780002 | |||||||
NEWMOND MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Administrateur | Pentagon House Sir Frank Whittle Road DE21 4XA Derby Derbyshire | 57363780002 | |||||||
WESTMINSTER SECURITIES LIMITED | Administrateur | Pentagon House Sir Frank Whittle Road DE21 4XA Derby | 33480800001 | |||||||
WILLIAMS MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Administrateur | Pentagon House Sir Frank Whittle Road DE21 4XA Derby Derbyshire | 6125640001 |
FIRES NUMBER 2 LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Trade marks and patents charge | Créé le 26 mars 2004 Livré le 08 avr. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each of the charging companies to any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions By way of first fixed charge all the charged property being the patents, the trademarks, the patent applications, the trade mark applications of the chargor the goodwill of the chargor's business to which its patents, the trademarks, the patent applications, the trade mark applications relate. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A guarantee and debenture | Créé le 12 mars 2004 Livré le 25 mars 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each of the charging companies to any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Trade marks and patents charge made between the company and the royal bank of scotland PLC as agent and trustee for the secured parties (as defined) | Créé le 28 nov. 2000 Livré le 12 déc. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti The actual contingent, present and/or future obligations and liabilities of the company to any of the secured parties under or pursuant to any of the secured documents (as defined) including the trade marks and patents charge | |
Brèves mentions A first fixed charge over the trade mark together with any goodwill of the company's business to which the trade mark relates and to any other intellectual property rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee and debenture made between the company and the royal bank of scotland PLC as agent and trustee for the secured parties (as defined) pursuant to the intercreditor agreement (as defined) | Créé le 28 nov. 2000 Livré le 12 déc. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti The actual contingent present and/or future obligations and liabilities of the company to any of the secured parties under or pursuant to all or any of the secured documents (as defined) including the guarantee and debenture | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Accession agreement relating to a debenture dated 4/12/96 | Créé le 31 déc. 1996 Livré le 09 janv. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the finance documents (as defined) | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Further guarantee & debenture | Créé le 30 sept. 1982 Livré le 07 oct. 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All that property undertaking and assets charges by the principal deed and further deed. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Further guarantee debentures | Créé le 24 déc. 1981 Livré le 13 janv. 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever and/or all or any of the other companies named therein. | |
Brèves mentions Charged by the principal deed & further deed. Undertaking and all property and assets. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 06 sept. 1972 Livré le 21 sept. 1972 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever buy not exceeding £500,000 | |
Brèves mentions Land & premises at whiston & rainhill.land at rear of 1 lumber lane whiston. 24 stoney lane whiston lane. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
FIRES NUMBER 2 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0