FIRES NUMBER 2 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFIRES NUMBER 2 LIMITED
    Statut de la sociétéLiquidation
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00163557
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FIRES NUMBER 2 LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe FIRES NUMBER 2 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Brooks House
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Warwickshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de FIRES NUMBER 2 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    VALOR NEWHOME LIMITED31 déc. 197631 déc. 1976
    STOVES LIMITED31 janv. 192031 janv. 1920

    Quels sont les derniers comptes de FIRES NUMBER 2 LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2011
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2012
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour FIRES NUMBER 2 LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au30 sept. 2016
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation14 oct. 2016
    En retardOui

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour FIRES NUMBER 2 LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour FIRES NUMBER 2 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Restauration par ordonnance du tribunal

    3 pagesAC92

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pages4.71

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 08 déc. 2013

    7 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 08 déc. 2012

    6 pages4.68

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 oct. 2011

    État du capital au 27 oct. 2011

    • Capital: GBP 450,450
    SH01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed valor newhome LIMITED\certificate issued on 07/10/11
    4 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name07 oct. 2011

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    1 pagesAA

    legacy

    2 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    1 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Adrian Egerton Darling le 28 sept. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur John Mcfaull le 28 sept. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Karen Roberts le 27 sept. 2010

    2 pagesCH03

    Changement d'adresse du siège social de , 16 Stanier Way, Wyvern Business Park, Derby, Derbyshire, DE21 6BF, England le 27 sept. 2010

    1 pagesAD01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Adrian Egerton Darling le 13 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur John Mcfaull le 13 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Karen Roberts le 13 janv. 2010

    1 pagesCH03

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2008

    1 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 sept. 2009 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de FIRES NUMBER 2 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ROBERTS, Karen Dawn
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    Secrétaire
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    British126457090001
    DARLING, Adrian Egerton
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    Administrateur
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritishGroup Finance Director13813980005
    MCFAULL, John
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    Administrateur
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    BritishFinancial Controller83628430003
    BOND, Sarah Caroline
    Hillside
    37 Rise End, Middleton
    DE4 4LS Wirksworth
    Derbyshire
    Secrétaire
    Hillside
    37 Rise End, Middleton
    DE4 4LS Wirksworth
    Derbyshire
    British90181180006
    CHAPMAN, Christopher John
    5 The Willows
    Walmley
    B76 2PX Sutton Coldfield
    West Midlands
    Secrétaire
    5 The Willows
    Walmley
    B76 2PX Sutton Coldfield
    West Midlands
    British50769680003
    LOWE, Tracey
    149 Smalley Drive
    Oakwood
    DE21 2SQ Derby
    Derbyshire
    Secrétaire
    149 Smalley Drive
    Oakwood
    DE21 2SQ Derby
    Derbyshire
    British86697030001
    PERKINS, Michael William
    38 Cubbington Road
    CV32 7AB Leamington Spa
    Warwickshire
    Secrétaire
    38 Cubbington Road
    CV32 7AB Leamington Spa
    Warwickshire
    British30958650001
    STRATTON, Malcolm
    Flat 40
    Manor Park Court, Uttoxeter New Road
    DE22 3NG Derby
    Derbyshire
    Secrétaire
    Flat 40
    Manor Park Court, Uttoxeter New Road
    DE22 3NG Derby
    Derbyshire
    British30601260018
    STRATTON, Malcolm
    White Rose Grange Hollington Road
    Stubwood
    ST14 5HY Uttoxeter
    Staffordshire
    Secrétaire
    White Rose Grange Hollington Road
    Stubwood
    ST14 5HY Uttoxeter
    Staffordshire
    British30601260002
    DAVIES, Michael Thomas
    11 The Rills
    LE10 1NA Hinckley
    Leicestershire
    Administrateur
    11 The Rills
    LE10 1NA Hinckley
    Leicestershire
    BritishManager50770000001
    EDWARDS, Mark John
    The Glen
    35 Hazelwood Road
    DE56 4DP Duffield
    Derby
    Administrateur
    The Glen
    35 Hazelwood Road
    DE56 4DP Duffield
    Derby
    United KingdomBritishChartered Accountant56562210001
    NASH, Robert Leslie
    12 Manor Fields Drive
    DE7 5FA Ilkeston
    Derbyshire
    Administrateur
    12 Manor Fields Drive
    DE7 5FA Ilkeston
    Derbyshire
    United KingdomBritishGroup Financial Controller83397580001
    PERKINS, Michael William
    38 Cubbington Road
    CV32 7AB Leamington Spa
    Warwickshire
    Administrateur
    38 Cubbington Road
    CV32 7AB Leamington Spa
    Warwickshire
    United KingdomBritishAccountant30958650001
    NEWMOND ADMINISTRATION LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    Administrateur
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    57363930002
    NEWMOND ADMINISTRATION LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    Administrateur
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    57363930002
    NEWMOND MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    Administrateur
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    57363780002
    NEWMOND MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    Administrateur
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    57363780002
    WESTMINSTER SECURITIES LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Administrateur
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    33480800001
    WILLIAMS MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    Administrateur
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    6125640001

    FIRES NUMBER 2 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Trade marks and patents charge
    Créé le 26 mars 2004
    Livré le 08 avr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each of the charging companies to any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge all the charged property being the patents, the trademarks, the patent applications, the trade mark applications of the chargor the goodwill of the chargor's business to which its patents, the trademarks, the patent applications, the trade mark applications relate. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Secured Parties
    Transactions
    • 08 avr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A guarantee and debenture
    Créé le 12 mars 2004
    Livré le 25 mars 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each of the charging companies to any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC, as Agent and Trustee (The Security Trustee) for the Securedparties
    Transactions
    • 25 mars 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Trade marks and patents charge made between the company and the royal bank of scotland PLC as agent and trustee for the secured parties (as defined)
    Créé le 28 nov. 2000
    Livré le 12 déc. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The actual contingent, present and/or future obligations and liabilities of the company to any of the secured parties under or pursuant to any of the secured documents (as defined) including the trade marks and patents charge
    Brèves mentions
    A first fixed charge over the trade mark together with any goodwill of the company's business to which the trade mark relates and to any other intellectual property rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 12 déc. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 mars 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture made between the company and the royal bank of scotland PLC as agent and trustee for the secured parties (as defined) pursuant to the intercreditor agreement (as defined)
    Créé le 28 nov. 2000
    Livré le 12 déc. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The actual contingent present and/or future obligations and liabilities of the company to any of the secured parties under or pursuant to all or any of the secured documents (as defined) including the guarantee and debenture
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 12 déc. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 mars 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Accession agreement relating to a debenture dated 4/12/96
    Créé le 31 déc. 1996
    Livré le 09 janv. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the finance documents (as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Morgan Grenfell & Co. Limited,as Agent for the Chargors
    Transactions
    • 09 janv. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 déc. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Further guarantee & debenture
    Créé le 30 sept. 1982
    Livré le 07 oct. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that property undertaking and assets charges by the principal deed and further deed.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 07 oct. 1982Enregistrement d'une charge
    Further guarantee debentures
    Créé le 24 déc. 1981
    Livré le 13 janv. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever and/or all or any of the other companies named therein.
    Brèves mentions
    Charged by the principal deed & further deed. Undertaking and all property and assets.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 janv. 1982Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 06 sept. 1972
    Livré le 21 sept. 1972
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever buy not exceeding £500,000
    Brèves mentions
    Land & premises at whiston & rainhill.land at rear of 1 lumber lane whiston. 24 stoney lane whiston lane.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 21 sept. 1972Enregistrement d'une charge

    FIRES NUMBER 2 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    09 déc. 2011Commencement of winding up
    15 avr. 2014Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Timothy Gerard Walsh
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    practitioner
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0