NATIONWIDE ACCIDENT REPAIR CENTRES LIMITED

NATIONWIDE ACCIDENT REPAIR CENTRES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNATIONWIDE ACCIDENT REPAIR CENTRES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00163614
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NATIONWIDE ACCIDENT REPAIR CENTRES LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe NATIONWIDE ACCIDENT REPAIR CENTRES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    17a Thorney Leys Park
    Witney
    OX28 4GE Oxfordshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NATIONWIDE ACCIDENT REPAIR CENTRES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PERRY GROUP QUEST TRUSTEES LIMITED14 juil. 199714 juil. 1997
    ROCAR (GAINSBOROUGH) LIMITED31 déc. 197931 déc. 1979
    BAINES BROS.,LIMITED03 févr. 192003 févr. 1920

    Quels sont les derniers comptes de NATIONWIDE ACCIDENT REPAIR CENTRES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour NATIONWIDE ACCIDENT REPAIR CENTRES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 29 mars 2021

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Période comptable précédente raccourcie du 31 déc. 2019 au 30 déc. 2019

    1 pagesAA01

    Cessation de la nomination de David Richard Pugh en tant que directeur le 17 juil. 2020

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 02 janv. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de David Richard Pugh en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 janv. 2019

    1 pagesPSC07

    Notification de Nationwide Accident Repair Services Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 janv. 2019

    2 pagesPSC02

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2018

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 02 janv. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 02 janv. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2017

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 10 avr. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2016

    2 pagesAA

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2015

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 avr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 avr. 2016

    État du capital au 14 avr. 2016

    • Capital: GBP 12,192
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 avr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 avr. 2015

    État du capital au 10 avr. 2015

    • Capital: GBP 12,192
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2014

    3 pagesAA

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2013

    3 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Michael Alfred Wilmshurst le 12 sept. 2014

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 mai 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 mai 2014

    État du capital au 28 mai 2014

    • Capital: GBP 12,192
    SH01

    Qui sont les dirigeants de NATIONWIDE ACCIDENT REPAIR CENTRES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WILMSHURST, Michael Alfred
    17a Thorney Leys Park
    Witney
    OX28 4GE Oxfordshire
    Administrateur
    17a Thorney Leys Park
    Witney
    OX28 4GE Oxfordshire
    EnglandBritish82302420002
    HICKMAN-ASHBY, Martin James
    7 High Elms Close
    HA6 2DG Northwood
    Middlesex
    Secrétaire
    7 High Elms Close
    HA6 2DG Northwood
    Middlesex
    British1841480001
    ALLAN, Richard Ronald
    Mornington House 1 High Trees
    CM4 9DQ Stock
    Essex
    Administrateur
    Mornington House 1 High Trees
    CM4 9DQ Stock
    Essex
    United KingdomBritish1841490001
    HICKMAN-ASHBY, Martin James
    7 High Elms Close
    HA6 2DG Northwood
    Middlesex
    Administrateur
    7 High Elms Close
    HA6 2DG Northwood
    Middlesex
    EnglandBritish1841480001
    HOGG, David John
    Parklands Hall
    Church Hill, Middleton On The Wolds
    YO25 9UG Driffield
    East Yorkshire
    Administrateur
    Parklands Hall
    Church Hill, Middleton On The Wolds
    YO25 9UG Driffield
    East Yorkshire
    British113013220001
    JAY, Peter Harry
    Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    100
    Administrateur
    Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    100
    United KingdomBritish34963720001
    LANE, Martin William
    Churchfields 6 New Road
    Great Chishill
    SG8 8ST Royston
    Hertfordshire
    Administrateur
    Churchfields 6 New Road
    Great Chishill
    SG8 8ST Royston
    Hertfordshire
    British1841500001
    PUGH, David Richard
    17a Thorney Leys Park
    Witney
    OX28 4GE Oxfordshire
    Administrateur
    17a Thorney Leys Park
    Witney
    OX28 4GE Oxfordshire
    EnglandBritish108788360001
    TURNER, Lesley Bridget
    68 Grovedale Close
    EN7 5NE Cheshunt
    Herts
    Administrateur
    68 Grovedale Close
    EN7 5NE Cheshunt
    Herts
    British1762570003

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur NATIONWIDE ACCIDENT REPAIR CENTRES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Nationwide Accident Repair Services Ltd
    Thorney Leys Park
    OX28 4GE Witney
    17
    England
    01 janv. 2019
    Thorney Leys Park
    OX28 4GE Witney
    17
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement966807
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    Mr David Richard Pugh
    17a Thorney Leys Park
    Witney
    OX28 4GE Oxfordshire
    06 avr. 2016
    17a Thorney Leys Park
    Witney
    OX28 4GE Oxfordshire
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    NATIONWIDE ACCIDENT REPAIR CENTRES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Fixed and floating charge
    Créé le 21 janv. 1986
    Livré le 24 janv. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A fixed charge on all book and other debts owing to the company floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital. Excluding (those mentioned above).
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 24 janv. 1986Enregistrement d'une charge
    • 26 juin 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 15 févr. 1980
    Livré le 25 févr. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts uncalled capital. (See doc M120 for details).
    Personnes ayant droit
    • Mercantile Credit Company LTD
    Transactions
    • 25 févr. 1980Enregistrement d'une charge
    Floating charge
    Créé le 19 juin 1978
    Livré le 23 juin 1978
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Floating charge over the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 23 juin 1978Enregistrement d'une charge
    • 26 juin 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 04 mai 1977
    Livré le 17 mai 1977
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For securing sums not exceeding £15,000 which the chargee may be called upon to pay to the bank of new york under the terms of a guarantee dated 4TH may 1977 and all other monies due or to become due from the company to the chargee in connection with the property charged or business carried on thereat
    Brèves mentions
    Land at situate at gainsborough, lincoln having a frontage to north street and church street, together with all buildings erected thereon.
    Personnes ayant droit
    • Texaco LTD
    Transactions
    • 17 mai 1977Enregistrement d'une charge
    • 26 juin 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 09 juil. 1975
    Livré le 16 juil. 1975
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property known as 1 works offices and show rooms, north street, gainsborough & dwellinghouse 32 & 34 north street gainsborough. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 16 juil. 1975Enregistrement d'une charge
    • 26 juin 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 09 juil. 1975
    Livré le 16 juil. 1975
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold property known as house, fractory buildings and approximately 1689 sq yards land in all, wintern house and wintern works carlisle street, gainsborugh.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 16 juil. 1975Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 09 juil. 1975
    Livré le 16 juil. 1975
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    28 north street, gainsborough. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 16 juil. 1975Enregistrement d'une charge
    • 26 juin 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 25 juil. 1973
    Livré le 08 août 1973
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Sums n/e £25,000 which the chargee may be called upon to pay to the bank of new york pursuant to a guarantee entered into by the chargee and any other monies due from the co. To the chargee in connection with property thereby charged on this business carried on.
    Brèves mentions
    Land fronting to north street/church street gainsborough, lincs together with all buildings erected thereon.
    Personnes ayant droit
    • Texaco LTD.
    Transactions
    • 08 août 1973Enregistrement d'une charge
    • 26 juin 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0