STANLEY GIBBONS AUCTIONS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | STANLEY GIBBONS AUCTIONS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00163668 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe STANLEY GIBBONS AUCTIONS LIMITED ?
Adresse du siège social | 399 Strand London WC2R 0LX |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de STANLEY GIBBONS AUCTIONS LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2022 |
Quels sont les derniers dépôts pour STANLEY GIBBONS AUCTIONS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |
---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||
Cessation de la nomination de Kevin Fitzpatrick en tant que directeur le 02 août 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Tom Pickford en tant que directeur le 02 août 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||
Nomination de Mr Kevin Fitzpatrick en tant qu'administrateur le 01 août 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Tom Pickford en tant qu'administrateur le 01 août 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Tom Pickford en tant que directeur le 01 août 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Kevin Fitzpatrick en tant que directeur le 01 août 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Kevin Fitzpatrick en tant que secrétaire le 01 août 2023 | 1 pages | TM02 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Tom Pickford le 01 janv. 2023 | 2 pages | CH01 | ||
Cessation de la nomination de Graham Elliott Shircore en tant que directeur le 01 janv. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Tom Pickford en tant qu'administrateur le 01 janv. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 29 déc. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes de micro-entité établis au 31 mars 2022 | 3 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 29 déc. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mr Kevin Fitzpatrick en tant que secrétaire le 15 nov. 2021 | 2 pages | AP03 | ||
Nomination de Mr Kevin Fitzpatrick en tant qu'administrateur le 15 nov. 2021 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Anthony Michael Gee en tant que directeur le 15 nov. 2021 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Anthony Michael Gee en tant que secrétaire le 15 nov. 2021 | 1 pages | TM02 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2021 | 1 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 29 déc. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Richard Kenneth Purkis en tant que directeur le 02 nov. 2020 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Graham Elliott Shircore en tant qu'administrateur le 02 nov. 2020 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Anthony Michael Gee en tant que secrétaire le 02 nov. 2020 | 2 pages | AP03 | ||
Qui sont les dirigeants de STANLEY GIBBONS AUCTIONS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITZPATRICK, Kevin | Secrétaire | 399 Strand London WC2R 0LX | 289605610001 | |||||||
GEE, Anthony Michael | Secrétaire | 399 Strand London WC2R 0LX | 276052100001 | |||||||
PANDIT, Arvind Jivanlal | Secrétaire | 33 Oak Vale West End SO30 3SE Southampton Hampshire | British | Chartered Accountant | 4791360001 | |||||
PURKIS, Richard Kenneth | Secrétaire | Chiswell House Shernden Lane Marsh Green TN8 5PR Edenbridge Kent | British | Administrator | 50467140001 | |||||
CROCKER, David John | Administrateur | 2 Clover Way Paddock Wood TN12 6BQ Tonbridge Kent | British | Philatelist | 23422730002 | |||||
DUNNINGHAM, Timothy | Administrateur | Avranches Farm La Ruette D`Avranches St Lawrence JE3 1GJ Jersey Channel Islands | Jersey | British | Chief Executive | 58978030001 | ||||
ELLIOTT SHIRCORE, Graham | Administrateur | 399 Strand London WC2R 0LX | England | British | Company Executive | 276026200001 | ||||
FITZPATRICK, Kevin | Administrateur | 399 Strand London WC2R 0LX | England | Irish | Director | 117212260001 | ||||
FITZPATRICK, Kevin | Administrateur | 399 Strand London WC2R 0LX | England | Irish | Chief Finance Officer | 117212260001 | ||||
FRASER, Paul Ian | Administrateur | 222 Cheltenham Road BS6 5QU Bristol Avon | British | Retailer | 5342100001 | |||||
GEE, Anthony Michael | Administrateur | 399 Strand London WC2R 0LX | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 181780820001 | ||||
GRODECKI, Antony Richard Jan | Administrateur | The Maltings Hopgarden Lane TN13 1PX Sevenoaks Kent | British | Managing Director | 42800860002 | |||||
HALL, Michael Robert Montague | Administrateur | Doyle Court Doyle Road St Peter Port GY1 1RD Guernsey Channel Islands | British | Chartered Accountant | 74643910002 | |||||
HEDDLE, Keith Andrew Millar | Administrateur | 399 Strand London WC2R 0LX | England | British | Sales & Marketing Director | 164474410001 | ||||
HENLEY, Mark David | Administrateur | 399 Strand London WC2R 0LX | England | British | Accountant | 52315890005 | ||||
MCQUILLAN, Anthony Michael | Administrateur | Church Lodge Station Road Wrington BS40 5LG Bristol Avon | Irish | Publisher | 22631310001 | |||||
PANDIT, Arvind Jivanlal | Administrateur | 33 Oak Vale West End SO30 3SE Southampton Hampshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 4791360001 | ||||
PICKFORD, Tom | Administrateur | 399 Strand London WC2R 0LX | England | British | Ceo | 303763600001 | ||||
PICKFORD, Tom | Administrateur | 399 Strand London WC2R 0LX | England | British | Chief Executive Officer | 303764130002 | ||||
PURKIS, Richard Kenneth | Administrateur | 399 Strand London WC2R 0LX | England | British | Administrator | 50467140001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur STANLEY GIBBONS AUCTIONS LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stanley Gibbons Holdings Limited | 06 avr. 2016 | Strand WC2R 0LX London 399 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
STANLEY GIBBONS AUCTIONS LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Mortgage debenture | Créé le 15 oct. 1993 Livré le 27 oct. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee and debenture | Créé le 07 sept. 1989 Livré le 22 sept. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies name therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee and debenture deed | Créé le 11 juin 1986 Livré le 17 juin 1986 | Totalement satisfaite | Montant garanti All moneys due or to become due from the company and/or the "companies" (as defined) to the chargee under the terms of the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Further guarantee & debenture | Créé le 29 oct. 1984 Livré le 16 nov. 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All that property undertaking and assets charges by the principal deed and further deed. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee debenture | Créé le 25 juin 1982 Livré le 09 juil. 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies names therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee & debenture | Créé le 25 juin 1982 Livré le 12 juil. 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti Sterling pounds 1750000 and all other monies due or to become due from stanley gibbons international limited to the chargee under one terms of a share sale agreement dtd 25.6.1982 | |
Brèves mentions Fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwills, debts uncalled capital, with all buildings, fixtures, fixed plant & machinery (see doc M113 for full details). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0