HUGH STEEPER LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHUGH STEEPER LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00173865
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HUGH STEEPER LIMITED ?

    • Fabrication d'instruments et fournitures médicaux et dentaires (32500) / Industries manufacturières
    • Autres activités liées à la santé humaine (86900) / Activités de santé humaine et d'action sociale

    Où se situe HUGH STEEPER LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Unit 3, Stourton Link
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HUGH STEEPER LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    IDEAL LIMBS LIMITED02 juil. 199002 juil. 1990
    HUGH STEEPER,LIMITED23 mars 192123 mars 1921

    Quels sont les derniers comptes de HUGH STEEPER LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le30 sept. 2024
    Date d'échéance des prochains comptes30 juin 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour HUGH STEEPER LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au12 juin 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation26 juin 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au12 juin 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour HUGH STEEPER LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Cessation de la nomination de Jonathan Mark Murfin en tant que directeur le 05 nov. 2024

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Carl Chatfield en tant que directeur le 05 nov. 2024

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2023

    30 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 12 juin 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Période comptable précédente raccourcie du 28 févr. 2024 au 30 sept. 2023

    1 pagesAA01

    Comptes annuels établis au 28 févr. 2023

    28 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 12 juin 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Statuts

    9 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Satisfaction de la charge 001738650011 en totalité

    1 pagesMR04

    Inscription de la charge 001738650012, créée le 09 mars 2023

    13 pagesMR01

    Nomination de Mr Jean-Pierre Michel Paul Mahe en tant qu'administrateur le 08 mars 2023

    2 pagesAP01

    Cessation de Paul Martin Steeper en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 08 mars 2023

    1 pagesPSC07

    Cessation de John Antony Midgley en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 08 mars 2023

    1 pagesPSC07

    Statuts

    10 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    resolution

    Résolution de capitalisation ou d'émission d'actions gratuites

    Capitalise the sum of £27,229,349 26/01/2017
    RES14
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Comptes annuels établis au 28 févr. 2022

    27 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 12 juin 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Paul Drake en tant que directeur le 21 févr. 2022

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 28 févr. 2021

    28 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 12 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Andrew Nicol en tant qu'administrateur le 01 mars 2021

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Paul Drake en tant qu'administrateur le 01 mars 2021

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Ian Stuart Rodger en tant qu'administrateur le 01 mars 2021

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Jonathan Mark Murfin en tant qu'administrateur le 01 mars 2021

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de HUGH STEEPER LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HARVEY-KITCHING, Emma Claire
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    Unit 3, Stourton Link
    England
    Secrétaire
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    Unit 3, Stourton Link
    England
    250527450001
    HARVEY-KITCHING, Emma Claire
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    Unit 3, Stourton Link
    England
    Administrateur
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    Unit 3, Stourton Link
    England
    EnglandBritishDirector279714040001
    MAHE, Jean-Pierre Michel Paul
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    Unit 3, Stourton Link
    England
    Administrateur
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    Unit 3, Stourton Link
    England
    FranceFrenchChairman And Ceo305810950001
    MIDGLEY, John Antony
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    Unit 3, Stourton Link
    England
    Administrateur
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    Unit 3, Stourton Link
    England
    United KingdomBritishDirector45716360003
    NICOL, Andrew
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    Unit 3, Stourton Link
    England
    Administrateur
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    Unit 3, Stourton Link
    England
    EnglandBritishDirector280271140001
    RODGER, Ian Stuart
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    Unit 3, Stourton Link
    England
    Administrateur
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    Unit 3, Stourton Link
    England
    EnglandBritishDirector280266610001
    STEEPER, Paul Martin
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    Unit 3, Stourton Link
    England
    Administrateur
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    Unit 3, Stourton Link
    England
    EnglandBritishDirector183358890001
    ALI, Sheikh Ghulam
    11 Cleveland Gardens
    KT4 7JJ Worcester Park
    Surrey
    Secrétaire
    11 Cleveland Gardens
    KT4 7JJ Worcester Park
    Surrey
    British12441120002
    CROSS, Richard Alexander
    The Old School House
    Church Hill, Charing Heath
    TN27 0BU Ashford
    Kent
    Secrétaire
    The Old School House
    Church Hill, Charing Heath
    TN27 0BU Ashford
    Kent
    BritishCompany Director178817310001
    CROSS, Richard Alexander
    The Old School House
    Church Hill, Charing Heath
    TN27 0BU Ashford
    Kent
    Secrétaire
    The Old School House
    Church Hill, Charing Heath
    TN27 0BU Ashford
    Kent
    BritishCompany Director178817310001
    MIDGLEY, John Antony
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    Unit 3, Stourton Link
    England
    Secrétaire
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    Unit 3, Stourton Link
    England
    BritishDirector45716360002
    O'CALLAGHAN, Perry Charles
    9 Court Lodge Cottages
    Lower Road East Farleigh
    ME15 0JL Maidstone
    Kent
    Secrétaire
    9 Court Lodge Cottages
    Lower Road East Farleigh
    ME15 0JL Maidstone
    Kent
    BritishAccountant30363240003
    ORAM, Stephen Marcus
    Shernold House
    1a Paynes Lane
    ME15 9QT Maidstone
    Kent
    Secrétaire
    Shernold House
    1a Paynes Lane
    ME15 9QT Maidstone
    Kent
    BritishAccountant57274140002
    HBJGW SECRETARIAL SUPPORT LIMITED
    One Eleven Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    West Midlands
    Secrétaire
    One Eleven Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    West Midlands
    93128710002
    BERTHINUSSEN, Angus Park
    Parkview
    34 Dewartown
    EH23 4NX Gorebridge
    Midlothian
    Administrateur
    Parkview
    34 Dewartown
    EH23 4NX Gorebridge
    Midlothian
    ScotlandBritishProsthetics Director30945100003
    CHATFIELD, Carl
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    Unit 3, Stourton Link
    England
    Administrateur
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    Unit 3, Stourton Link
    England
    EnglandBritishDirector251551570001
    CROSS, Richard Alexander
    The Old School House
    Church Hill, Charing Heath
    TN27 0BU Ashford
    Kent
    Administrateur
    The Old School House
    Church Hill, Charing Heath
    TN27 0BU Ashford
    Kent
    UkBritishCompany Director178817310001
    CROSS, Richard Alexander
    The Old School House
    Church Hill, Charing Heath
    TN27 0BU Ashford
    Kent
    Administrateur
    The Old School House
    Church Hill, Charing Heath
    TN27 0BU Ashford
    Kent
    UkBritishCompany Director178817310001
    DAVIES, Mark Leslie
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    Unit 3, Stourton Link
    England
    Administrateur
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    Unit 3, Stourton Link
    England
    EnglandBritishDirector251551630001
    DAVIES, Mark
    17 Heyford Grove
    B91 3XX Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    17 Heyford Grove
    B91 3XX Solihull
    West Midlands
    BritishOrthotist49400350003
    DRAKE, Paul
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    Unit 3, Stourton Link
    England
    Administrateur
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    Unit 3, Stourton Link
    England
    EnglandBritishDirector280267120001
    FAIRCLOUGH, James
    The Salt Box
    Lower Road
    KT22 9H Fetcham
    Surrey
    Administrateur
    The Salt Box
    Lower Road
    KT22 9H Fetcham
    Surrey
    United KingdomBritishSolicitor122061390001
    HODGSON, Giles Charles
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    Unit 3, Stourton Link
    England
    Administrateur
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    Unit 3, Stourton Link
    England
    EnglandBritishDirector230051830001
    HOLLAMBY, John
    Melborne House
    124a Borden Lane
    ME9 8HR Sittingbourne
    Kent
    Administrateur
    Melborne House
    124a Borden Lane
    ME9 8HR Sittingbourne
    Kent
    BritishProsthetist11350680003
    JOYCE, Shaun William
    c/o Rsl Steeper
    Hunslet Trading Estate
    Severn Road
    LS10 1BL Leeds
    Unit 7
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Rsl Steeper
    Hunslet Trading Estate
    Severn Road
    LS10 1BL Leeds
    Unit 7
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector133825540001
    KNIGHT, David
    99 Elmstead Gardens
    KT4 7BG Worcester Park
    Surrey
    Administrateur
    99 Elmstead Gardens
    KT4 7BG Worcester Park
    Surrey
    BritishDirector12441150001
    MILLER, Alasdair James
    22 Beauly Crescent
    Newton Mearns
    G77 5UQ Glasgow
    Administrateur
    22 Beauly Crescent
    Newton Mearns
    G77 5UQ Glasgow
    United KingdomBritishDirector200739750001
    MILLS, Trevor James
    Elm Tree House
    The Green Dunsfold
    GU8 4LZ Godalming
    Surrey
    Administrateur
    Elm Tree House
    The Green Dunsfold
    GU8 4LZ Godalming
    Surrey
    BritishFinancial Director33843850001
    MURFIN, Jonathan Mark
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    Unit 3, Stourton Link
    England
    Administrateur
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    Unit 3, Stourton Link
    England
    EnglandBritishDirector280266420001
    O'CALLAGHAN, Perry Charles
    9 Court Lodge Cottages
    Lower Road East Farleigh
    ME15 0JL Maidstone
    Kent
    Administrateur
    9 Court Lodge Cottages
    Lower Road East Farleigh
    ME15 0JL Maidstone
    Kent
    BritishAccountant30363240003
    ORAM, Stephen Marcus
    Shernold House
    1a Paynes Lane
    ME15 9QT Maidstone
    Kent
    Administrateur
    Shernold House
    1a Paynes Lane
    ME15 9QT Maidstone
    Kent
    EnglandBritishAccountant57274140002
    RANDERSON, Mark Andrew
    c/o Rsl Steeper
    Hunslet Trading Estate
    Severn Road
    LS10 1BL Leeds
    Unit 7
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Rsl Steeper
    Hunslet Trading Estate
    Severn Road
    LS10 1BL Leeds
    Unit 7
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector178061350001
    SHEARD, Gary, Dr
    Riverside 2
    Medway City Estate
    ME2 4DP Rochester
    51
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Riverside 2
    Medway City Estate
    ME2 4DP Rochester
    51
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector118863590001
    STEEPER, Kenneth Oscar
    Morland 14 Cheyham Way
    Cheam
    SM2 7HX Sutton
    Surrey
    Administrateur
    Morland 14 Cheyham Way
    Cheam
    SM2 7HX Sutton
    Surrey
    BritishDirector12441130001
    STEEPER, Paul Martin
    361 Reigate Road
    Epsom Downs
    KT17 3LU Epsom
    Surrey
    Administrateur
    361 Reigate Road
    Epsom Downs
    KT17 3LU Epsom
    Surrey
    BritishSales Director32025980001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HUGH STEEPER LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr John Antony Midgley
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    Unit 3, Stourton Link
    England
    06 avr. 2016
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    Unit 3, Stourton Link
    England
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: United Kingdom
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Mr Paul Martin Steeper
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    Unit 3, Stourton Link
    England
    06 avr. 2016
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    Unit 3, Stourton Link
    England
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    Unit 3 Stourton Link
    England
    06 avr. 2016
    Intermezzo Drive
    LS10 1DF Leeds
    Unit 3 Stourton Link
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement03039649
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    HUGH STEEPER LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 09 mars 2023
    Livré le 10 mars 2023
    En cours
    Brève description
    Security over cash deposits.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc UK Bank PLC
    Transactions
    • 10 mars 2023Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 03 avr. 2020
    Livré le 16 avr. 2020
    Totalement satisfaite
    Brève description
    A fixed and floating charge over all assets.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc UK Bank PLC
    Transactions
    • 16 avr. 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 10 mars 2023Satisfaction d'une charge (MR04)
    Guarantee & debenture
    Créé le 16 déc. 2005
    Livré le 03 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 03 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 avr. 2017Satisfaction partielle d'une charge (MR04)
    • 15 août 2017L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    • 02 oct. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 16 déc. 2005
    Livré le 22 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Dunedin Enterprise Investment Trust PLC
    Transactions
    • 22 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 avr. 2017Satisfaction partielle d'une charge (MR04)
    • 21 août 2017L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    • 02 oct. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 05 mars 2004
    Livré le 16 mars 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 mars 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 sept. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 20 avr. 1998
    Livré le 01 mai 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 01 mai 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mars 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge
    Créé le 09 janv. 1997
    Livré le 10 janv. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the charge
    Brèves mentions
    Fixed charge over the equipment listed :- 2 x advanced designer package-locked serial no 10-10-fa-F8 1X advanced designer package -floating 10-10-fa-F9. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transactions
    • 10 janv. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 févr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 02 nov. 1993
    Livré le 10 nov. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H premises k/a mortlake clinic north worple way mortlake london. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 10 nov. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 29 oct. 1993
    Livré le 05 nov. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 05 nov. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mai 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 28 janv. 1991
    Livré le 11 févr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    59, north worple way, london borough of richmond upon thames title no ngl 314727.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 févr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 07 oct. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 01 sept. 1989
    Livré le 11 sept. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 sept. 1989Enregistrement d'une charge
    • 07 oct. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 12 janv. 1950
    Livré le 28 janv. 1950
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £1,200 & further advances
    Brèves mentions
    65, walton road, sale, chester.
    Personnes ayant droit
    • Halifax Bldg Socy
    Transactions
    • 28 janv. 1950Enregistrement d'une charge
    • 07 févr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0