HUGH STEEPER LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | HUGH STEEPER LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Active |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00173865 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe HUGH STEEPER LIMITED ?
Adresse du siège social | Unit 3, Stourton Link Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de HUGH STEEPER LIMITED ?
En retard | Non |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 30 sept. 2024 |
Date d'échéance des prochains comptes | 30 juin 2025 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2023 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour HUGH STEEPER LIMITED ?
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 12 juin 2025 |
---|---|
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 26 juin 2025 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 12 juin 2024 |
En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour HUGH STEEPER LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cessation de la nomination de Jonathan Mark Murfin en tant que directeur le 05 nov. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Carl Chatfield en tant que directeur le 05 nov. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||||||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2023 | 30 pages | AA | ||||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 12 juin 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||||||
Période comptable précédente raccourcie du 28 févr. 2024 au 30 sept. 2023 | 1 pages | AA01 | ||||||||||||||||||
Comptes annuels établis au 28 févr. 2023 | 28 pages | AA | ||||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 12 juin 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||||||
Statuts | 9 pages | MA | ||||||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Satisfaction de la charge 001738650011 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||||||||||
Inscription de la charge 001738650012, créée le 09 mars 2023 | 13 pages | MR01 | ||||||||||||||||||
Nomination de Mr Jean-Pierre Michel Paul Mahe en tant qu'administrateur le 08 mars 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||||||
Cessation de Paul Martin Steeper en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 08 mars 2023 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||||||||||
Cessation de John Antony Midgley en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 08 mars 2023 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||||||||||
Statuts | 10 pages | MA | ||||||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Comptes annuels établis au 28 févr. 2022 | 27 pages | AA | ||||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 12 juin 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Paul Drake en tant que directeur le 21 févr. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||||||
Comptes annuels établis au 28 févr. 2021 | 28 pages | AA | ||||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 12 juin 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||||||
Nomination de Mr Andrew Nicol en tant qu'administrateur le 01 mars 2021 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||||||
Nomination de Mr Paul Drake en tant qu'administrateur le 01 mars 2021 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||||||
Nomination de Mr Ian Stuart Rodger en tant qu'administrateur le 01 mars 2021 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||||||
Nomination de Mr Jonathan Mark Murfin en tant qu'administrateur le 01 mars 2021 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de HUGH STEEPER LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARVEY-KITCHING, Emma Claire | Secrétaire | Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds Unit 3, Stourton Link England | 250527450001 | |||||||
HARVEY-KITCHING, Emma Claire | Administrateur | Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds Unit 3, Stourton Link England | England | British | Director | 279714040001 | ||||
MAHE, Jean-Pierre Michel Paul | Administrateur | Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds Unit 3, Stourton Link England | France | French | Chairman And Ceo | 305810950001 | ||||
MIDGLEY, John Antony | Administrateur | Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds Unit 3, Stourton Link England | United Kingdom | British | Director | 45716360003 | ||||
NICOL, Andrew | Administrateur | Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds Unit 3, Stourton Link England | England | British | Director | 280271140001 | ||||
RODGER, Ian Stuart | Administrateur | Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds Unit 3, Stourton Link England | England | British | Director | 280266610001 | ||||
STEEPER, Paul Martin | Administrateur | Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds Unit 3, Stourton Link England | England | British | Director | 183358890001 | ||||
ALI, Sheikh Ghulam | Secrétaire | 11 Cleveland Gardens KT4 7JJ Worcester Park Surrey | British | 12441120002 | ||||||
CROSS, Richard Alexander | Secrétaire | The Old School House Church Hill, Charing Heath TN27 0BU Ashford Kent | British | Company Director | 178817310001 | |||||
CROSS, Richard Alexander | Secrétaire | The Old School House Church Hill, Charing Heath TN27 0BU Ashford Kent | British | Company Director | 178817310001 | |||||
MIDGLEY, John Antony | Secrétaire | Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds Unit 3, Stourton Link England | British | Director | 45716360002 | |||||
O'CALLAGHAN, Perry Charles | Secrétaire | 9 Court Lodge Cottages Lower Road East Farleigh ME15 0JL Maidstone Kent | British | Accountant | 30363240003 | |||||
ORAM, Stephen Marcus | Secrétaire | Shernold House 1a Paynes Lane ME15 9QT Maidstone Kent | British | Accountant | 57274140002 | |||||
HBJGW SECRETARIAL SUPPORT LIMITED | Secrétaire | One Eleven Edmund Street B3 2HJ Birmingham West Midlands | 93128710002 | |||||||
BERTHINUSSEN, Angus Park | Administrateur | Parkview 34 Dewartown EH23 4NX Gorebridge Midlothian | Scotland | British | Prosthetics Director | 30945100003 | ||||
CHATFIELD, Carl | Administrateur | Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds Unit 3, Stourton Link England | England | British | Director | 251551570001 | ||||
CROSS, Richard Alexander | Administrateur | The Old School House Church Hill, Charing Heath TN27 0BU Ashford Kent | Uk | British | Company Director | 178817310001 | ||||
CROSS, Richard Alexander | Administrateur | The Old School House Church Hill, Charing Heath TN27 0BU Ashford Kent | Uk | British | Company Director | 178817310001 | ||||
DAVIES, Mark Leslie | Administrateur | Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds Unit 3, Stourton Link England | England | British | Director | 251551630001 | ||||
DAVIES, Mark | Administrateur | 17 Heyford Grove B91 3XX Solihull West Midlands | British | Orthotist | 49400350003 | |||||
DRAKE, Paul | Administrateur | Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds Unit 3, Stourton Link England | England | British | Director | 280267120001 | ||||
FAIRCLOUGH, James | Administrateur | The Salt Box Lower Road KT22 9H Fetcham Surrey | United Kingdom | British | Solicitor | 122061390001 | ||||
HODGSON, Giles Charles | Administrateur | Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds Unit 3, Stourton Link England | England | British | Director | 230051830001 | ||||
HOLLAMBY, John | Administrateur | Melborne House 124a Borden Lane ME9 8HR Sittingbourne Kent | British | Prosthetist | 11350680003 | |||||
JOYCE, Shaun William | Administrateur | c/o Rsl Steeper Hunslet Trading Estate Severn Road LS10 1BL Leeds Unit 7 United Kingdom | England | British | Director | 133825540001 | ||||
KNIGHT, David | Administrateur | 99 Elmstead Gardens KT4 7BG Worcester Park Surrey | British | Director | 12441150001 | |||||
MILLER, Alasdair James | Administrateur | 22 Beauly Crescent Newton Mearns G77 5UQ Glasgow | United Kingdom | British | Director | 200739750001 | ||||
MILLS, Trevor James | Administrateur | Elm Tree House The Green Dunsfold GU8 4LZ Godalming Surrey | British | Financial Director | 33843850001 | |||||
MURFIN, Jonathan Mark | Administrateur | Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds Unit 3, Stourton Link England | England | British | Director | 280266420001 | ||||
O'CALLAGHAN, Perry Charles | Administrateur | 9 Court Lodge Cottages Lower Road East Farleigh ME15 0JL Maidstone Kent | British | Accountant | 30363240003 | |||||
ORAM, Stephen Marcus | Administrateur | Shernold House 1a Paynes Lane ME15 9QT Maidstone Kent | England | British | Accountant | 57274140002 | ||||
RANDERSON, Mark Andrew | Administrateur | c/o Rsl Steeper Hunslet Trading Estate Severn Road LS10 1BL Leeds Unit 7 United Kingdom | England | British | Director | 178061350001 | ||||
SHEARD, Gary, Dr | Administrateur | Riverside 2 Medway City Estate ME2 4DP Rochester 51 Kent United Kingdom | England | British | Director | 118863590001 | ||||
STEEPER, Kenneth Oscar | Administrateur | Morland 14 Cheyham Way Cheam SM2 7HX Sutton Surrey | British | Director | 12441130001 | |||||
STEEPER, Paul Martin | Administrateur | 361 Reigate Road Epsom Downs KT17 3LU Epsom Surrey | British | Sales Director | 32025980001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HUGH STEEPER LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr John Antony Midgley | 06 avr. 2016 | Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds Unit 3, Stourton Link England | Oui | ||||||||||
Nationalité: British Pays de résidence: United Kingdom | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Mr Paul Martin Steeper | 06 avr. 2016 | Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds Unit 3, Stourton Link England | Oui | ||||||||||
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Meditech Group Limited | 06 avr. 2016 | Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds Unit 3 Stourton Link England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
HUGH STEEPER LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 09 mars 2023 Livré le 10 mars 2023 | En cours | ||
Brève description Security over cash deposits. Contient une promesse négative: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 03 avr. 2020 Livré le 16 avr. 2020 | Totalement satisfaite | ||
Brève description A fixed and floating charge over all assets. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee & debenture | Créé le 16 déc. 2005 Livré le 03 janv. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to the secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 16 déc. 2005 Livré le 22 déc. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 05 mars 2004 Livré le 16 mars 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 20 avr. 1998 Livré le 01 mai 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Fixed charge | Créé le 09 janv. 1997 Livré le 10 janv. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the charge | |
Brèves mentions Fixed charge over the equipment listed :- 2 x advanced designer package-locked serial no 10-10-fa-F8 1X advanced designer package -floating 10-10-fa-F9. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 02 nov. 1993 Livré le 10 nov. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H premises k/a mortlake clinic north worple way mortlake london. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Fixed and floating charge | Créé le 29 oct. 1993 Livré le 05 nov. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 28 janv. 1991 Livré le 11 févr. 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 59, north worple way, london borough of richmond upon thames title no ngl 314727. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 01 sept. 1989 Livré le 11 sept. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage | Créé le 12 janv. 1950 Livré le 28 janv. 1950 | Totalement satisfaite | Montant garanti £1,200 & further advances | |
Brèves mentions 65, walton road, sale, chester. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0