HUGH STEEPER LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | HUGH STEEPER LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Active |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00173865 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Non |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe HUGH STEEPER LIMITED ?
Adresse du siège social | Unit 3, Stourton Link Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de HUGH STEEPER LIMITED ?
En retard | Non |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 30 sept. 2025 |
Date d'échéance des prochains comptes | 30 juin 2026 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour HUGH STEEPER LIMITED ?
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 12 juin 2026 |
---|---|
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 26 juin 2026 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 12 juin 2025 |
En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour HUGH STEEPER LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comptes annuels établis au 30 sept. 2024 | 30 pages | AA | ||||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 12 juin 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Jonathan Mark Murfin en tant que directeur le 05 nov. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Carl Chatfield en tant que directeur le 05 nov. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||||||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2023 | 30 pages | AA | ||||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 12 juin 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||||||
Période comptable précédente raccourcie du 28 févr. 2024 au 30 sept. 2023 | 1 pages | AA01 | ||||||||||||||||||
Comptes annuels établis au 28 févr. 2023 | 28 pages | AA | ||||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 12 juin 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||||||
Statuts | 9 pages | MA | ||||||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Satisfaction de la charge 001738650011 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||||||||||
Inscription de la charge 001738650012, créée le 09 mars 2023 | 13 pages | MR01 | ||||||||||||||||||
Nomination de Mr Jean-Pierre Michel Paul Mahe en tant qu'administrateur le 08 mars 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||||||
Cessation de Paul Martin Steeper en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 08 mars 2023 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||||||||||
Cessation de John Antony Midgley en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 08 mars 2023 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||||||||||
Statuts | 10 pages | MA | ||||||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Comptes annuels établis au 28 févr. 2022 | 27 pages | AA | ||||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 12 juin 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Paul Drake en tant que directeur le 21 févr. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||||||
Comptes annuels établis au 28 févr. 2021 | 28 pages | AA | ||||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 12 juin 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||||||
Nomination de Mr Andrew Nicol en tant qu'administrateur le 01 mars 2021 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||||||
Nomination de Mr Paul Drake en tant qu'administrateur le 01 mars 2021 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de HUGH STEEPER LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARVEY-KITCHING, Emma Claire | Secrétaire | Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds Unit 3, Stourton Link England | 250527450001 | |||||||
HARVEY-KITCHING, Emma Claire | Administrateur | Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds Unit 3, Stourton Link England | England | British | Director | 279714040001 | ||||
MAHE, Jean-Pierre Michel Paul | Administrateur | Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds Unit 3, Stourton Link England | France | French | Chairman And Ceo | 305810950001 | ||||
MIDGLEY, John Antony | Administrateur | Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds Unit 3, Stourton Link England | United Kingdom | British | Director | 45716360003 | ||||
NICOL, Andrew | Administrateur | Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds Unit 3, Stourton Link England | England | British | Director | 280271140001 | ||||
RODGER, Ian Stuart | Administrateur | Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds Unit 3, Stourton Link England | England | British | Director | 280266610001 | ||||
STEEPER, Paul Martin | Administrateur | Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds Unit 3, Stourton Link England | England | British | Director | 183358890001 | ||||
ALI, Sheikh Ghulam | Secrétaire | 11 Cleveland Gardens KT4 7JJ Worcester Park Surrey | British | 12441120002 | ||||||
CROSS, Richard Alexander | Secrétaire | The Old School House Church Hill, Charing Heath TN27 0BU Ashford Kent | British | Company Director | 178817310001 | |||||
CROSS, Richard Alexander | Secrétaire | The Old School House Church Hill, Charing Heath TN27 0BU Ashford Kent | British | Company Director | 178817310001 | |||||
MIDGLEY, John Antony | Secrétaire | Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds Unit 3, Stourton Link England | British | Director | 45716360002 | |||||
O'CALLAGHAN, Perry Charles | Secrétaire | 9 Court Lodge Cottages Lower Road East Farleigh ME15 0JL Maidstone Kent | British | Accountant | 30363240003 | |||||
ORAM, Stephen Marcus | Secrétaire | Shernold House 1a Paynes Lane ME15 9QT Maidstone Kent | British | Accountant | 57274140002 | |||||
HBJGW SECRETARIAL SUPPORT LIMITED | Secrétaire | One Eleven Edmund Street B3 2HJ Birmingham West Midlands | 93128710002 | |||||||
BERTHINUSSEN, Angus Park | Administrateur | Parkview 34 Dewartown EH23 4NX Gorebridge Midlothian | Scotland | British | Prosthetics Director | 30945100003 | ||||
CHATFIELD, Carl | Administrateur | Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds Unit 3, Stourton Link England | England | British | Director | 251551570001 | ||||
CROSS, Richard Alexander | Administrateur | The Old School House Church Hill, Charing Heath TN27 0BU Ashford Kent | Uk | British | Company Director | 178817310001 | ||||
CROSS, Richard Alexander | Administrateur | The Old School House Church Hill, Charing Heath TN27 0BU Ashford Kent | Uk | British | Company Director | 178817310001 | ||||
DAVIES, Mark Leslie | Administrateur | Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds Unit 3, Stourton Link England | England | British | Director | 251551630001 | ||||
DAVIES, Mark | Administrateur | 17 Heyford Grove B91 3XX Solihull West Midlands | British | Orthotist | 49400350003 | |||||
DRAKE, Paul | Administrateur | Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds Unit 3, Stourton Link England | England | British | Director | 280267120001 | ||||
FAIRCLOUGH, James | Administrateur | The Salt Box Lower Road KT22 9H Fetcham Surrey | United Kingdom | British | Solicitor | 122061390001 | ||||
HODGSON, Giles Charles | Administrateur | Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds Unit 3, Stourton Link England | England | British | Director | 230051830001 | ||||
HOLLAMBY, John | Administrateur | Melborne House 124a Borden Lane ME9 8HR Sittingbourne Kent | British | Prosthetist | 11350680003 | |||||
JOYCE, Shaun William | Administrateur | c/o Rsl Steeper Hunslet Trading Estate Severn Road LS10 1BL Leeds Unit 7 United Kingdom | England | British | Director | 133825540001 | ||||
KNIGHT, David | Administrateur | 99 Elmstead Gardens KT4 7BG Worcester Park Surrey | British | Director | 12441150001 | |||||
MILLER, Alasdair James | Administrateur | 22 Beauly Crescent Newton Mearns G77 5UQ Glasgow | United Kingdom | British | Director | 200739750001 | ||||
MILLS, Trevor James | Administrateur | Elm Tree House The Green Dunsfold GU8 4LZ Godalming Surrey | British | Financial Director | 33843850001 | |||||
MURFIN, Jonathan Mark | Administrateur | Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds Unit 3, Stourton Link England | England | British | Director | 280266420001 | ||||
O'CALLAGHAN, Perry Charles | Administrateur | 9 Court Lodge Cottages Lower Road East Farleigh ME15 0JL Maidstone Kent | England | British | Accountant | 30363240003 | ||||
ORAM, Stephen Marcus | Administrateur | Shernold House 1a Paynes Lane ME15 9QT Maidstone Kent | England | British | Accountant | 57274140002 | ||||
RANDERSON, Mark Andrew | Administrateur | c/o Rsl Steeper Hunslet Trading Estate Severn Road LS10 1BL Leeds Unit 7 United Kingdom | England | British | Director | 178061350001 | ||||
SHEARD, Gary, Dr | Administrateur | Riverside 2 Medway City Estate ME2 4DP Rochester 51 Kent United Kingdom | England | British | Director | 118863590001 | ||||
STEEPER, Kenneth Oscar | Administrateur | Morland 14 Cheyham Way Cheam SM2 7HX Sutton Surrey | British | Director | 12441130001 | |||||
STEEPER, Paul Martin | Administrateur | 361 Reigate Road Epsom Downs KT17 3LU Epsom Surrey | British | Sales Director | 32025980001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HUGH STEEPER LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr John Antony Midgley | 06 avr. 2016 | Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds Unit 3, Stourton Link England | Oui | ||||||||||
Nationalité: British Pays de résidence: United Kingdom | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Mr Paul Martin Steeper | 06 avr. 2016 | Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds Unit 3, Stourton Link England | Oui | ||||||||||
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Meditech Group Limited | 06 avr. 2016 | Intermezzo Drive LS10 1DF Leeds Unit 3 Stourton Link England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0