CSONCO LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCSONCO LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00174828
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CSONCO LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe CSONCO LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Loudwater Mill
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Buckinghamshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CSONCO LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CLARE SON AND COMPANY LIMITED23 mai 192123 mai 1921

    Quels sont les derniers comptes de CSONCO LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au25 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour CSONCO LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 15 mai 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    État du capital au 28 mars 2017

    • Capital: GBP 1
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes pour une société dormante établis au 25 déc. 2016

    4 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 27 déc. 2015

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 avr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 mai 2016

    État du capital au 19 mai 2016

    • Capital: GBP 58,825
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Paul Anthony Hunter le 26 nov. 2015

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 28 déc. 2014

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 mai 2015

    État du capital au 15 mai 2015

    • Capital: GBP 58,825
    SH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Neil Edward Carpenter le 13 janv. 2015

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées du secrétaire Simon Alton Westrop le 13 janv. 2015

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Henry Kennedy Faure Walker le 13 janv. 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Paul Anthony Hunter le 13 janv. 2015

    2 pagesCH01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré 9Th and 10Th Floors Quadrant House Sutton Surrey SM2 5AS

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 9Th and 10Th Floors Quadrant House Sutton Surrey SM2 5AS

    1 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de 58 Church Street Weybridge Surrey KT13 8DP à Loudwater Mill Station Road High Wycombe Buckinghamshire HP10 9TY le 11 déc. 2014

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Paul Davidson en tant que directeur le 11 nov. 2014

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 avr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 mai 2014

    État du capital au 07 mai 2014

    • Capital: GBP 58,825
    SH01

    Nomination de Henry Kennedy Faure Walker en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 29 déc. 2013

    6 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de CSONCO LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CARPENTER, Neil Edward
    Quadrant House
    The Quadrant
    SM2 5AS Sutton
    9th And 10th Floors
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Quadrant House
    The Quadrant
    SM2 5AS Sutton
    9th And 10th Floors
    Surrey
    United Kingdom
    British90209080001
    WESTROP, Simon Alton
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    British109662340001
    FAURE WALKER, Henry Kennedy
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director187012370001
    HUNTER, Paul Anthony
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandEnglishFinance Director69320190004
    BLACKNELL, David
    62 Kenwood Drive
    BR3 6QY Beckenham
    Kent
    Secrétaire
    62 Kenwood Drive
    BR3 6QY Beckenham
    Kent
    British7332320001
    BRESNARK, Lawrence
    50 Brockley Avenue
    HA7 4LT Stanmore
    Middlesex
    Secrétaire
    50 Brockley Avenue
    HA7 4LT Stanmore
    Middlesex
    BritishChartered Accountant1942970001
    GLASS, Josephine Mary
    Cairn Cottage Woodham Park Way
    Woodham
    KT15 3SD Addlestone
    Surrey
    Secrétaire
    Cairn Cottage Woodham Park Way
    Woodham
    KT15 3SD Addlestone
    Surrey
    BritishFinancial Controller44504060001
    HUNTER, Paul Anthony
    15 Downs Way
    KT18 5LU Epsom
    Surrey
    Secrétaire
    15 Downs Way
    KT18 5LU Epsom
    Surrey
    British69320190002
    TOWNSEND, John Arthur
    36 Guithavon Road
    CM8 1HD Witham
    Essex
    Secrétaire
    36 Guithavon Road
    CM8 1HD Witham
    Essex
    British7332310001
    AIKEN, Iain William
    Pendle View, Primrose Hill
    BB2 7EQ Mellor
    Lancashire
    Administrateur
    Pendle View, Primrose Hill
    BB2 7EQ Mellor
    Lancashire
    BritishNewspaper Publisher83849650001
    BLACKNELL, David
    62 Kenwood Drive
    BR3 6QY Beckenham
    Kent
    Administrateur
    62 Kenwood Drive
    BR3 6QY Beckenham
    Kent
    BritishCompany Secretary7332320001
    BRESNARK, Lawrence
    50 Brockley Avenue
    HA7 4LT Stanmore
    Middlesex
    Administrateur
    50 Brockley Avenue
    HA7 4LT Stanmore
    Middlesex
    BritishChartered Accountant1942970001
    BROWN, James Thomson
    Eyhurst Hall 8 Manor House
    Eyhurst Park Outwood Lane
    KT20 6JP Kingswood
    Surrey
    Administrateur
    Eyhurst Hall 8 Manor House
    Eyhurst Park Outwood Lane
    KT20 6JP Kingswood
    Surrey
    BritishNewspaper Chief Executive4154210013
    CHRISTIE, David Gordon
    53 The Mount
    Fetcham
    KT22 9EG Leatherhead
    Surrey
    Administrateur
    53 The Mount
    Fetcham
    KT22 9EG Leatherhead
    Surrey
    BritishNewspaper Publisher75461250001
    DAVIDSON, Paul
    Church Street
    KT13 8DP Weybridge
    58
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Church Street
    KT13 8DP Weybridge
    58
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishNewspaper Publisher46356560004
    GRAHAM, John Stuart
    10 Hatley Close
    Friern Barnet
    N11 3LN London
    Administrateur
    10 Hatley Close
    Friern Barnet
    N11 3LN London
    BritishChartered Accountant72224100001
    PFEIL, John Christopher
    148 High Street
    ME19 6NE West Malling
    Kent
    Administrateur
    148 High Street
    ME19 6NE West Malling
    Kent
    EnglandBritishFinance Director93412530001
    RADBURN, Philip Arthur
    Pyebirch Manor
    Eccleshall
    ST21 6JG Stafford
    Staffordshire
    Administrateur
    Pyebirch Manor
    Eccleshall
    ST21 6JG Stafford
    Staffordshire
    United KingdomBritishNewspaper Publisher46357310001
    SKINNER, Peter John
    22 Beresford Gardens
    SS7 2SA Hadleigh
    Essex
    Administrateur
    22 Beresford Gardens
    SS7 2SA Hadleigh
    Essex
    BritishChartered Accountant7332340001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CSONCO LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Station Road
    Loudwater
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    England
    06 avr. 2016
    Station Road
    Loudwater
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement01676637
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    CSONCO LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 01 juin 1989
    Livré le 10 juin 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (See form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 10 juin 1989Enregistrement d'une charge
    • 29 nov. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 29 janv. 1987
    Livré le 06 févr. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 06 févr. 1987Enregistrement d'une charge
    Mortgage debenture
    Créé le 30 déc. 1986
    Livré le 20 janv. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 janv. 1987Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 05 déc. 1985
    Livré le 11 déc. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a southover wells somerset and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 11 déc. 1985Enregistrement d'une charge
    Charge over book debts
    Créé le 14 mars 1985
    Livré le 22 mars 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific charge over the benefit of all book debts and other debts.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 22 mars 1985Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 05 mai 1981
    Livré le 12 mai 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H southover wills somerset. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 12 mai 1981Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 30 avr. 1981
    Livré le 13 mai 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 13 mai 1981Enregistrement d'une charge
    Supplemental deed
    Créé le 02 mars 1981
    Livré le 16 mars 1981
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £13,000,000 under the terms of a deed dated 18/12/67 & deeds supplemental thereto
    Brèves mentions
    Floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 16 mars 1981Enregistrement d'une charge
    Supplemental deed
    Créé le 26 févr. 1981
    Livré le 10 mars 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from bpc limited under the terms of the charge.
    Brèves mentions
    Floating charge over the company's assets present & future as charged by a principal deed dated 18/12/67 (see doc M151).
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 10 mars 1981Enregistrement d'une charge
    Deed of guarantee & charge
    Créé le 18 déc. 1967
    Livré le 01 janv. 1968
    En cours
    Montant garanti
    All monies due to chargees from british printing corps LTD.
    Brèves mentions
    Floating charge over. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • National Provincial Bank
    • Westminster Bank LTD
    • British Bank
    Transactions
    • 01 janv. 1968Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0