CSONCO LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | CSONCO LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00174828 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CSONCO LIMITED ?
Adresse du siège social | Loudwater Mill Station Road HP10 9TY High Wycombe Buckinghamshire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CSONCO LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 25 déc. 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour CSONCO LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 mai 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
État du capital au 28 mars 2017
| 5 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 25 déc. 2016 | 4 pages | AA | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 27 déc. 2015 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 19 avr. 2016 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Paul Anthony Hunter le 26 nov. 2015 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 28 déc. 2014 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 15 mai 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mr Neil Edward Carpenter le 13 janv. 2015 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Simon Alton Westrop le 13 janv. 2015 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Henry Kennedy Faure Walker le 13 janv. 2015 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Paul Anthony Hunter le 13 janv. 2015 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré 9Th and 10Th Floors Quadrant House Sutton Surrey SM2 5AS | 1 pages | AD03 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 9Th and 10Th Floors Quadrant House Sutton Surrey SM2 5AS | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 58 Church Street Weybridge Surrey KT13 8DP à Loudwater Mill Station Road High Wycombe Buckinghamshire HP10 9TY le 11 déc. 2014 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Paul Davidson en tant que directeur le 11 nov. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 19 avr. 2014 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Henry Kennedy Faure Walker en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 29 déc. 2013 | 6 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de CSONCO LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARPENTER, Neil Edward | Secrétaire | Quadrant House The Quadrant SM2 5AS Sutton 9th And 10th Floors Surrey United Kingdom | British | 90209080001 | ||||||
WESTROP, Simon Alton | Secrétaire | Station Road HP10 9TY High Wycombe Loudwater Mill Buckinghamshire United Kingdom | British | 109662340001 | ||||||
FAURE WALKER, Henry Kennedy | Administrateur | Station Road HP10 9TY High Wycombe Loudwater Mill Buckinghamshire United Kingdom | England | British | Company Director | 187012370001 | ||||
HUNTER, Paul Anthony | Administrateur | Station Road HP10 9TY High Wycombe Loudwater Mill Buckinghamshire United Kingdom | England | English | Finance Director | 69320190004 | ||||
BLACKNELL, David | Secrétaire | 62 Kenwood Drive BR3 6QY Beckenham Kent | British | 7332320001 | ||||||
BRESNARK, Lawrence | Secrétaire | 50 Brockley Avenue HA7 4LT Stanmore Middlesex | British | Chartered Accountant | 1942970001 | |||||
GLASS, Josephine Mary | Secrétaire | Cairn Cottage Woodham Park Way Woodham KT15 3SD Addlestone Surrey | British | Financial Controller | 44504060001 | |||||
HUNTER, Paul Anthony | Secrétaire | 15 Downs Way KT18 5LU Epsom Surrey | British | 69320190002 | ||||||
TOWNSEND, John Arthur | Secrétaire | 36 Guithavon Road CM8 1HD Witham Essex | British | 7332310001 | ||||||
AIKEN, Iain William | Administrateur | Pendle View, Primrose Hill BB2 7EQ Mellor Lancashire | British | Newspaper Publisher | 83849650001 | |||||
BLACKNELL, David | Administrateur | 62 Kenwood Drive BR3 6QY Beckenham Kent | British | Company Secretary | 7332320001 | |||||
BRESNARK, Lawrence | Administrateur | 50 Brockley Avenue HA7 4LT Stanmore Middlesex | British | Chartered Accountant | 1942970001 | |||||
BROWN, James Thomson | Administrateur | Eyhurst Hall 8 Manor House Eyhurst Park Outwood Lane KT20 6JP Kingswood Surrey | British | Newspaper Chief Executive | 4154210013 | |||||
CHRISTIE, David Gordon | Administrateur | 53 The Mount Fetcham KT22 9EG Leatherhead Surrey | British | Newspaper Publisher | 75461250001 | |||||
DAVIDSON, Paul | Administrateur | Church Street KT13 8DP Weybridge 58 Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | Newspaper Publisher | 46356560004 | ||||
GRAHAM, John Stuart | Administrateur | 10 Hatley Close Friern Barnet N11 3LN London | British | Chartered Accountant | 72224100001 | |||||
PFEIL, John Christopher | Administrateur | 148 High Street ME19 6NE West Malling Kent | England | British | Finance Director | 93412530001 | ||||
RADBURN, Philip Arthur | Administrateur | Pyebirch Manor Eccleshall ST21 6JG Stafford Staffordshire | United Kingdom | British | Newspaper Publisher | 46357310001 | ||||
SKINNER, Peter John | Administrateur | 22 Beresford Gardens SS7 2SA Hadleigh Essex | British | Chartered Accountant | 7332340001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CSONCO LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newsquest Media Group Limited | 06 avr. 2016 | Station Road Loudwater HP10 9TY High Wycombe Loudwater Mill England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
CSONCO LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 01 juin 1989 Livré le 10 juin 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions (See form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture | Créé le 29 janv. 1987 Livré le 06 févr. 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture | Créé le 30 déc. 1986 Livré le 20 janv. 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 05 déc. 1985 Livré le 11 déc. 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H property k/a southover wells somerset and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge over book debts | Créé le 14 mars 1985 Livré le 22 mars 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific charge over the benefit of all book debts and other debts. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 05 mai 1981 Livré le 12 mai 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H southover wills somerset. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 30 avr. 1981 Livré le 13 mai 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Supplemental deed | Créé le 02 mars 1981 Livré le 16 mars 1981 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £13,000,000 under the terms of a deed dated 18/12/67 & deeds supplemental thereto | |
Brèves mentions Floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Supplemental deed | Créé le 26 févr. 1981 Livré le 10 mars 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from bpc limited under the terms of the charge. | |
Brèves mentions Floating charge over the company's assets present & future as charged by a principal deed dated 18/12/67 (see doc M151). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of guarantee & charge | Créé le 18 déc. 1967 Livré le 01 janv. 1968 | En cours | Montant garanti All monies due to chargees from british printing corps LTD. | |
Brèves mentions Floating charge over. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0