CASPIAN UK HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCASPIAN UK HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00182180
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CASPIAN UK HOLDINGS LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe CASPIAN UK HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Cedars
    2 High Street
    GU19 5AE Bagshot
    Surrey
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CASPIAN UK HOLDINGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    GOWRINGS LIMITED23 mars 200523 mars 2005
    GOWRINGS PLC09 juin 198909 juin 1989
    GOWRING'S LIMITED31 mai 192231 mai 1922

    Quels sont les derniers comptes de CASPIAN UK HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour CASPIAN UK HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2021

    8 pagesAA

    État du capital au 14 avr. 2022

    • Capital: GBP 0.10
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Cancel capuital redemption reserve and share prem ac/ 13/04/2022
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2020

    10 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 18 juin 2021 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 18 juin 2020 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2019

    9 pagesAA

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2018

    9 pagesAA

    Cessation de la nomination de Jan Mohammad Nader Zadeh en tant que directeur le 29 août 2019

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 18 juin 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Nomination de Mrs Yvonne Davey en tant que secrétaire le 31 mai 2019

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Michael James Gray en tant que secrétaire le 31 mai 2019

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Michael James Gray en tant que directeur le 31 mai 2019

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    18 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 18 juin 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 19 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 17 en totalité

    4 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 01 janv. 2017

    14 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 18 juin 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 03 janv. 2016

    14 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de CASPIAN UK HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DAVEY, Yvonne
    GU19 5AE Bagshot
    The Cedars, 2 High Street
    Surrey
    England
    Secrétaire
    GU19 5AE Bagshot
    The Cedars, 2 High Street
    Surrey
    England
    259041230001
    NADER-ZADEH, Taji
    The Cedars
    2 High Street
    GU19 5AE Bagshot
    Surrey
    Administrateur
    The Cedars
    2 High Street
    GU19 5AE Bagshot
    Surrey
    EnglandBritish35056010004
    CHADWICK, Clive Frederick
    75 Gorselands
    Wash Common
    RG14 6PU Newbury
    Berkshire
    Secrétaire
    75 Gorselands
    Wash Common
    RG14 6PU Newbury
    Berkshire
    British107091790001
    FOALE, Stephen John
    42 Holmbury Avenue
    RG45 6TQ Crowthorne
    Berkshire
    Secrétaire
    42 Holmbury Avenue
    RG45 6TQ Crowthorne
    Berkshire
    British37403500001
    GRAY, David Henry
    Whisper Wood House Whisper Wood
    Loudwater
    WD3 4JU Hertfordshire
    Secrétaire
    Whisper Wood House Whisper Wood
    Loudwater
    WD3 4JU Hertfordshire
    British6369250003
    GRAY, Michael James
    The Cedars
    2 High Street
    GU19 5AE Bagshot
    Surrey
    Secrétaire
    The Cedars
    2 High Street
    GU19 5AE Bagshot
    Surrey
    British55978100001
    SMITH, Graham Charles
    Lawndale
    8 Hillfield Road
    SL9 0DX Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Lawndale
    8 Hillfield Road
    SL9 0DX Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British37978250001
    COULSON, Derek William
    Fox Lea Hermitage Road
    Cold Ash
    RG18 9JH Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Fox Lea Hermitage Road
    Cold Ash
    RG18 9JH Newbury
    Berkshire
    EnglandBritish30237250002
    FOALE, Stephen John
    42 Holmbury Avenue
    RG45 6TQ Crowthorne
    Berkshire
    Administrateur
    42 Holmbury Avenue
    RG45 6TQ Crowthorne
    Berkshire
    EnglandBritish37403500001
    FOWLES, John
    Burghclere Manor
    Old Burghclere
    RG20 9NS Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Burghclere Manor
    Old Burghclere
    RG20 9NS Newbury
    Berkshire
    British12870040001
    GOOD, Anthony Bruton Meyrick
    Clench House
    Wootton Rivers
    SN8 4NT Marlborough
    Wilts
    Administrateur
    Clench House
    Wootton Rivers
    SN8 4NT Marlborough
    Wilts
    United KingdomBritish39536400006
    GRAY, David Henry
    Whisper Wood House Whisper Wood
    Loudwater
    WD3 4JU Hertfordshire
    Administrateur
    Whisper Wood House Whisper Wood
    Loudwater
    WD3 4JU Hertfordshire
    British6369250003
    GRAY, Michael James
    The Cedars
    2 High Street
    GU19 5AE Bagshot
    Surrey
    Administrateur
    The Cedars
    2 High Street
    GU19 5AE Bagshot
    Surrey
    EnglandBritish55978100001
    KENDALL, David William
    41 Albion Street
    W2 2AU London
    Administrateur
    41 Albion Street
    W2 2AU London
    United KingdomBritish9207490001
    NADER ZADEH, Jan Mohammad
    The Cedars
    2 High Street
    GU19 5AE Bagshot
    Surrey
    Administrateur
    The Cedars
    2 High Street
    GU19 5AE Bagshot
    Surrey
    EnglandBritish102645370001
    OLDLAND, Michael John
    Dolmans Barn
    Hankerton
    SN16 9LH Malmesbury
    Wiltshire
    Administrateur
    Dolmans Barn
    Hankerton
    SN16 9LH Malmesbury
    Wiltshire
    British12870050002
    THOMAS, Vivian
    Camelot
    Bennett Way
    GU4 7TN West Clandon
    Surrey
    Administrateur
    Camelot
    Bennett Way
    GU4 7TN West Clandon
    Surrey
    EnglandBritish102093310001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CASPIAN UK HOLDINGS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Caspian Uk Group Limited
    2 High Street
    GU19 5AE Bagshot
    The Cedars
    Surrey
    England
    06 avr. 2016
    2 High Street
    GU19 5AE Bagshot
    The Cedars
    Surrey
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland
    Numéro d'enregistrement2810190
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    CASPIAN UK HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 24 mars 2005
    Livré le 30 mars 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 30 mars 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 nov. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 17 févr. 2005
    Livré le 19 févr. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Land and building at 1 wellington avenue aldershot hampshire title no HP652649.
    Personnes ayant droit
    • The Secretary of State for Defence
    Transactions
    • 19 févr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 12 mars 2004
    Livré le 20 mars 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 mars 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 nov. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 30 déc. 1988
    Livré le 07 janv. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Sterling pounds 30,750 and all monies due or to become due from the company to the chargee and all moneys due for goods and services supplied
    Brèves mentions
    All that f/h property k/a gowrings leisure centre at hte willows caravan park maidenhead berkshire.
    Personnes ayant droit
    • Whitebread & Company PLC
    Transactions
    • 07 janv. 1989Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 30 déc. 1988
    Livré le 07 janv. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a or being the willows caravan park, maidenhead road, bray, berkshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 07 janv. 1989Enregistrement d'une charge
    • 27 mai 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 16 déc. 1988
    Livré le 19 déc. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a kings copse caravan park garsington oxford tn ON45651 (please refer to form M395). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 19 déc. 1988Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 15 avr. 1987
    Livré le 21 avr. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or cowrings food services limited to the chargee on any account whatsover
    Brèves mentions
    L/H porperty l/a trafalgar house wellington avenue ardershot hampshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 avr. 1987Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 18 nov. 1985
    Livré le 27 nov. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Church gate & cco church gate a thatcham grange, thatcham berkshire t/no BK52156 a/m us proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 27 nov. 1985Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 09 déc. 1983
    Livré le 15 déc. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land, truttle green, finchampstead rd, workingham, berkshire, title no bk 30719.
    Personnes ayant droit
    • United Dominatins Trust Limited
    Transactions
    • 15 déc. 1983Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 05 mars 1982
    Livré le 08 mars 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Other lands buildings throttle green, finchampstead road, barks, title no BK30719 f/hold lands buildgs 85,87 basingstoke road reading berks title no BK183148 l/hold land & buildings unit 1 smallmead road reading, berks title no BK131326.
    Personnes ayant droit
    • Mercantile Credit Company Limited
    Transactions
    • 08 mars 1982Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 27 août 1980
    Livré le 03 sept. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land on the bank side of commercial road, reading, berkshire title no BK49008.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 03 sept. 1980Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 17 juil. 1980
    Livré le 25 juil. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold throttle green, wokingham berks title no bk 30719.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 25 juil. 1980Enregistrement d'une charge
    Mortgage debenture
    Créé le 14 sept. 1971
    Livré le 21 sept. 1971
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The stock in trade as defined in the mortgage debenture (see doc. 99).
    Personnes ayant droit
    • United Dominions Trust Limited
    Transactions
    • 21 sept. 1971Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 19 janv. 1971
    Livré le 28 janv. 1971
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Swanbridge garage, london road, newbury, berks. L/h swanbridge & brookside filling stations london road, newbury, berks.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 28 janv. 1971Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 02 déc. 1970
    Livré le 21 déc. 1970
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at 60 beaumpstoke rd, reading, berks title no br 49007.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 déc. 1970Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 02 déc. 1970
    Livré le 21 déc. 1970
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Part of 169, basingstoke rd, reading, berkshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 déc. 1970Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 18 janv. 1961
    Livré le 18 janv. 1961
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £1800 and all other monies due..etc
    Brèves mentions
    17 westernville road reading, berks.
    Personnes ayant droit
    • Co-Operative Permanent Bldg Society
    Transactions
    • 18 janv. 1961Enregistrement d'une charge
    • 20 déc. 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 26 févr. 1959
    Livré le 26 févr. 1959
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Sterling pounds 25,000
    Brèves mentions
    75 and 77 silver street reading, berks.
    Personnes ayant droit
    • B W Trade Facilities LTD
    Transactions
    • 26 févr. 1959Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 10 oct. 1949
    Livré le 28 sept. 1949
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due etc
    Brèves mentions
    Freehold:- 6,8,10 london road reading.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 28 sept. 1949Enregistrement d'une charge
    • 28 mars 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0