TOWN INVESTMENTS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | TOWN INVESTMENTS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00182305 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe TOWN INVESTMENTS LIMITED ?
Adresse du siège social | No 1 Dorset Street SO18 2DP Southampton Hampshire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de TOWN INVESTMENTS LIMITED ?
En retard | Oui |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2015 |
Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2016 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2014 |
Quels sont les derniers dépôts pour TOWN INVESTMENTS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 6 pages | 4.71 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Lloyds Chambers 1 Portsoken Street London E1 8HZ à No 1 Dorset Street Southampton Hampshire SO18 2DP le 03 juin 2016 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 3 pages | 4.70 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 2 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 19 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 19 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013 | 4 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Leonard Grose le 29 janv. 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 19 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Emily Ann Mousley le 11 janv. 2013 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 19 déc. 2012 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011 | 4 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * 4Th Floor Lloyds Chambers 1 Portsoken Street London E1 8LW* le 22 déc. 2011 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 19 déc. 2011 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 19 déc. 2010 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Leonard Grose le 20 déc. 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Graham Pierce en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2009 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 19 déc. 2009 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mepc Secretaries Limited le 16 déc. 2009 | 2 pages | CH04 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de TOWN INVESTMENTS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEPC SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Floor Lloyds Chambers 1 Portsoken Street E1 8LW London 4th United Kingdom |
| 79708020003 | ||||||||||
GROSE, David Leonard | Administrateur | Dorset Street SO18 2DP Southampton No 1 Hampshire | United Kingdom | British | Accountant | 120479020004 | ||||||||
MOUSLEY, Emily Ann | Administrateur | Dorset Street SO18 2DP Southampton No 1 Hampshire | England | British | Chartered Accountant | 155262770003 | ||||||||
LEE, John Philip Macarthur | Secrétaire | Flat 9 14 Marylebone Street W1M 7PR London | British | 32509900003 | ||||||||||
PRICE, John Dewi Brychan | Secrétaire | 12 The Rise RH16 2TA Lindfield West Sussex | British | Secretary | 3041640002 | |||||||||
BRADY, James Michael | Administrateur | 1 Cromwell Close AL4 9YE St Albans Hertfordshire | England | British | Chartered Accountant | 3769730001 | ||||||||
BURROWES, David William | Administrateur | 60 Westwater Way OX11 7TY Didcot Oxfordshire | United Kingdom | British | Director Taxation | 100504300001 | ||||||||
EAST, Stephen John | Administrateur | White Ladies Birch Hill Shirley Hills CR0 5HT Surrey | England | British | Chartered Accountant | 108586450001 | ||||||||
HARROLD, Richard Anthony | Administrateur | Hill House Farm Brandon Parva NR9 4DL Norwich Norfolk | British | Chartered Surveyor | 33048780001 | |||||||||
JOHNSON, Edward John | Administrateur | 57 Park Road Chiswick W4 3EY London | British | Chartered Surveyor | 76145820001 | |||||||||
LEWIS, Gavin Andrew | Administrateur | 38 Victoria Avenue KT6 5DW Surbiton Surrey | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 93017010003 | ||||||||
MONAGHAN, Kevin Peter | Administrateur | Pendennis High Street, Long Wittenham OX14 4QJ Abingdon Oxon | England | British | Chartered Surveyor | 116273610001 | ||||||||
MONIZ, Christopher Mario | Administrateur | 26 The Avenue CR5 2BN Coulsdon Surrey | England | British | Certified Accountant | 3831690001 | ||||||||
PIERCE, Graham Charles | Administrateur | 66 Lausanne Road SE15 2JB London | United Kingdom | Uk | Accountant | 123665160001 | ||||||||
STRATTON, Carol Ann | Administrateur | 127 Maidstone Road Ruxley Corner Foots Cray DA14 5HX Sidcup Kent | United Kingdom | British | Company Secretary | 79680570001 | ||||||||
THOMPSON, Nathan James | Administrateur | No 1 Elsynge Road Wandsworth SW18 2HW London | British | Chartered Surveyor | 43320980004 | |||||||||
TUCKEY, James Lane | Administrateur | 95 Elgin Crescent W11 2JF London | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 35019240001 | ||||||||
WATTERS, Iain Russell | Administrateur | Laurel Bank Poyle Lane SL1 8LA Burnham Slough Buckinghamshire | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 3717820002 |
TOWN INVESTMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Supplemental trust deed | Créé le 20 mars 1984 Livré le 23 mars 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti For securing £900,000 7% first mortgage debenture stock 1985/90 £1,600,000 7% first mortgage debenture stock 1985/90 and £500,000 7 3/4% first mortgage debenture stock 1985/90 of the company secured by a trust deed 21-6-1960 and deeds supplemental thereto | |
Brèves mentions F/Hold property 14 nicholas lane city of london titles 357278 and 181892 together with all buildings and erection and all fixed plant fixed machinery and all fixtures (incluidng trade fixtures) thereon belonging to the company. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 16 oct. 1981 Livré le 05 nov. 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from mepc LTD to manufactures hanover trust company under a loan agreement dated 2/10/81 and all sums due or to become duue from the company to the chargee under the terms of the charge. | |
Brèves mentions 439 and 441, oxford street, london borough of the city of westminster. Title nos - 145426 and ln 64539. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 16 oct. 1981 Livré le 05 nov. 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from mepc LTD to dresdner bank aktiengeseuschaft under a loan agreement dated 2/10/81 and all sums due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brèves mentions L/H 439 and 441, oxford street, london borough of the city of westminster. Title nos - 145426 and ln 64539. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 16 oct. 1981 Livré le 05 nov. 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from mepc LTD to county bank limited under a loan agreement dated 2/10/81 and all sums due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brèves mentions L/H 439 and 441 oxford street, london borough of the city of westminster . title nos - 145426 and ln 64539. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 16 oct. 1981 Livré le 05 nov. 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from mepc LTD to banque de paris et des pays-bas under a loan agreement dated 2/10/81 and all sums due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brèves mentions L/H 439 and 441, oxford street, london borough of the city of westminster. Title nos - 145426 and ln 64539. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 16 oct. 1981 Livré le 05 nov. 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from mepc LTD to bank of new south wales under a loan agreement dated 2/10/81 and all sums due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brèves mentions L/H 439 and 441 oxford street, london borough of the city of westminster. Title nos - 145426 and ln 64539. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 16 oct. 1981 Livré le 05 nov. 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from mepc LTD to bank of america national trust & savings association under a loan agreement dated 2/10/81 and all sums due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brèves mentions L/H 439 and 441 oxford street london borough of the city of westminster. Title nos - 145426 and ln 64539. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 16 oct. 1981 Livré le 05 nov. 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from mepc LTD to N.M.rothschild & sons limited under a loan agreement dated 2/10/81 and all sums due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brèves mentions L/H 439 and 441 oxford street london borough of the city of westminster. Title nos - 145426 and ln 64539. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 19 sept. 1974 Livré le 03 oct. 1974 | Totalement satisfaite | Montant garanti For further securing £25,000,000 under the terms of a loan agreement dated 7-12-73 and all other monies due or to become due from mepc limited to the chargee, secured by a charge dated 7-1-74 | |
Brèves mentions 439 and 441 oxford street, city of westminster, london title nos ln 64539 & 145426. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Further charge | Créé le 29 sept. 1972 Livré le 05 oct. 1972 | Totalement satisfaite | Montant garanti For securing £3,685,500 due from metropolitan estate and property corporation LTD to the chargee | |
Brèves mentions 20 albert embarkment lambeth SE1. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage | Créé le 02 sept. 1971 Livré le 03 sept. 1971 | Totalement satisfaite | Montant garanti £3,359,000 due from metropolitan estate and property corporation LTD. | |
Brèves mentions 20 albert embarkment lambeth SE1. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Further charge | Créé le 19 févr. 1970 Livré le 02 oct. 1978 | Totalement satisfaite | Montant garanti The interest due on a loan of £20,000,000 from mepc limited to the trustee under the terms of a principal charge dated 7TH january '74 and deeds supplemental thereto. | |
Brèves mentions 439 & 441 oxford st london (westminster) title no's ln 64539 & 145426. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Series of debentures | Créé le 16 janv. 1962 Livré le 24 janv. 1962 | Totalement satisfaite | ||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge | Créé le 11 déc. 1958 Livré le 15 déc. 1958 | Totalement satisfaite | Montant garanti £3,800 | |
Brèves mentions 75, 77, 79, high st, whitton, middlesex. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge | Créé le 06 juil. 1956 Livré le 10 juil. 1956 | Totalement satisfaite | Montant garanti £2000. | |
Brèves mentions 10 & 12 brighton road, south croydon surrey. Title no. Sy 66123. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 15 nov. 1954 Livré le 17 nov. 1954 | Totalement satisfaite | Montant garanti £2000. | |
Brèves mentions 206 high st, beckenham kent. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge | Créé le 29 sept. 1954 Livré le 05 oct. 1954 | Totalement satisfaite | Montant garanti £8,500 | |
Brèves mentions F/Hold:- 156 brompton road and 27 cheval place london S.W. title no 162742. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge | Créé le 29 sept. 1954 Livré le 05 oct. 1954 | Totalement satisfaite | Montant garanti £3,000 | |
Brèves mentions F/Hold:- 14 lavender hill battersea london. Title no 406496. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage | Créé le 24 mars 1954 Livré le 25 mars 1954 | Totalement satisfaite | Montant garanti £25,000 | |
Brèves mentions 7/15 white horse street briggate, leeds, york. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage | Créé le 01 juil. 1953 Livré le 03 juil. 1953 | Totalement satisfaite | Montant garanti £10,800 | |
Brèves mentions 10 buckingham palace, westminster, london. Title no. 181037. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Instrument of charge | Créé le 29 juin 1950 Livré le 07 juin 1950 | Totalement satisfaite | Montant garanti £10,000 | |
Brèves mentions No 1-14 york house & no 15-28 york house church st. On n side of york house place kensington london. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Ins: of charge | Créé le 06 févr. 1950 Livré le 23 févr. 1950 | Totalement satisfaite | Montant garanti By way of substituted security for securing £4,400 secured by a mortgage dated 18/1/36 | |
Brèves mentions 4, browns parade, green lanes, southgate, middx. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage | Créé le 06 févr. 1950 Livré le 23 févr. 1950 | Totalement satisfaite | Montant garanti By way of substituted security for securing £4,400 secured by a mortgage dated 18.1.36 | |
Brèves mentions 420, mare street, hackney, london, e. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Instr. Of further charge. | Créé le 02 août 1949 Livré le 03 août 1949 | Totalement satisfaite | Montant garanti £18,500. | |
Brèves mentions 1-14 york house & 15 to 28 york house & land on the north side of york house place, & the east side of kensington church street, kensington. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Instrument of charge. | Créé le 25 juin 1948 Livré le 25 juin 1948 | Totalement satisfaite | Montant garanti £50,000 | |
Brèves mentions 1-14 york house & 15 to 28 york house & land on the north side of york house place, & the east side of kensington church street, kensington. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
TOWN INVESTMENTS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0