NEVILL LONG LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | NEVILL LONG LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00184628 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe NEVILL LONG LIMITED ?
Adresse du siège social | 2 Kingmaker Court, Warwick Technology Park Gallows Hill CV34 6DY Warwick Warwickshire United Kingdom |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de NEVILL LONG LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 juil. 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour NEVILL LONG LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 20 mars 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 juil. 2018 | 17 pages | AA | ||||||||||||||
Modification des détails de Wolseley Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 déc. 2018 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Wolseley Uk Directors Limited le 03 déc. 2018 | 1 pages | CH02 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de The Wolseley Center Harrison Way Leamington Spa CV31 3HH à 2 Kingmaker Court, Warwick Technology Park Gallows Hill Warwick Warwickshire CV34 6DY le 03 déc. 2018 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
État du capital au 29 juin 2018
| 5 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomination de Katherine Mary Mccormick en tant que secrétaire le 31 mai 2018 | 2 pages | AP03 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Vanessa French en tant que secrétaire le 31 mai 2018 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 20 mars 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Nomination de Simon Gray en tant qu'administrateur le 01 mars 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Elizabeth Louise Hancox en tant que directeur le 02 mars 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 juil. 2017 | 15 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 20 mars 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 juil. 2016 | 14 pages | AA | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Marc Arthur Ronchetti en tant que directeur le 29 juil. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Nomination de Dr Elizabeth Louise Hancox en tant qu'administrateur le 08 juil. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 02 juil. 2016 avec mises à jour | 24 pages | CS01 | ||||||||||||||
Démission de l'auditeur | 2 pages | AUD | ||||||||||||||
Démission de l'auditeur | 2 pages | AUD | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de NEVILL LONG LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCCORMICK, Katherine Mary | Secrétaire | Kingmaker Court, Warwick Technology Park Gallows Hill CV34 6DY Warwick 2 Warwickshire United Kingdom | 247125270001 | |||||||||||
GRAY, Simon | Administrateur | Kingmaker Court, Warwick Technology Park Gallows Hill CV34 6DY Warwick 2 Warwickshire United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 243497760001 | ||||||||
WOLSELEY UK DIRECTORS LIMITED | Administrateur | Kingmaker Court, Warwick Technology Park Gallows Hill CV34 6DY Warwick 2 Warwickshire United Kingdom |
| 190186170001 | ||||||||||
DUNMOW, David Alan | Secrétaire | 51 Oak Lodge Tye Springfield CM1 6GY Chelmsford Essex | British | Finance Director | 17376370002 | |||||||||
FRENCH, Vanessa | Secrétaire | Harrison Way CV31 3HH Leamington Spa The Wolseley Center United Kingdom | 179501590001 | |||||||||||
JONES, Peter Howard | Secrétaire | 152 Church Green Road Bletchley MK3 6DD Milton Keynes Buckinghamshire | British | Company Secretary | 25572450001 | |||||||||
LATHAM, Philippa Anne Joan | Secrétaire | 4 Chepstow Crescent W11 3EB London | British | Company Secretary | 38437780003 | |||||||||
LYALL, James | Secrétaire | 44 Millway Duston NN5 6ES Northampton Northamptonshire | British | 12417440001 | ||||||||||
MIDDLEMISS, Graham | Secrétaire | 20 Spindle Lane Dickens Heath B90 1RP Solihull West Midlands | British | Solicitor | 100701940002 | |||||||||
ASHMORE, Stephen, Mr. | Administrateur | The Wolseley Center Harrison Way CV31 3HH Leamington Spa | England | British | Company Director | 232880380001 | ||||||||
BONNER, David George | Administrateur | 49 Badgers Close Bugbrooke NN7 3BA Northampton | England | British | Executive Sales Dir | 62317840001 | ||||||||
ELDRIDGE, John Barrington | Administrateur | 66 Halkingcroft Langley SL3 7AY Slough Berkshire | British | Sales Director | 13064260001 | |||||||||
HANCOX, Elizabeth Louise, Dr | Administrateur | Harrison Way CV31 3HH Leamington Spa The Wolseley Center United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 210216760001 | ||||||||
HARDING, Derek John | Administrateur | The Wolseley Center Harrison Way CV31 3HH Leamington Spa | United Kingdom | British | Accountant | 152377500001 | ||||||||
JONES, Keith Harold Davenport | Administrateur | The Wolseley Center Harrison Way CV31 3HH Leamington Spa | England | British | Director | 95915810001 | ||||||||
JONES, Peter Howard | Administrateur | 152 Church Green Road Bletchley MK3 6DD Milton Keynes Buckinghamshire | British | Finance Director | 25572450001 | |||||||||
LATHAM, Christopher George Arnot | Administrateur | 5 Canonbury Square N1 2AU London | British | Company Secretary | 12417450001 | |||||||||
LATHAM, David Russell | Administrateur | The Manor House Bayford SG13 8PU Hertford Hertfordshire | British | Director | 12417460001 | |||||||||
LATHAM, Paul William Christopher | Administrateur | Planoy 77540 Voinsles France | France | British | Sales Director | 120966790001 | ||||||||
LATHAM, Peter Douglas Langdon | Administrateur | 8 Flora Grove AL1 5ET St. Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | Company Director | 15588560002 | ||||||||
LATHAM, Roger John | Administrateur | Wilson House Farm Briestfield WF12 0PA Dewsbury West Yorkshire | British | Company Director | 17316370001 | |||||||||
LYALL, James | Administrateur | 44 Millway Duston NN5 6ES Northampton Northamptonshire | British | Company Secretary | 12417440001 | |||||||||
MIDDLEMISS, Graham | Administrateur | 20 Spindle Lane Dickens Heath B90 1RP Solihull West Midlands | United Kingdom | British | Solicitor | 100701940002 | ||||||||
NEARCHOU, Nicholas Savas | Administrateur | Abbotsford Oxhey Drive South HA6 3ET Northwood Middlesex | United Kingdom | British | Business Development Director | 112740760001 | ||||||||
NEVILLE, Matthew James | Administrateur | 9 The Brickall Long Marston CV37 8QL Stratford Upon Avon Warwickshire | England | British | Company Director | 85093360003 | ||||||||
RONCHETTI, Marc Arthur | Administrateur | Harrison Way CV31 3HH Leamington Spa The Wolseley Center United Kingdom | England | British | Company Director | 247980780001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur NEVILL LONG LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolseley Uk Limited | 02 juil. 2016 | Kingmaker Court, Warwick Technology Park Gallows Hill CV34 6DY Warwick 2 Warwickshire United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
NEVILL LONG LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 26 mars 1997 Livré le 01 avr. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 26 mars 1997 Livré le 01 avr. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 26 mars 1997 Livré le 01 avr. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 19 nov. 1993 Livré le 03 déc. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge | Créé le 01 mai 1968 Livré le 14 mai 1968 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due etc | |
Brèves mentions Floating charge on the (see doc 78 for full details, please). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0