NEVILL LONG LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNEVILL LONG LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00184628
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NEVILL LONG LIMITED ?

    • Commerce de gros non spécialisé (46900) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe NEVILL LONG LIMITED ?

    Adresse du siège social
    2 Kingmaker Court, Warwick Technology Park
    Gallows Hill
    CV34 6DY Warwick
    Warwickshire
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NEVILL LONG LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    NEVILL LONG & CO (BOARDS) LIMITED28 sept. 192228 sept. 1922

    Quels sont les derniers comptes de NEVILL LONG LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 juil. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour NEVILL LONG LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 20 mars 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 juil. 2018

    17 pagesAA

    Modification des détails de Wolseley Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 déc. 2018

    2 pagesPSC05

    Modification des coordonnées de l'administrateur Wolseley Uk Directors Limited le 03 déc. 2018

    1 pagesCH02

    Changement d'adresse du siège social de The Wolseley Center Harrison Way Leamington Spa CV31 3HH à 2 Kingmaker Court, Warwick Technology Park Gallows Hill Warwick Warwickshire CV34 6DY le 03 déc. 2018

    1 pagesAD01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 29 juin 2018

    • Capital: GBP 1
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Cancel non distributable capital reserve 04/06/2018
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Nomination de Katherine Mary Mccormick en tant que secrétaire le 31 mai 2018

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Vanessa French en tant que secrétaire le 31 mai 2018

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 20 mars 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Simon Gray en tant qu'administrateur le 01 mars 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Elizabeth Louise Hancox en tant que directeur le 02 mars 2018

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 juil. 2017

    15 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 20 mars 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 juil. 2016

    14 pagesAA

    Cessation de la nomination de Marc Arthur Ronchetti en tant que directeur le 29 juil. 2016

    1 pagesTM01

    Nomination de Dr Elizabeth Louise Hancox en tant qu'administrateur le 08 juil. 2016

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 02 juil. 2016 avec mises à jour

    24 pagesCS01

    Démission de l'auditeur

    2 pagesAUD

    Démission de l'auditeur

    2 pagesAUD

    Qui sont les dirigeants de NEVILL LONG LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MCCORMICK, Katherine Mary
    Kingmaker Court, Warwick Technology Park
    Gallows Hill
    CV34 6DY Warwick
    2
    Warwickshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Kingmaker Court, Warwick Technology Park
    Gallows Hill
    CV34 6DY Warwick
    2
    Warwickshire
    United Kingdom
    247125270001
    GRAY, Simon
    Kingmaker Court, Warwick Technology Park
    Gallows Hill
    CV34 6DY Warwick
    2
    Warwickshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Kingmaker Court, Warwick Technology Park
    Gallows Hill
    CV34 6DY Warwick
    2
    Warwickshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant243497760001
    WOLSELEY UK DIRECTORS LIMITED
    Kingmaker Court, Warwick Technology Park
    Gallows Hill
    CV34 6DY Warwick
    2
    Warwickshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Kingmaker Court, Warwick Technology Park
    Gallows Hill
    CV34 6DY Warwick
    2
    Warwickshire
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement09104902
    190186170001
    DUNMOW, David Alan
    51 Oak Lodge Tye
    Springfield
    CM1 6GY Chelmsford
    Essex
    Secrétaire
    51 Oak Lodge Tye
    Springfield
    CM1 6GY Chelmsford
    Essex
    BritishFinance Director17376370002
    FRENCH, Vanessa
    Harrison Way
    CV31 3HH Leamington Spa
    The Wolseley Center
    United Kingdom
    Secrétaire
    Harrison Way
    CV31 3HH Leamington Spa
    The Wolseley Center
    United Kingdom
    179501590001
    JONES, Peter Howard
    152 Church Green Road
    Bletchley
    MK3 6DD Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    152 Church Green Road
    Bletchley
    MK3 6DD Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishCompany Secretary25572450001
    LATHAM, Philippa Anne Joan
    4 Chepstow Crescent
    W11 3EB London
    Secrétaire
    4 Chepstow Crescent
    W11 3EB London
    BritishCompany Secretary38437780003
    LYALL, James
    44 Millway
    Duston
    NN5 6ES Northampton
    Northamptonshire
    Secrétaire
    44 Millway
    Duston
    NN5 6ES Northampton
    Northamptonshire
    British12417440001
    MIDDLEMISS, Graham
    20 Spindle Lane
    Dickens Heath
    B90 1RP Solihull
    West Midlands
    Secrétaire
    20 Spindle Lane
    Dickens Heath
    B90 1RP Solihull
    West Midlands
    BritishSolicitor100701940002
    ASHMORE, Stephen, Mr.
    The Wolseley Center
    Harrison Way
    CV31 3HH Leamington Spa
    Administrateur
    The Wolseley Center
    Harrison Way
    CV31 3HH Leamington Spa
    EnglandBritishCompany Director232880380001
    BONNER, David George
    49 Badgers Close
    Bugbrooke
    NN7 3BA Northampton
    Administrateur
    49 Badgers Close
    Bugbrooke
    NN7 3BA Northampton
    EnglandBritishExecutive Sales Dir62317840001
    ELDRIDGE, John Barrington
    66 Halkingcroft
    Langley
    SL3 7AY Slough
    Berkshire
    Administrateur
    66 Halkingcroft
    Langley
    SL3 7AY Slough
    Berkshire
    BritishSales Director13064260001
    HANCOX, Elizabeth Louise, Dr
    Harrison Way
    CV31 3HH Leamington Spa
    The Wolseley Center
    United Kingdom
    Administrateur
    Harrison Way
    CV31 3HH Leamington Spa
    The Wolseley Center
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant210216760001
    HARDING, Derek John
    The Wolseley Center
    Harrison Way
    CV31 3HH Leamington Spa
    Administrateur
    The Wolseley Center
    Harrison Way
    CV31 3HH Leamington Spa
    United KingdomBritishAccountant152377500001
    JONES, Keith Harold Davenport
    The Wolseley Center
    Harrison Way
    CV31 3HH Leamington Spa
    Administrateur
    The Wolseley Center
    Harrison Way
    CV31 3HH Leamington Spa
    EnglandBritishDirector95915810001
    JONES, Peter Howard
    152 Church Green Road
    Bletchley
    MK3 6DD Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Administrateur
    152 Church Green Road
    Bletchley
    MK3 6DD Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishFinance Director25572450001
    LATHAM, Christopher George Arnot
    5 Canonbury Square
    N1 2AU London
    Administrateur
    5 Canonbury Square
    N1 2AU London
    BritishCompany Secretary12417450001
    LATHAM, David Russell
    The Manor House Bayford
    SG13 8PU Hertford
    Hertfordshire
    Administrateur
    The Manor House Bayford
    SG13 8PU Hertford
    Hertfordshire
    BritishDirector12417460001
    LATHAM, Paul William Christopher
    Planoy
    77540 Voinsles
    France
    Administrateur
    Planoy
    77540 Voinsles
    France
    FranceBritishSales Director120966790001
    LATHAM, Peter Douglas Langdon
    8 Flora Grove
    AL1 5ET St. Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    8 Flora Grove
    AL1 5ET St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Director15588560002
    LATHAM, Roger John
    Wilson House Farm
    Briestfield
    WF12 0PA Dewsbury
    West Yorkshire
    Administrateur
    Wilson House Farm
    Briestfield
    WF12 0PA Dewsbury
    West Yorkshire
    BritishCompany Director17316370001
    LYALL, James
    44 Millway
    Duston
    NN5 6ES Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    44 Millway
    Duston
    NN5 6ES Northampton
    Northamptonshire
    BritishCompany Secretary12417440001
    MIDDLEMISS, Graham
    20 Spindle Lane
    Dickens Heath
    B90 1RP Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    20 Spindle Lane
    Dickens Heath
    B90 1RP Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritishSolicitor100701940002
    NEARCHOU, Nicholas Savas
    Abbotsford
    Oxhey Drive South
    HA6 3ET Northwood
    Middlesex
    Administrateur
    Abbotsford
    Oxhey Drive South
    HA6 3ET Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritishBusiness Development Director112740760001
    NEVILLE, Matthew James
    9 The Brickall
    Long Marston
    CV37 8QL Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Administrateur
    9 The Brickall
    Long Marston
    CV37 8QL Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    EnglandBritishCompany Director85093360003
    RONCHETTI, Marc Arthur
    Harrison Way
    CV31 3HH Leamington Spa
    The Wolseley Center
    United Kingdom
    Administrateur
    Harrison Way
    CV31 3HH Leamington Spa
    The Wolseley Center
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director247980780001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur NEVILL LONG LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Wolseley Uk Limited
    Kingmaker Court, Warwick Technology Park
    Gallows Hill
    CV34 6DY Warwick
    2
    Warwickshire
    United Kingdom
    02 juil. 2016
    Kingmaker Court, Warwick Technology Park
    Gallows Hill
    CV34 6DY Warwick
    2
    Warwickshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUnited Kingdom
    Lieu d'enregistrementCompanies House Register
    Numéro d'enregistrement00636445
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    NEVILL LONG LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 26 mars 1997
    Livré le 01 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Merita Bank LTD
    Transactions
    • 01 avr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 août 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 26 mars 1997
    Livré le 01 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transactions
    • 01 avr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 26 mars 1997
    Livré le 01 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 01 avr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 nov. 1993
    Livré le 03 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hambros Bank Limited, for Itself and as Trustee for the Banks (As Defined)
    Transactions
    • 03 déc. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 sept. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 01 mai 1968
    Livré le 14 mai 1968
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due etc
    Brèves mentions
    Floating charge on the (see doc 78 for full details, please). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 14 mai 1968Enregistrement d'une charge
    • 03 sept. 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0