ISTITHMAR ESTATES LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | ISTITHMAR ESTATES LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00195207 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe ISTITHMAR ESTATES LIMITED ?
Adresse du siège social | 16 Palace Street London SW1E 5JQ |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de ISTITHMAR ESTATES LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 24 déc. 2009 |
Quels sont les derniers dépôts pour ISTITHMAR ESTATES LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 mai 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Nicholson en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Cynthia Mary Coombe en tant que secrétaire | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 24 déc. 2009 | 9 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 mai 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Nomination de Mr Ian Gregory Howie Barnett en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Angus Fletcher en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed nakheel estates LIMITED\certificate issued on 20/01/10 | 3 pages | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes établis au 24 déc. 2008 | 9 pages | AA | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288a | ||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||
legacy | 4 pages | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
Comptes établis au 24 déc. 2007 | 11 pages | AA | ||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||
Statuts | 33 pages | MA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de ISTITHMAR ESTATES LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COOMBE, Cynthia Mary | Secrétaire | Palace Street SW1E 5JQ London 16 England England | 155158090001 | |||||||
BARNETT, Ian Gregory Howie | Administrateur | The Firs RG17 9PT Inkpen Winswood United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 11591280001 | ||||
KESHIRO, Rashidi Olugbenga | Administrateur | 19 Longfield Avenue NW7 2EH London | United Kingdom | British | Finance Director | 120935530001 | ||||
ALLINSON, Bernadette | Secrétaire | Linden Lea Hutton Roof LA6 2PG Kirkby Lonsdale Lancashire | Other | 116264270001 | ||||||
ASHURST, John Richard | Secrétaire | 20 Culverhay KT21 1PR Ashtead Surrey | British | 31732150003 | ||||||
BIGNELL, Philip Alwyn | Secrétaire | 65 Clissold Crescent Stoke Newington N16 9AR London | British | 11498530001 | ||||||
NICHOLSON, David John | Secrétaire | Savannah Villa 7 PO BOX 28656 Dubai Arabian Ranches United Arab Emirates | Other | General Counsel | 129525930001 | |||||
WYATT, Edmund Kenneth | Secrétaire | 145 Oaklands Avenue Oxhey WD1 4LH Watford Hertfordshire | British | 10691680001 | ||||||
BIGNELL, Philip Alwyn | Administrateur | 65 Clissold Crescent Stoke Newington N16 9AR London | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 11498530001 | ||||
EDGERLEY, William Thomas | Administrateur | 1 Diamond Terrace Greenwich SE10 8QN London | England | British | Director | 36091100002 | ||||
FERGUSON, Robert George | Administrateur | The Warren 51 Between Streets KT11 1AA Cobham Surrey | British | Surveyor | 10691690002 | |||||
FLETCHER, Angus Howard | Administrateur | 9 Lees Heights Charlbury OX7 3EZ Chipping Norton Oxfordshire | United Kingdom | British | Surveyor | 65254010001 | ||||
KNIGHT, Raymond Antony | Administrateur | Furzewood Barden Road Speldhurst TN3 0LE Tunbridge Wells Kent | British | Chartered Surveyor | 2198910001 | |||||
PREISKEL, Anthony Alexander | Administrateur | 93 Corringham Road NW11 7DL London | United Kingdom | British | Company Director | 36551930001 | ||||
SADLER, Christopher Frank | Administrateur | 59a Marney Road Battersea SW11 5EW London | British | Chartered Accountant | 36608160001 | |||||
WALKER, Peter Arthur | Administrateur | 64 Connaught Avenue Chingford E4 7AA London | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 708770001 |
ISTITHMAR ESTATES LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Mortgage | Créé le 18 janv. 1959 Livré le 19 janv. 1959 | Totalement satisfaite | Montant garanti £45,000 | |
Brèves mentions 52/55 carnaby street/ W.1. title no. 145837. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage supplemental to the above or charge by way collateral security. | Créé le 03 mars 1955 Livré le 14 mars 1955 | Totalement satisfaite | Montant garanti For securing £50,000 together with a premium of up to 5% in certain events secured by a legal charge dated 3 march 1955. | |
Brèves mentions (2) a sinking fund policy for £50,000 payable on the 3RD march 1975 dated 3RD march 1955 and nos 63590. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 03 mars 1955 Livré le 14 mars 1955 | Totalement satisfaite | Montant garanti £50,000 together with a premium of up to 5% certain events | |
Brèves mentions (1) freehold premises 22 tower street holborn london leasehold premises 24 haymarket and 2 panton street westminster, london title 367800. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage supplemental to above legal charge (see doc 50) | Créé le 31 déc. 1954 Acquis le 17 oct. 1956 Livré le 25 oct. 1956 | Totalement satisfaite | Montant garanti See col 3 | |
Brèves mentions Sinking fund policy with the century insurance company LTD. No 63548. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 31 déc. 1954 Acquis le 17 oct. 1956 Livré le 25 oct. 1956 | Totalement satisfaite | Montant garanti £40,000 together with a premium of up to 5% in certain events and a mortgage collateral thereto secured on property acquiired by the company (owing) | |
Brèves mentions 19,20,21 tower street and 50/52 monmouth street holborn london title nos. 243505 62853 and 63016. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0