ISTITHMAR ESTATES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéISTITHMAR ESTATES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00195207
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ISTITHMAR ESTATES LIMITED ?

    • (7020) /

    Où se situe ISTITHMAR ESTATES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    16 Palace Street
    London
    SW1E 5JQ
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ISTITHMAR ESTATES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    NAKHEEL ESTATES LIMITED06 juin 200806 juin 2008
    LINDEN GARDENS TRUST.LIMITED(THE)21 janv. 192421 janv. 1924

    Quels sont les derniers comptes de ISTITHMAR ESTATES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au24 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour ISTITHMAR ESTATES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 mai 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital25 mai 2011

    État du capital au 25 mai 2011

    • Capital: GBP 5
    SH01

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Cessation de la nomination de David Nicholson en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Cynthia Mary Coombe en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Comptes pour une société dormante établis au 24 déc. 2009

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 mai 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Nomination de Mr Ian Gregory Howie Barnett en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Angus Fletcher en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed nakheel estates LIMITED\certificate issued on 20/01/10
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name20 janv. 2010

    Avis de changement de nom"

    CONNOT

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Comptes établis au 24 déc. 2008

    9 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    4 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 24 déc. 2007

    11 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Statuts

    33 pagesMA

    Qui sont les dirigeants de ISTITHMAR ESTATES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    COOMBE, Cynthia Mary
    Palace Street
    SW1E 5JQ London
    16
    England
    England
    Secrétaire
    Palace Street
    SW1E 5JQ London
    16
    England
    England
    155158090001
    BARNETT, Ian Gregory Howie
    The Firs
    RG17 9PT Inkpen
    Winswood
    United Kingdom
    Administrateur
    The Firs
    RG17 9PT Inkpen
    Winswood
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director11591280001
    KESHIRO, Rashidi Olugbenga
    19 Longfield Avenue
    NW7 2EH London
    Administrateur
    19 Longfield Avenue
    NW7 2EH London
    United KingdomBritishFinance Director120935530001
    ALLINSON, Bernadette
    Linden Lea
    Hutton Roof
    LA6 2PG Kirkby Lonsdale
    Lancashire
    Secrétaire
    Linden Lea
    Hutton Roof
    LA6 2PG Kirkby Lonsdale
    Lancashire
    Other116264270001
    ASHURST, John Richard
    20 Culverhay
    KT21 1PR Ashtead
    Surrey
    Secrétaire
    20 Culverhay
    KT21 1PR Ashtead
    Surrey
    British31732150003
    BIGNELL, Philip Alwyn
    65 Clissold Crescent
    Stoke Newington
    N16 9AR London
    Secrétaire
    65 Clissold Crescent
    Stoke Newington
    N16 9AR London
    British11498530001
    NICHOLSON, David John
    Savannah Villa 7
    PO BOX 28656
    Dubai
    Arabian Ranches
    United Arab Emirates
    Secrétaire
    Savannah Villa 7
    PO BOX 28656
    Dubai
    Arabian Ranches
    United Arab Emirates
    OtherGeneral Counsel129525930001
    WYATT, Edmund Kenneth
    145 Oaklands Avenue
    Oxhey
    WD1 4LH Watford
    Hertfordshire
    Secrétaire
    145 Oaklands Avenue
    Oxhey
    WD1 4LH Watford
    Hertfordshire
    British10691680001
    BIGNELL, Philip Alwyn
    65 Clissold Crescent
    Stoke Newington
    N16 9AR London
    Administrateur
    65 Clissold Crescent
    Stoke Newington
    N16 9AR London
    United KingdomBritishChartered Accountant11498530001
    EDGERLEY, William Thomas
    1 Diamond Terrace
    Greenwich
    SE10 8QN London
    Administrateur
    1 Diamond Terrace
    Greenwich
    SE10 8QN London
    EnglandBritishDirector36091100002
    FERGUSON, Robert George
    The Warren 51 Between Streets
    KT11 1AA Cobham
    Surrey
    Administrateur
    The Warren 51 Between Streets
    KT11 1AA Cobham
    Surrey
    BritishSurveyor10691690002
    FLETCHER, Angus Howard
    9 Lees Heights
    Charlbury
    OX7 3EZ Chipping Norton
    Oxfordshire
    Administrateur
    9 Lees Heights
    Charlbury
    OX7 3EZ Chipping Norton
    Oxfordshire
    United KingdomBritishSurveyor65254010001
    KNIGHT, Raymond Antony
    Furzewood Barden Road
    Speldhurst
    TN3 0LE Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    Furzewood Barden Road
    Speldhurst
    TN3 0LE Tunbridge Wells
    Kent
    BritishChartered Surveyor2198910001
    PREISKEL, Anthony Alexander
    93 Corringham Road
    NW11 7DL London
    Administrateur
    93 Corringham Road
    NW11 7DL London
    United KingdomBritishCompany Director36551930001
    SADLER, Christopher Frank
    59a Marney Road
    Battersea
    SW11 5EW London
    Administrateur
    59a Marney Road
    Battersea
    SW11 5EW London
    BritishChartered Accountant36608160001
    WALKER, Peter Arthur
    64 Connaught Avenue
    Chingford
    E4 7AA London
    Administrateur
    64 Connaught Avenue
    Chingford
    E4 7AA London
    United KingdomBritishChartered Accountant708770001

    ISTITHMAR ESTATES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage
    Créé le 18 janv. 1959
    Livré le 19 janv. 1959
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £45,000
    Brèves mentions
    52/55 carnaby street/ W.1. title no. 145837.
    Personnes ayant droit
    • Legal and General Assurance Society LTD
    Transactions
    • 19 janv. 1959Enregistrement d'une charge
    • 28 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage supplemental to the above or charge by way collateral security.
    Créé le 03 mars 1955
    Livré le 14 mars 1955
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For securing £50,000 together with a premium of up to 5% in certain events secured by a legal charge dated 3 march 1955.
    Brèves mentions
    (2) a sinking fund policy for £50,000 payable on the 3RD march 1975 dated 3RD march 1955 and nos 63590.
    Personnes ayant droit
    • Friends' Provident and Century Life Office
    Transactions
    • 14 mars 1955Enregistrement d'une charge
    • 28 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 03 mars 1955
    Livré le 14 mars 1955
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £50,000 together with a premium of up to 5% certain events
    Brèves mentions
    (1) freehold premises 22 tower street holborn london leasehold premises 24 haymarket and 2 panton street westminster, london title 367800.
    Personnes ayant droit
    • Friends' Provident and Century Life Office
    Transactions
    • 14 mars 1955Enregistrement d'une charge
    Mortgage supplemental to above legal charge (see doc 50)
    Créé le 31 déc. 1954
    Acquis le 17 oct. 1956
    Livré le 25 oct. 1956
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    See col 3
    Brèves mentions
    Sinking fund policy with the century insurance company LTD. No 63548.
    Personnes ayant droit
    • Friends Provident and Century Life Office
    Transactions
    • 25 oct. 1956Enregistrement d'une charge
    • 28 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 31 déc. 1954
    Acquis le 17 oct. 1956
    Livré le 25 oct. 1956
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £40,000 together with a premium of up to 5% in certain events and a mortgage collateral thereto secured on property acquiired by the company (owing)
    Brèves mentions
    19,20,21 tower street and 50/52 monmouth street holborn london title nos. 243505 62853 and 63016.
    Personnes ayant droit
    • Friends Provident and Century Life Office
    Transactions
    • 25 oct. 1956Enregistrement d'une charge
    • 28 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0