DEXION INTERNATIONAL LIMITED

DEXION INTERNATIONAL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDEXION INTERNATIONAL LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00195736
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DEXION INTERNATIONAL LIMITED ?

    • (2922) /

    Où se situe DEXION INTERNATIONAL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Ernst & Young Llp
    No 1 Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de DEXION INTERNATIONAL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    INTERLAKE UK LIMITED31 déc. 198431 déc. 1984
    GERRARD INDUSTRIES LIMITED14 févr. 192414 févr. 1924

    Quels sont les derniers comptes de DEXION INTERNATIONAL LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2003
    Date d'échéance des prochains comptes31 oct. 2004
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2002

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour DEXION INTERNATIONAL LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour DEXION INTERNATIONAL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Restauration par ordonnance du tribunal

    3 pagesAC92
    Q5AAQM5V

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Avis d'achèvement de l'accord volontaire

    10 pages1.4
    A3CRS6WE

    Résumé des recettes et paiements du superviseur de l'accord volontaire jusqu'au 21 déc. 2013

    10 pages1.3
    A3245ANC

    Résumé des recettes et paiements du superviseur de l'accord volontaire jusqu'au 21 déc. 2012

    10 pages1.3
    A22C1RBU

    Résumé des recettes et paiements du superviseur de l'accord volontaire jusqu'au 21 déc. 2011

    9 pages1.3
    A110BVEG

    Résumé des recettes et paiements du superviseur de l'accord volontaire jusqu'au 21 déc. 2010

    10 pages1.3
    A680DRSK

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 12 nov. 2010

    2 pages3.6
    AEL1BP6G

    legacy

    2 pagesLQ02
    AEDNZP6I

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 12 mai 2010

    2 pages3.6
    A598XLJX

    Avis au registre des sociétés de l'accord volontaire prenant effet

    6 pages1.1
    PRQSFG70

    Nomination de Andrew Stephen Leese en tant que secrétaire

    3 pagesAP03
    AXWE6FPR

    Cessation de la nomination de Simon Martinsen en tant que directeur

    2 pagesTM01
    RWA9VFL1

    Cessation de la nomination de Stuart Jackson en tant que directeur

    2 pagesTM01
    A07GBFL8

    Cessation de la nomination de Hallvard Muri en tant que directeur

    2 pagesTM01
    A07GAFL7

    Nomination de Olay Revhaug en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01
    A07G9FL6

    Nomination de Steinar Vatle en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01
    A07G8FL5

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 12 mai 2009

    2 pages3.6
    A3ATXAZM

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 12 mai 2009

    2 pages3.6
    AE2H317I

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 12 mai 2008

    2 pages3.6
    AE50M17N

    Résumé des recettes et paiements du récepteur

    2 pages3.6

    legacy

    1 pages288b

    Résumé des recettes et paiements du récepteur

    2 pages3.6

    legacy

    2 pages288a

    Qui sont les dirigeants de DEXION INTERNATIONAL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LEESE, Andrew Stephen
    Sell Close
    EN7 6XE Cheshunt
    1
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Sell Close
    EN7 6XE Cheshunt
    1
    Hertfordshire
    British147718000001
    REVHAUG, Olav
    Fjordallen 16
    PO BOX 1423 Vika
    0250 No - Oslo
    Aker Asa
    Norway
    Administrateur
    Fjordallen 16
    PO BOX 1423 Vika
    0250 No - Oslo
    Aker Asa
    Norway
    NorwayNorwegianActing Cfo105373050001
    VATLE, Steinar Hausberg
    Fjordallen 16
    PO BOX 1423 Vika
    No - Oslo
    Aker Asa
    0250
    Norway
    Administrateur
    Fjordallen 16
    PO BOX 1423 Vika
    No - Oslo
    Aker Asa
    0250
    Norway
    NorwayNorwegianFinance Manager162452370001
    FOSTER, Alison Taylor
    136 Eastmoor Park
    AL5 1BP Harpenden
    Hertfordshire
    Secrétaire
    136 Eastmoor Park
    AL5 1BP Harpenden
    Hertfordshire
    British62154470001
    WEBSTER, Martin Jeffrey
    42 Northway
    Hampstead Garden Suburb
    NW3 5DR London
    Secrétaire
    42 Northway
    Hampstead Garden Suburb
    NW3 5DR London
    British6916040002
    WEBSTER, Martin Jeffrey
    42 Northway
    Hampstead Garden Suburb
    NW3 5DR London
    Secrétaire
    42 Northway
    Hampstead Garden Suburb
    NW3 5DR London
    British6916040002
    APPLETON, Kevin Andrew
    Dormer House
    Cumnor Hill
    OX2 9JA Oxford
    Oxfordshire
    Administrateur
    Dormer House
    Cumnor Hill
    OX2 9JA Oxford
    Oxfordshire
    BritishDirector67821450002
    BEAK, David William
    36 Rousebarn Lane
    Croxley Green
    WD3 3RL Rickmansworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    36 Rousebarn Lane
    Croxley Green
    WD3 3RL Rickmansworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritishFinance Director46400020001
    COUTTS, Neil Mccrone
    St Dunstans House
    Mill Lane Monks
    HP27 9JE Risborough
    Buckinghamshire
    Administrateur
    St Dunstans House
    Mill Lane Monks
    HP27 9JE Risborough
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishDirector43075390001
    GREISCH, John Jay
    2636 Chesapeake Lane
    60062 Northbrook
    Illinois
    Usa
    Administrateur
    2636 Chesapeake Lane
    60062 Northbrook
    Illinois
    Usa
    AmericanCompany Executive6916060002
    GREISCH, John Jay
    5 Hamilton Gardens
    NW8 9PT London
    Administrateur
    5 Hamilton Gardens
    NW8 9PT London
    AmericanManaging Director6916060001
    HEY, John Stephen Paul
    8 Hopping Lane
    N1 2NU London
    Administrateur
    8 Hopping Lane
    N1 2NU London
    BritishManaging Director71286180001
    JACKSON, Stuart
    The Coach House
    Church Street
    CM9 8AR Goldhanger
    Essex
    Administrateur
    The Coach House
    Church Street
    CM9 8AR Goldhanger
    Essex
    United KingdomBritishCompany Director72753960003
    MARTINSEN, Simon Nyquist
    Hvitveisstien 2
    1346 Gjettum
    Norway
    Administrateur
    Hvitveisstien 2
    1346 Gjettum
    Norway
    NorwayNorwegianCfo96352030001
    MILLER, Stuart Purves
    1 Meadway Park
    SL9 7NN Gerards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    1 Meadway Park
    SL9 7NN Gerards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector98718070001
    MURI, Hallvard
    Vendla 53
    Nesqya
    1397
    Norway
    Administrateur
    Vendla 53
    Nesqya
    1397
    Norway
    NorwegianCeo108570900001
    OSMAN, Wayne Miles
    48a Queens Road
    SG13 8BB Hertford
    Hertfordshire
    Administrateur
    48a Queens Road
    SG13 8BB Hertford
    Hertfordshire
    BritishManaging Director37925180001
    PIACENTI, Vincent Edward
    142-146 Fishpool Street
    AL3 4RZ St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    142-146 Fishpool Street
    AL3 4RZ St Albans
    Hertfordshire
    BritishDirector20998310002
    SJURSEN, Frode
    Valhallvn 4c
    3500 Honefoss
    Norway
    Administrateur
    Valhallvn 4c
    3500 Honefoss
    Norway
    NorwegianChief Executive62938670001
    SMITH, Nicholas Ralph
    1 Tompkins Close
    HP22 5WH Aston Clinton
    Buckinghamshire
    Administrateur
    1 Tompkins Close
    HP22 5WH Aston Clinton
    Buckinghamshire
    BritishChief Financial Officer72551500001
    STILLER, Bernd Wenzel Paul
    Beethovenstrasse 4
    6312 Laubach
    Germany
    Administrateur
    Beethovenstrasse 4
    6312 Laubach
    Germany
    GermanDirector33839420001
    TAYLOR, Paul Kevin
    25 Clover Lane
    DY6 0DT Kingswinford
    West Midlands
    Administrateur
    25 Clover Lane
    DY6 0DT Kingswinford
    West Midlands
    EnglandBritishDirector30603010001
    VAN ENGELAND, Maarten
    Avej 20a
    FOREIGN 3500 Vaerlose
    Denmark
    Denmark
    Administrateur
    Avej 20a
    FOREIGN 3500 Vaerlose
    Denmark
    Denmark
    DutchDirector64878410001
    WEBSTER, Martin Jeffrey
    42 Northway
    Hampstead Garden Suburb
    NW3 5DR London
    Administrateur
    42 Northway
    Hampstead Garden Suburb
    NW3 5DR London
    EnglandBritishCompany Secretary6916040002
    WILMOT, Geoffrey Tristan Descarriers
    122 Taybridge Road
    SW11 5PZ London
    Administrateur
    122 Taybridge Road
    SW11 5PZ London
    BritishDirector11278690001

    DEXION INTERNATIONAL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 14 juil. 2000
    Livré le 26 juil. 2000
    Partiellement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aker Rgi Holding Asa
    Transactions
    • 26 juil. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 07 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 03 févr. 1999
    Livré le 17 févr. 1999
    Partiellement satisfaite
    Montant garanti
    The actual,contingent,present and/or future obligations and liabilities of the company to the chargee as agent and trustee for the secured parties (as defined) and to any of the secured parties under or pursuant to,all or any of the financing documents (as defined)
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Credit Suisse First Boston
    Transactions
    • 17 févr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 07 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 15 mai 2003Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (405 (1))
    • 19 sept. 2003Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (405 (2))
    • 17 oct. 2003Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (405 (1))
    • 24 sept. 2004Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (405 (2))
    • 117 nov. 2010Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (LQ02)
      • Numéro de dossier 1
    Trade marks charge
    Créé le 03 févr. 1999
    Livré le 17 févr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The actual,contingent,present and/or future obligations and liabilities of the company to the chargee as agent and trustee for the secured parties (as defined) and to any of the secured parties under or pursuant to,all or any of the financing documents (as defined)
    Brèves mentions
    The trade marks being rediangle registered no R1001674 class 6,redirack registered no H998738 class 6 and redishelf registered no H1151926 and any goodwill of the company's business to which the trade marks relate and to any other rights which may arise from,relate to or be associated with the trade marks.
    Personnes ayant droit
    • Credit Suisse First Boston
    Transactions
    • 17 févr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 mai 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A trade marks charge
    Créé le 19 déc. 1997
    Livré le 24 déc. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The actual,contingent,present and/or future obligations and liabilities of the company to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to all or any of the financing documents (as defined)
    Brèves mentions
    The chargor as legal,beneficial and registered owner charged as continuing security for the payment of the secured obligations by way of first fixed charge in favour of the security trustee all the charged property (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Credit Suisse First Bostonas Agent and Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transactions
    • 24 déc. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 mai 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 19 déc. 1997
    Livré le 24 déc. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The actual,contingent,present and/or future obligations and liabilities of the company to any of the secured parties under,or pursuant to,all or any of the financing documents including the guarantee and debenture(the "secured obligations")
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Credit Suisse First Boston (Security Trustee)
    Transactions
    • 24 déc. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 mai 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security
    Créé le 07 sept. 1992
    Livré le 28 sept. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and each of the "secured creditors" (as defined therein) under the terms of all or any of the "credit documents" (as defined) and any hedging agreements or any other documents entered into
    Brèves mentions
    Plot of ground lying on the west side of tollpark place, cumbernauld together with the factory buildings thereon all k/a 12 tollpark place, cumbernauld t/no. DMB29210.
    Personnes ayant droit
    • Chemical Bank"Secured Creditors" (As Defined Therein)as Agent and Trustee for Itself and Each of The
    Transactions
    • 28 sept. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 mars 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 14 août 1992
    Livré le 27 août 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and the secured creditors (all as defined therein) under the terms of all or any of the "credit documents" (as defined therein)
    Brèves mentions
    F/H land lying to the north of wharf road, kilnhurst t/nos. SYK124247 & SYK144418 with all buildings thereon and the proceeds of sale thereof and a fixed charge on all fixtures fixed and moveable plant machinery and equipment and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Chemical Bankcreditors (All as Defined Therein)as Agent and Trustee for Itself and the Secured
    Transactions
    • 27 août 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 mai 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 14 août 1992
    Livré le 27 août 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and the secured creditors (all as defined therein) under the terms of all or any of the "credit documents" (as defined therein)
    Brèves mentions
    (For full details see form 395 tc ref: M4). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Chemical Bankcreditors (All as Defined)as Agent and Trustee for Itself and the Secured
    Transactions
    • 27 août 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 mai 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Share charge agreement
    Créé le 27 sept. 1989
    Livré le 17 oct. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as collateral agent under the terms of the credit agreement dated 27TH september 1989 any hedging agreement (as defined) and this deed
    Brèves mentions
    All dividends paid on payable after the date hereof on all on any of the shares and all stocks shares securities (and to dividends and interest thereon) rights moneys on property accruing on offered at any time by way of redemption loan preference, option rights or otherwise in respect of the shares (please see form 395 for details).
    Personnes ayant droit
    • Chemical Bank
    Transactions
    • 17 oct. 1989Enregistrement d'une charge
    • 07 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Subsidiary security deed
    Créé le 27 sept. 1989
    Livré le 17 oct. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as collateral agent) under the terms of the credit agreement dated 27TH september 1989 any hedging agreement (as defined) and this deed
    Brèves mentions
    Fixed charge over each and every receivable,all inventory the cash collateral account and all monies securities and instruments deposited in the cash collateral account see form 395 for full details.
    Personnes ayant droit
    • Chemical Bank
    Transactions
    • 17 oct. 1989Enregistrement d'une charge
    • 22 mars 1994Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 07 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Memorandum charge
    Créé le 10 sept. 1985
    Livré le 23 sept. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All monies in any currency or currencies whatsoever now or hereafter standing to the credit of the company with banque nationale de paris PLC.
    Personnes ayant droit
    • Banque Nationale De Paris PLC
    Transactions
    • 23 sept. 1985Enregistrement d'une charge
    Charge by way of collateral
    Créé le 15 juin 1933
    Livré le 27 juin 1933
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Securing for £25,000 debs of company
    Brèves mentions
    12502 fully paid shares of £1 each held by coy in colourgravare LTD.
    Personnes ayant droit
    • Prudential Assurance Co LTD
    Transactions
    • 27 juin 1933Enregistrement d'une charge
    • 07 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    DEXION INTERNATIONAL LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    03 févr. 1999Instrument date
    Administrative receiver appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Wr. Tacon
    Ernst & Young
    One Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    practitioner
    Ernst & Young
    One Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    Adrian John Wolstenholme
    Ernst & Young
    One Colmore Row
    B3 2BD Birmingham
    practitioner
    Ernst & Young
    One Colmore Row
    B3 2BD Birmingham
    Ian Best
    Ernst & Young
    One Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    practitioner
    Ernst & Young
    One Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    2
    DateType
    22 déc. 2009Date of meeting to approve CVA
    22 juil. 2014Date of completion or termination of CVA
    Corporate voluntary arrangement (CVA)
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    practitioner
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0