CREMANAZE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCREMANAZE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00198371
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CREMANAZE LIMITED ?

    • (1589) /

    Où se situe CREMANAZE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    2 Mountview Court 310 Friern Barnet Lane
    Whetstone
    N20 0YZ London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CREMANAZE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MEDEOL UK LIMITED01 avr. 199301 avr. 1993
    CREMANAZE SALADS LIMITED02 juin 192402 juin 1924

    Quels sont les derniers comptes de CREMANAZE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2007

    Quels sont les derniers dépôts pour CREMANAZE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01
    A6TLBUVU

    Résumé des recettes et paiements du superviseur de l'accord volontaire jusqu'au 29 nov. 2010

    2 pages1.3
    A24BDPXQ

    Avis d'achèvement de l'accord volontaire

    8 pages1.4
    A4YQBPRT

    Résumé des recettes et paiements du superviseur de l'accord volontaire jusqu'au 27 avr. 2010

    13 pages1.3
    ATLQTK7Y

    Résumé des recettes et paiements du superviseur de l'accord volontaire jusqu'au 27 avr. 2009

    11 pages1.3
    AYFYTKEC

    Résumé des recettes et paiements du superviseur de l'accord volontaire jusqu'au 27 avr. 2009

    11 pages1.3
    ALRXQ9WE

    legacy

    1 pages288b
    XVSCO7WN

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2007

    19 pagesAA
    A8A401IF

    Avis au registre des sociétés de l'accord volontaire prenant effet

    11 pages1.1
    AML79ZB7

    legacy

    1 pages287
    AJESPY1N

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2006

    20 pagesAA

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    6 pages363s

    legacy

    1 pages288a

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2005

    20 pagesAA

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2004

    19 pagesAA

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    7 pages363s

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2003

    19 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de CREMANAZE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    NORMANTON, Tom Frederick William
    Old Rectory
    Oby
    NR29 3BP Great Yarmouth
    Norfolk
    Secrétaire
    Old Rectory
    Oby
    NR29 3BP Great Yarmouth
    Norfolk
    BritishDirector82209410001
    MACK, Timothy John
    Brinklow Church Road
    Mendlesham
    IP14 5SF Stowmarket
    Suffolk
    Administrateur
    Brinklow Church Road
    Mendlesham
    IP14 5SF Stowmarket
    Suffolk
    EnglandBritishManaging Director13782470001
    NORMANTON, Tom Frederick William
    Old Rectory
    Oby
    NR29 3BP Great Yarmouth
    Norfolk
    Administrateur
    Old Rectory
    Oby
    NR29 3BP Great Yarmouth
    Norfolk
    EnglandBritishDirector82209410001
    ROSE, Martyn Craig
    39a Limerston Street
    SW10 0BQ London
    Administrateur
    39a Limerston Street
    SW10 0BQ London
    BritishDirector75808040001
    WARD, Edward John
    29 Ivedon Road
    DA16 1NN Welling
    Kent
    Administrateur
    29 Ivedon Road
    DA16 1NN Welling
    Kent
    United KingdomBritishFinance Director110326230002
    AKISTER, John Edward
    Northdown Road
    DA3 7QW Longfield
    56
    Kent
    Secrétaire
    Northdown Road
    DA3 7QW Longfield
    56
    Kent
    British133597670001
    BURGESS, David Patrick Henry
    Apartment 9
    100 Piccadilly
    W1J 7NH London
    Secrétaire
    Apartment 9
    100 Piccadilly
    W1J 7NH London
    BritishSolicitor124903940001
    FLOOK, Susan Narelle
    Fern Lodge
    London Road
    RG12 6QR Bracknell
    Berkshire
    Secrétaire
    Fern Lodge
    London Road
    RG12 6QR Bracknell
    Berkshire
    Australian168876340001
    MACAULAY, Barbara Scott
    1 Mayfield Close
    AL5 3LG Harpenden
    Hertfordshire
    Secrétaire
    1 Mayfield Close
    AL5 3LG Harpenden
    Hertfordshire
    British39335990001
    NEWICK, Lisa Jane
    44 Winchendon Road
    SW6 5DR London
    Secrétaire
    44 Winchendon Road
    SW6 5DR London
    BritishSolicitor45931180003
    TERRY, Alan James
    17 Junewood Close
    Woodham
    KT15 3PX Addlestone
    Surrey
    Secrétaire
    17 Junewood Close
    Woodham
    KT15 3PX Addlestone
    Surrey
    BritishAccountant2975130001
    ALLEN, Nicholas Graham
    18 Rossetti Garden Mansions
    Flood Street
    SW3 5QY Chelsea
    London
    Administrateur
    18 Rossetti Garden Mansions
    Flood Street
    SW3 5QY Chelsea
    London
    United KingdomBritishManager55881390001
    BARLOW, Stephen Charles
    97 Park View
    Kettering Road
    NN3 7UZ Moulton
    Northampton
    Administrateur
    97 Park View
    Kettering Road
    NN3 7UZ Moulton
    Northampton
    BritishSales Director6935980001
    BENSON, Trevor Walker
    The Samlings
    1 Ely Gardens
    CV37 6LW Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Administrateur
    The Samlings
    1 Ely Gardens
    CV37 6LW Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    EnglandBritishCommercial Director36699200002
    FAULKNER, Jeremy David
    Boston House
    Main Street
    OX11 0RZ Chilton
    Oxfordshire
    Administrateur
    Boston House
    Main Street
    OX11 0RZ Chilton
    Oxfordshire
    BritishManaging Director82209540001
    HERMES, Michel
    7 Riversdale Road
    KT7 0QL Thames Ditton
    Surrey
    Administrateur
    7 Riversdale Road
    KT7 0QL Thames Ditton
    Surrey
    BritishSales & Marketing Director14426160001
    LYNE, Michael Charles
    114 High Oak Road
    SG12 7NZ Ware
    Hertfordshire
    Administrateur
    114 High Oak Road
    SG12 7NZ Ware
    Hertfordshire
    BritishSales Director106514980001
    LYON, Geoffrey Thomas
    A V Henri Pirenne 4
    Boite 4
    1180 Brussells
    Belgium
    Administrateur
    A V Henri Pirenne 4
    Boite 4
    1180 Brussells
    Belgium
    BritishDirector Manufacturing And Log34503180001
    MCDERMOTT, Denis David
    13 Imber Park Road
    KT10 8JB Esher
    Surrey
    Administrateur
    13 Imber Park Road
    KT10 8JB Esher
    Surrey
    IrishFinancial Director55115060002
    NEATH, Gavin Ellis
    5 Lebanon Park
    TW1 3DE Twickenham
    Middlesex
    Administrateur
    5 Lebanon Park
    TW1 3DE Twickenham
    Middlesex
    United KingdomBritishManager72160380001
    OPPENHEIM, John Richard
    Shadows
    21 Claremont Lane
    KT10 9DP Esher
    Surrey
    Administrateur
    Shadows
    21 Claremont Lane
    KT10 9DP Esher
    Surrey
    BritishManaging Director52840840002
    PRICE, Robert Michael
    38 Milestone Road
    DA2 6DN Dartford
    Kent
    Administrateur
    38 Milestone Road
    DA2 6DN Dartford
    Kent
    BritishCompany Director10482750001
    RAMSAY, Ian Mcdonald
    5 Oak Grove
    RH14 0DN Loxwood
    West Sussex
    Administrateur
    5 Oak Grove
    RH14 0DN Loxwood
    West Sussex
    BritishDirector99503460001
    RAYMOND, Jean-Louis
    19 Chemin De Lane Cote Du Moulin
    FOREIGN 78620 Letang La Ville
    France
    Administrateur
    19 Chemin De Lane Cote Du Moulin
    FOREIGN 78620 Letang La Ville
    France
    FrenchCompany Chairman15380240001
    RENSHAW, John Harold
    Stonecrop
    Dorking Road Walton On The Hill
    KT20 7TL Tadworth
    Surrey
    Administrateur
    Stonecrop
    Dorking Road Walton On The Hill
    KT20 7TL Tadworth
    Surrey
    BritishCompany Director108470680001
    RENSHAW, Peter James
    Greenaway Warren Drive
    Kingswood
    KT20 6PZ Tadworth
    Surrey
    Administrateur
    Greenaway Warren Drive
    Kingswood
    KT20 6PZ Tadworth
    Surrey
    BritishCompany Director8390120001
    SENDOWSKI, Claude
    20 Rue De La Belle Feuille
    Boulogne
    FOREIGN France
    Administrateur
    20 Rue De La Belle Feuille
    Boulogne
    FOREIGN France
    FrenchDirector36140310001
    SPOONER, Julian Robert Archer
    301 Kings Road
    KT2 5JJ Kingston Upon Thames
    Surrey
    Administrateur
    301 Kings Road
    KT2 5JJ Kingston Upon Thames
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director117770880001
    TAYLOR, Brian
    Rarta Lodge Furze Hill
    KT20 6HB Tadworth
    Surrey
    Administrateur
    Rarta Lodge Furze Hill
    KT20 6HB Tadworth
    Surrey
    BritishCompany Director39670910001
    TERRY, Alan James
    17 Junewood Close
    Woodham
    KT15 3PX Addlestone
    Surrey
    Administrateur
    17 Junewood Close
    Woodham
    KT15 3PX Addlestone
    Surrey
    EnglandBritishAccountant2975130001
    WILLIS, Ronald James
    86 Lovel Avenue
    DA16 3HT Welling
    Kent
    Administrateur
    86 Lovel Avenue
    DA16 3HT Welling
    Kent
    BritishCompany Director10482760001

    CREMANAZE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Fixed and floating charge
    Créé le 31 janv. 2003
    Livré le 04 févr. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transactions
    • 04 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 18 déc. 2001
    Livré le 04 janv. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The land on the south west side of centurion way thamesmead t/n SGL539010. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 janv. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 18 déc. 2001
    Livré le 22 déc. 2001
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 22 déc. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 29 août 1990
    Livré le 13 sept. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings to the south yamton way thamesmead bexley title no:- sgl 539010.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 sept. 1990Enregistrement d'une charge
    • 03 févr. 1995Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 02 mars 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 29 mars 1990
    Livré le 06 avr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank LTD
    Transactions
    • 06 avr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 03 févr. 1995Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 02 mars 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    CREMANAZE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    28 avr. 2008Date of meeting to approve CVA
    29 nov. 2010Date of completion or termination of CVA
    Corporate voluntary arrangement (CVA)
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Freddy Khalastchi
    Harris Lipman Llp 2 Mountview Court
    310 Friern Barnet Lane, Whetstone
    N20 0YZ London
    practitioner
    Harris Lipman Llp 2 Mountview Court
    310 Friern Barnet Lane, Whetstone
    N20 0YZ London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0