CREMANAZE LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | CREMANAZE LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00198371 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CREMANAZE LIMITED ?
Adresse du siège social | 2 Mountview Court 310 Friern Barnet Lane Whetstone N20 0YZ London |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CREMANAZE LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2007 |
Quels sont les derniers dépôts pour CREMANAZE LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |
---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||
Résumé des recettes et paiements du superviseur de l'accord volontaire jusqu'au 29 nov. 2010 | 2 pages | 1.3 | ||
Avis d'achèvement de l'accord volontaire | 8 pages | 1.4 | ||
Résumé des recettes et paiements du superviseur de l'accord volontaire jusqu'au 27 avr. 2010 | 13 pages | 1.3 | ||
Résumé des recettes et paiements du superviseur de l'accord volontaire jusqu'au 27 avr. 2009 | 11 pages | 1.3 | ||
Résumé des recettes et paiements du superviseur de l'accord volontaire jusqu'au 27 avr. 2009 | 11 pages | 1.3 | ||
legacy | 1 pages | 288b | ||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2007 | 19 pages | AA | ||
Avis au registre des sociétés de l'accord volontaire prenant effet | 11 pages | 1.1 | ||
legacy | 1 pages | 287 | ||
legacy | 3 pages | 363a | ||
legacy | 1 pages | 288b | ||
legacy | 2 pages | 288a | ||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2006 | 20 pages | AA | ||
legacy | 1 pages | 288c | ||
legacy | 3 pages | 363a | ||
legacy | 6 pages | 363s | ||
legacy | 1 pages | 288a | ||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2005 | 20 pages | AA | ||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2004 | 19 pages | AA | ||
legacy | 2 pages | 288a | ||
legacy | 7 pages | 363s | ||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2003 | 19 pages | AA |
Qui sont les dirigeants de CREMANAZE LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORMANTON, Tom Frederick William | Secrétaire | Old Rectory Oby NR29 3BP Great Yarmouth Norfolk | British | Director | 82209410001 | |||||
MACK, Timothy John | Administrateur | Brinklow Church Road Mendlesham IP14 5SF Stowmarket Suffolk | England | British | Managing Director | 13782470001 | ||||
NORMANTON, Tom Frederick William | Administrateur | Old Rectory Oby NR29 3BP Great Yarmouth Norfolk | England | British | Director | 82209410001 | ||||
ROSE, Martyn Craig | Administrateur | 39a Limerston Street SW10 0BQ London | British | Director | 75808040001 | |||||
WARD, Edward John | Administrateur | 29 Ivedon Road DA16 1NN Welling Kent | United Kingdom | British | Finance Director | 110326230002 | ||||
AKISTER, John Edward | Secrétaire | Northdown Road DA3 7QW Longfield 56 Kent | British | 133597670001 | ||||||
BURGESS, David Patrick Henry | Secrétaire | Apartment 9 100 Piccadilly W1J 7NH London | British | Solicitor | 124903940001 | |||||
FLOOK, Susan Narelle | Secrétaire | Fern Lodge London Road RG12 6QR Bracknell Berkshire | Australian | 168876340001 | ||||||
MACAULAY, Barbara Scott | Secrétaire | 1 Mayfield Close AL5 3LG Harpenden Hertfordshire | British | 39335990001 | ||||||
NEWICK, Lisa Jane | Secrétaire | 44 Winchendon Road SW6 5DR London | British | Solicitor | 45931180003 | |||||
TERRY, Alan James | Secrétaire | 17 Junewood Close Woodham KT15 3PX Addlestone Surrey | British | Accountant | 2975130001 | |||||
ALLEN, Nicholas Graham | Administrateur | 18 Rossetti Garden Mansions Flood Street SW3 5QY Chelsea London | United Kingdom | British | Manager | 55881390001 | ||||
BARLOW, Stephen Charles | Administrateur | 97 Park View Kettering Road NN3 7UZ Moulton Northampton | British | Sales Director | 6935980001 | |||||
BENSON, Trevor Walker | Administrateur | The Samlings 1 Ely Gardens CV37 6LW Stratford Upon Avon Warwickshire | England | British | Commercial Director | 36699200002 | ||||
FAULKNER, Jeremy David | Administrateur | Boston House Main Street OX11 0RZ Chilton Oxfordshire | British | Managing Director | 82209540001 | |||||
HERMES, Michel | Administrateur | 7 Riversdale Road KT7 0QL Thames Ditton Surrey | British | Sales & Marketing Director | 14426160001 | |||||
LYNE, Michael Charles | Administrateur | 114 High Oak Road SG12 7NZ Ware Hertfordshire | British | Sales Director | 106514980001 | |||||
LYON, Geoffrey Thomas | Administrateur | A V Henri Pirenne 4 Boite 4 1180 Brussells Belgium | British | Director Manufacturing And Log | 34503180001 | |||||
MCDERMOTT, Denis David | Administrateur | 13 Imber Park Road KT10 8JB Esher Surrey | Irish | Financial Director | 55115060002 | |||||
NEATH, Gavin Ellis | Administrateur | 5 Lebanon Park TW1 3DE Twickenham Middlesex | United Kingdom | British | Manager | 72160380001 | ||||
OPPENHEIM, John Richard | Administrateur | Shadows 21 Claremont Lane KT10 9DP Esher Surrey | British | Managing Director | 52840840002 | |||||
PRICE, Robert Michael | Administrateur | 38 Milestone Road DA2 6DN Dartford Kent | British | Company Director | 10482750001 | |||||
RAMSAY, Ian Mcdonald | Administrateur | 5 Oak Grove RH14 0DN Loxwood West Sussex | British | Director | 99503460001 | |||||
RAYMOND, Jean-Louis | Administrateur | 19 Chemin De Lane Cote Du Moulin FOREIGN 78620 Letang La Ville France | French | Company Chairman | 15380240001 | |||||
RENSHAW, John Harold | Administrateur | Stonecrop Dorking Road Walton On The Hill KT20 7TL Tadworth Surrey | British | Company Director | 108470680001 | |||||
RENSHAW, Peter James | Administrateur | Greenaway Warren Drive Kingswood KT20 6PZ Tadworth Surrey | British | Company Director | 8390120001 | |||||
SENDOWSKI, Claude | Administrateur | 20 Rue De La Belle Feuille Boulogne FOREIGN France | French | Director | 36140310001 | |||||
SPOONER, Julian Robert Archer | Administrateur | 301 Kings Road KT2 5JJ Kingston Upon Thames Surrey | England | British | Company Director | 117770880001 | ||||
TAYLOR, Brian | Administrateur | Rarta Lodge Furze Hill KT20 6HB Tadworth Surrey | British | Company Director | 39670910001 | |||||
TERRY, Alan James | Administrateur | 17 Junewood Close Woodham KT15 3PX Addlestone Surrey | England | British | Accountant | 2975130001 | ||||
WILLIS, Ronald James | Administrateur | 86 Lovel Avenue DA16 3HT Welling Kent | British | Company Director | 10482760001 |
CREMANAZE LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Fixed and floating charge | Créé le 31 janv. 2003 Livré le 04 févr. 2003 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 18 déc. 2001 Livré le 04 janv. 2002 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The land on the south west side of centurion way thamesmead t/n SGL539010. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 18 déc. 2001 Livré le 22 déc. 2001 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 29 août 1990 Livré le 13 sept. 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Land and buildings to the south yamton way thamesmead bexley title no:- sgl 539010. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 29 mars 1990 Livré le 06 avr. 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
CREMANAZE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Corporate voluntary arrangement (CVA) |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0