BERHAM PROPERTY COMPANY LIMITED

BERHAM PROPERTY COMPANY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBERHAM PROPERTY COMPANY LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00199108
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BERHAM PROPERTY COMPANY LIMITED ?

    • (9305) /

    Où se situe BERHAM PROPERTY COMPANY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    8 Kpmg Restructuring
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BERHAM PROPERTY COMPANY LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BERKELEY PROPERTY COMPANY LIMITED12 sept. 198512 sept. 1985
    BERKELEY HAMBRO PROPERTY LIMITED07 juil. 192407 juil. 1924

    Quels sont les derniers comptes de BERHAM PROPERTY COMPANY LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2007

    Quels sont les derniers dépôts pour BERHAM PROPERTY COMPANY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 26 oct. 2010

    5 pages4.68

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    3 pages4.71

    Cessation de la nomination de John Woollacott en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Ordonnance du tribunal d'insolvabilité

    Court order insolvency:replacement of liquidator
    8 pagesLIQ MISC OC

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    1 pages4.40

    Changement d'adresse du siège social de 16 Palace Street London SW1E 5JQ le 03 nov. 2009

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 27 oct. 2009

    LRESSP

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288b

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    15 pagesAA

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2006

    15 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de BERHAM PROPERTY COMPANY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ALLINSON, Bernadette
    Street 5
    Meadows 1
    Dubai
    Villa 31,
    United Arab Emirates
    Secrétaire
    Street 5
    Meadows 1
    Dubai
    Villa 31,
    United Arab Emirates
    Other116264270002
    DALGAARD, Flemming
    8 Netherton Road
    St Margarets
    TW1 1LZ Twickenham
    Middlesex
    Administrateur
    8 Netherton Road
    St Margarets
    TW1 1LZ Twickenham
    Middlesex
    United KingdomDanishSvp & Managing Director, Europe116091010001
    WALKER, Peter Arthur
    64 Connaught Avenue
    Chingford
    E4 7AA London
    Administrateur
    64 Connaught Avenue
    Chingford
    E4 7AA London
    United KingdomBritishChartered Accountant708770001
    DAMLE, Sameer Dileep
    76 St. Saviours Wharf
    8 Shad Thames
    SE1 2YP London
    Secrétaire
    76 St. Saviours Wharf
    8 Shad Thames
    SE1 2YP London
    British121281830001
    LAVER, John Michael
    Brook House Homestead Road
    TN8 6JD Edenbridge
    Kent
    Secrétaire
    Brook House Homestead Road
    TN8 6JD Edenbridge
    Kent
    BritishCompany Secretary8207040001
    LEONARD, David Jack
    Flat 10
    10 Abbey Orchard Street
    SW1P 2JP London
    Secrétaire
    Flat 10
    10 Abbey Orchard Street
    SW1P 2JP London
    BritishChartered Secretary30168510002
    OWEN, Michael
    1 Thornfield Gardens
    Sandown Park
    TN2 4RZ Tunbridge Wells
    Kent
    Secrétaire
    1 Thornfield Gardens
    Sandown Park
    TN2 4RZ Tunbridge Wells
    Kent
    British10057640001
    REES, Nicholas Haydn Glyndwr
    80 Frankfurt Road
    SE24 9NY London
    Secrétaire
    80 Frankfurt Road
    SE24 9NY London
    BritishSolicitor115881230001
    SCOTT, Sandra
    40 The Grove
    Ealing
    W5 5LH London
    Secrétaire
    40 The Grove
    Ealing
    W5 5LH London
    BritishChartered Secretary75631110001
    CROSSMAN, John Malcolm, Lieutenant Commander
    The Old Vicarage
    Church Hill Ramsey
    CO12 5EU Harwich
    Essex
    Administrateur
    The Old Vicarage
    Church Hill Ramsey
    CO12 5EU Harwich
    Essex
    EnglandBritishCompany Secretary41093970001
    GRADON, Richard Michael
    Summer House
    18 Granville Road
    RH8 0DA Oxted
    Surrey
    Administrateur
    Summer House
    18 Granville Road
    RH8 0DA Oxted
    Surrey
    United KingdomBritishSolicitor48859920002
    LAVER, John Michael
    Brook House Homestead Road
    TN8 6JD Edenbridge
    Kent
    Administrateur
    Brook House Homestead Road
    TN8 6JD Edenbridge
    Kent
    United KingdomBritishCompany Secretary8207040001
    LEONARD, David Jack
    Flat 10
    10 Abbey Orchard Street
    SW1P 2JP London
    Administrateur
    Flat 10
    10 Abbey Orchard Street
    SW1P 2JP London
    EnglandBritishChartered Secretary30168510002
    MONTEITH, Nicholas John
    45 Mayfair Avenue
    KT4 7SH Worcester Park
    Surrey
    Administrateur
    45 Mayfair Avenue
    KT4 7SH Worcester Park
    Surrey
    BritishChartered Accountant39120850002
    MOORE, Michael Ellis
    Dp World
    Dubai
    United Arab Emirates
    Administrateur
    Dp World
    Dubai
    United Arab Emirates
    AmericanSenior Vice President114436710001
    OWEN, Michael
    1 Thornfield Gardens
    Sandown Park
    TN2 4RZ Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    1 Thornfield Gardens
    Sandown Park
    TN2 4RZ Tunbridge Wells
    Kent
    BritishChartered Accountant10057640001
    SCOTT, Sandra
    40 The Grove
    Ealing
    W5 5LH London
    Administrateur
    40 The Grove
    Ealing
    W5 5LH London
    EnglandBritishChartered Secretary75631110001
    SHAW, Derek
    35 Granville Road
    RH8 0BX Oxted
    Surrey
    Administrateur
    35 Granville Road
    RH8 0BX Oxted
    Surrey
    EnglandBritishAccountant114437060001
    WALTERS, Patrick William
    Tucker Mill
    Sway Road
    SO41 8NN Lymington
    Administrateur
    Tucker Mill
    Sway Road
    SO41 8NN Lymington
    EnglandBritishDirector154424260001
    WOOLLACOTT, John Mark
    Villiers Avenue
    Surbiton
    KT5 8BE Surrey
    105
    United Kingdom
    Administrateur
    Villiers Avenue
    Surbiton
    KT5 8BE Surrey
    105
    United Kingdom
    AustralianAccountant121666370002

    BERHAM PROPERTY COMPANY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Supplemental trust deed
    Créé le 31 janv. 1985
    Livré le 04 févr. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £1,875,000 6% first mortgage debenture stock 1988/93 due from the company to the chargee secured by a trust deed 7-11-63 and various deeds supplemental thereeto
    Brèves mentions
    F/Hold land and buildings k/as auckland house new zealand avenue walton on thames surrey title nos SY129807 and SY33519.
    Personnes ayant droit
    • The Norwich Union Life
    Transactions
    • 04 févr. 1985Enregistrement d'une charge
    • 23 oct. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 16 mars 1984
    Livré le 03 avr. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or sterling guarantee trust PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    F/Hold land abutting wellington house, new zealand avenue, walton-upon-thames, surrey. Title no- sy 161095.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 03 avr. 1984Enregistrement d'une charge
    • 23 oct. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Supplemental trust deed
    Créé le 16 mars 1984
    Livré le 23 mars 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £1,875,000 6 percent first mortgage debenture stock 1988/93 and all ot her moneys intended to be secured by a trust deed dated 7-11-63 and deeds supplemental thereto including this deed
    Brèves mentions
    F/Hold wellington house new zealand avenue walton on thames surrey. Title no SY161095 and car parking area abutting north western boundary of the property together with all buildings and erections, all fixed plant, & machinery and landlords fixtures (but excluding tenants and trade fixtures).
    Personnes ayant droit
    • The Norwich Union Life Insurance Society
    Transactions
    • 23 mars 1984Enregistrement d'une charge
    • 23 oct. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Further charge
    Créé le 16 nov. 1928
    Livré le 06 nov. 1928
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £175,000
    Brèves mentions
    Nos. 162 to 202 (even nos.) great portland st. Nos.75 To 102 (consecuti ve nos)bolsovece st. Nos.45,46 & 47 clipstol st. & 1 to 76 (consecutive nos. Except no.13) "portland court" great portland st. All in london.
    Personnes ayant droit
    • G.B. Clark/E. Goodship/H.C. Watson /the Trustees of the Royal Liver Friendly Soc.
    Transactions
    • 06 nov. 1928Enregistrement d'une charge
    • 23 oct. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Instrument of sub-charge under the land registration act, 1925.
    Créé le 29 juin 1927
    Livré le 08 juil. 1927
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Charge under the land registration act, 1925 dated 11.4.1927 nos. 20652 registered on the 12TH april 1927 in respect of title nos.308486 And 308487 affecting property block 2 (31-50) and block 1 (1-30) palace mansions hammersmith rd.fulham S.W. to secure £4,750. the debt or sum of £4,750 due & owing on the security of the charge above mentioned & all interest thereon & the benefit of all securities for the same & all powers & remedies for recovery thereof.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 08 juil. 1927Enregistrement d'une charge
    • 23 oct. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    BERHAM PROPERTY COMPANY LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    27 oct. 2009Commencement of winding up
    22 févr. 2011Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Jeremy Simon Spratt
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Finbarr O'Connell
    Kpmg Corporate Recovery
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    Kpmg Corporate Recovery
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    John David Thomas Milsom
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0