VOLVO TRUCK AND BUS (SOUTHERN ENGLAND) LIMITED

VOLVO TRUCK AND BUS (SOUTHERN ENGLAND) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéVOLVO TRUCK AND BUS (SOUTHERN ENGLAND) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00215909
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de VOLVO TRUCK AND BUS (SOUTHERN ENGLAND) LIMITED ?

    • (5010) /

    Où se situe VOLVO TRUCK AND BUS (SOUTHERN ENGLAND) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Wedgnock Lane
    Warwick
    CV34 5YA Warwickshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de VOLVO TRUCK AND BUS (SOUTHERN ENGLAND) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PRINCES COMMERCIALS (SOUTHAMPTON) LIMITED07 févr. 198507 févr. 1985
    J.H.PRINCE & CO.,LIMITED27 août 192627 août 1926

    Quels sont les derniers comptes de VOLVO TRUCK AND BUS (SOUTHERN ENGLAND) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour VOLVO TRUCK AND BUS (SOUTHERN ENGLAND) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    3 pages4.71

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 26 mai 2011

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 mai 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 juin 2010

    État du capital au 14 juin 2010

    • Capital: GBP 15,500
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    7 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    10 pagesAA

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    8 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2006

    16 pagesAA

    legacy

    6 pages363s

    legacy

    1 pages122

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    7 pages363s

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2005

    20 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2004

    21 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    8 pages363s

    Qui sont les dirigeants de VOLVO TRUCK AND BUS (SOUTHERN ENGLAND) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MCGREAL, Anthony Gerard
    7 Abbey Close
    B49 5QW Alcester
    Warwickshire
    Secrétaire
    7 Abbey Close
    B49 5QW Alcester
    Warwickshire
    British13719400003
    HUNTER, David
    Loxley Heights
    Banbury Road
    CV37 7HX Stratford Upon Avon
    3
    Warwickshire
    Administrateur
    Loxley Heights
    Banbury Road
    CV37 7HX Stratford Upon Avon
    3
    Warwickshire
    EnglandAustralian107771720003
    PRINCE, Hazel Valerie
    Yew Tree Cottage
    Church Lane
    SO51 0QH Braishfield
    Hampshire
    Secrétaire
    Yew Tree Cottage
    Church Lane
    SO51 0QH Braishfield
    Hampshire
    British8759860001
    BENZOW, Carl Jan Mikael
    Avenue De L'Ete 57
    Waterloo
    1410
    Belgium
    Administrateur
    Avenue De L'Ete 57
    Waterloo
    1410
    Belgium
    Swedish87936020001
    BRANDTZAEG, Bernt
    1 The Orchards
    Wilmcote
    CV37 9XF Stratford Upon Avon
    Administrateur
    1 The Orchards
    Wilmcote
    CV37 9XF Stratford Upon Avon
    Norwegian566080001
    BRANDTZAEG, Bernt
    1 The Orchards
    Wilmcote
    CV37 9XF Stratford Upon Avon
    Administrateur
    1 The Orchards
    Wilmcote
    CV37 9XF Stratford Upon Avon
    Norwegian566080001
    FROMMELT, Otto Christian
    87 Northumberland Road
    CV32 6HQ Leamington Spa
    Warwickshire
    Administrateur
    87 Northumberland Road
    CV32 6HQ Leamington Spa
    Warwickshire
    Liechtenstein Citizen79591040001
    HENDRIKSE, Albert Johannes
    97 Northumberland Road
    CV32 6HQ Leamington Spa
    Warwickshire
    Administrateur
    97 Northumberland Road
    CV32 6HQ Leamington Spa
    Warwickshire
    Dutch73122500002
    HINRICH, Michael Colin
    Cherry Tree Cottage
    Park Lane Great Alne
    B49 6HS Alcester
    Warwickshire
    Administrateur
    Cherry Tree Cottage
    Park Lane Great Alne
    B49 6HS Alcester
    Warwickshire
    British46812470001
    JOHNSON, Stephen Andrew
    Hasty Leys Farm
    Brailes
    OX15 5AF Banbury
    Oxfordshire
    Administrateur
    Hasty Leys Farm
    Brailes
    OX15 5AF Banbury
    Oxfordshire
    United KingdomBritish31861840002
    MARTIN, Malcolm
    The Mews
    233 Nithsdale Road
    G41 5PY Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    The Mews
    233 Nithsdale Road
    G41 5PY Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritish121711020001
    OLKINUORA, Markku Heikki
    97 Northumberland Road
    CV32 6HQ Leamington Spa
    Warwickshire
    Administrateur
    97 Northumberland Road
    CV32 6HQ Leamington Spa
    Warwickshire
    Finnish97638770003
    PRINCE, Hazel Valerie
    Yew Tree Cottage
    Church Lane
    SO51 0QH Braishfield
    Hampshire
    Administrateur
    Yew Tree Cottage
    Church Lane
    SO51 0QH Braishfield
    Hampshire
    British8759860001
    PRINCE, Henry John
    The Lilacs Noads Way
    Dibden Purlieu
    SO45 4PD Southampton
    Hampshire
    Administrateur
    The Lilacs Noads Way
    Dibden Purlieu
    SO45 4PD Southampton
    Hampshire
    British8759890001
    PRINCE, Marjorie Constance
    The Lilacs Noads Way
    Dibden Purlieu
    SO45 4PD Southampton
    Hampshire
    Administrateur
    The Lilacs Noads Way
    Dibden Purlieu
    SO45 4PD Southampton
    Hampshire
    British8759870001
    PRINCE, Michael John
    Yew Tree Cottage
    Church Lane
    SO51 0QH Braishfield
    Hampshire
    Administrateur
    Yew Tree Cottage
    Church Lane
    SO51 0QH Braishfield
    Hampshire
    EnglandBritish8759880001
    REBELING, Orjan Christer Ewald
    Tresco
    154a Loxley Road
    CV37 7DT Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Administrateur
    Tresco
    154a Loxley Road
    CV37 7DT Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Swedish40658190001
    ROBINSON, Alexander William
    Little Oak
    Norton Grange, Little Kineton
    CV35 0DP Warwick
    Warwickshire
    Administrateur
    Little Oak
    Norton Grange, Little Kineton
    CV35 0DP Warwick
    Warwickshire
    British84166850001
    RYDIN, Jan Staffan
    Tresco 154a Loxley Road
    CV37 7DT Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Administrateur
    Tresco 154a Loxley Road
    CV37 7DT Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Swedish145501470001
    SMITH, David Michael
    Longstone
    Myddle Wood, Myddle
    SY4 3RY Shrewsbury
    Shropshire
    Administrateur
    Longstone
    Myddle Wood, Myddle
    SY4 3RY Shrewsbury
    Shropshire
    EnglandEnglish86324790001
    SMITH, David Michael
    Longstone
    Myddle Wood, Myddle
    SY4 3RY Shrewsbury
    Shropshire
    Administrateur
    Longstone
    Myddle Wood, Myddle
    SY4 3RY Shrewsbury
    Shropshire
    EnglandEnglish86324790001
    SVENSSON, Tommy Ebenhard
    Avon House High Street
    Welford On Avon
    CV37 8EA Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Administrateur
    Avon House High Street
    Welford On Avon
    CV37 8EA Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Swedish56801510003
    TODD, Thomas Kevin
    The Mount 198 High Street
    Henley In Arden
    B95 5HT Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    The Mount 198 High Street
    Henley In Arden
    B95 5HT Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritish194024730001

    VOLVO TRUCK AND BUS (SOUTHERN ENGLAND) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 02 nov. 1992
    Livré le 05 nov. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (See form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Volvo Truck Finance (Great Britain) Limited
    Transactions
    • 05 nov. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 sept. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 09 juil. 1990
    Livré le 12 juil. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan agreement dated 21.4.37
    Brèves mentions
    Fixed charge over all vehicles plant machinery & equipment, the benefit of all contracts for the sale rental etc. all book & other debts in respect of the vehicles or contracts.
    Personnes ayant droit
    • Unibank PLC
    Transactions
    • 12 juil. 1990Enregistrement d'une charge
    • 01 août 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 29 avr. 1988
    Livré le 13 mai 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land adjoining repcon premises, test lane, nursling, southampton hampshire. Title no hp 152637.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 mai 1988Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 02 févr. 1988
    Livré le 10 févr. 1988
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Repcon premises test lane, nursling, southampton, hampshire T.no:- HP152637.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 févr. 1988Enregistrement d'une charge
    Fixed stock and book debt charge
    Créé le 20 mai 1987
    Livré le 21 mai 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a loan agreement dated 21.4.87 and all moneys due or to become due under the terms of the charge.
    Brèves mentions
    By way of fixed charge all the vehicles plant machinery, equipment. The benefit of all contracts for the sale rental conditional sale hire purchase or other finance or credit arrangements all book and other debts owing to the company (see 395 for further details).
    Personnes ayant droit
    • London Interstate Bank Limited
    Transactions
    • 21 mai 1987Enregistrement d'une charge
    • 01 août 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 05 août 1982
    Livré le 07 août 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £100,000 all monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therin to the chargee
    Brèves mentions
    Undertaking and property whatsoever and wheresoever both present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Volvo Trucko (Great Britain) Limited
    Transactions
    • 07 août 1982Enregistrement d'une charge
    Charge
    Créé le 18 sept. 1981
    Livré le 28 sept. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H corbridge depot beddow way, aylesford kent as comprised in a transfer dated 18/9/81.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 28 sept. 1981Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 29 juil. 1980
    Livré le 01 août 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Floating charge over the company's undertaking & all its property & assets whatsoever.
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central Limited
    Transactions
    • 01 août 1980Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 21 janv. 1980
    Livré le 28 janv. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and bldgs on east side of new road, newhaven, east sussex title no:- esx 26434.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 28 janv. 1980Enregistrement d'une charge
    Guarantee & debenture
    Créé le 12 avr. 1979
    Livré le 03 mai 1979
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Fixed & floating charges on undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital, with all buildings fixtures, fuxed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 03 mai 1979Enregistrement d'une charge
    • 17 sept. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    VOLVO TRUCK AND BUS (SOUTHERN ENGLAND) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    26 mai 2011Commencement of winding up
    20 déc. 2011Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Stewart Macdonald
    Scott-Moncrieff Chartered Accountants
    25 Bothwell Street
    G2 6NL Glasgow
    practitioner
    Scott-Moncrieff Chartered Accountants
    25 Bothwell Street
    G2 6NL Glasgow

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0