LAVA CAPITAL UK LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLAVA CAPITAL UK LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00224601
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LAVA CAPITAL UK LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe LAVA CAPITAL UK LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Chancery House
    30 St Johns Road
    GU21 7SA Woking
    Surrey
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de LAVA CAPITAL UK LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SHELLEY OAK LIMITED15 déc. 200815 déc. 2008
    SHELLEY OAK PLC20 mars 200620 mars 2006
    QUINCUNX PLC11 janv. 199511 janv. 1995
    SR RESTAURANT PLC10 août 199410 août 1994
    SCOTT'S RESTAURANT, PUBLIC LIMITED COMPANY22 sept. 192722 sept. 1927

    Quels sont les derniers comptes de LAVA CAPITAL UK LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour LAVA CAPITAL UK LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    2 pagesDS01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2020

    14 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 juin 2020 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2019

    14 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 juin 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2018

    14 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 juin 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2017

    15 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 juin 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2016

    14 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 juin 2016 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 10 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 12 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 11 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 13 en totalité

    4 pagesMR04

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2015

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 juin 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 août 2015

    État du capital au 12 août 2015

    • Capital: GBP 300,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2014

    19 pagesAA

    Cessation de la nomination de Philip James Curwen en tant que secrétaire le 29 juin 2013

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 oct. 2014

    État du capital au 09 oct. 2014

    • Capital: GBP 300,000
    SH01

    Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2013 au 30 juin 2014

    1 pagesAA01

    Cessation de la nomination de Snaebjorn Sigurdsson en tant que directeur le 26 juin 2014

    1 pagesTM01

    Nomination de So Director Limited en tant qu'administrateur le 26 juin 2014

    2 pagesAP02

    Qui sont les dirigeants de LAVA CAPITAL UK LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PERRY, Alan
    30 St Johns Road
    GU21 7SA Woking
    Chancery House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    30 St Johns Road
    GU21 7SA Woking
    Chancery House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish125162690001
    SO DIRECTOR LIMITED
    30 St Johns Road
    GU21 7SA Woking
    Chancery House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    30 St Johns Road
    GU21 7SA Woking
    Chancery House
    Surrey
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement06045490
    190248950001
    BLAND, Geoffrey Charles
    1 Hollowmead
    Claverham
    BS49 4LF Bristol
    Secrétaire
    1 Hollowmead
    Claverham
    BS49 4LF Bristol
    British1763600001
    CURWEN, Philip James
    High Street
    Knaphill
    GU21 2PG Woking
    1
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    High Street
    Knaphill
    GU21 2PG Woking
    1
    Surrey
    United Kingdom
    155749400001
    CURWEN, Philip James
    High Street
    Knaphill
    GU21 2PG Woking
    1
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    High Street
    Knaphill
    GU21 2PG Woking
    1
    Surrey
    United Kingdom
    British161979510001
    FOKES, Brian Ronald
    34 Rowan Way
    Rottingdean
    BN2 7FP Brighton
    East Sussex
    Secrétaire
    34 Rowan Way
    Rottingdean
    BN2 7FP Brighton
    East Sussex
    British14013980001
    PRICHARD-JONES, Kenneth Victor
    1 Field Place
    Broadbridge Heath
    RH12 3PB Horsham
    West Sussex
    Secrétaire
    1 Field Place
    Broadbridge Heath
    RH12 3PB Horsham
    West Sussex
    British37769570002
    NETWORK SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Field Place
    Broadbridge Heath
    RH12 3PB Horsham
    West Sussex
    Secrétaire
    Field Place
    Broadbridge Heath
    RH12 3PB Horsham
    West Sussex
    50353670001
    BENNISON, Peter James
    5 Ashley Close
    NW4 1PH London
    Administrateur
    5 Ashley Close
    NW4 1PH London
    EnglandBritish88640070003
    BLAND, Geoffrey Charles
    1 Hollowmead
    Claverham
    BS49 4LF Bristol
    Administrateur
    1 Hollowmead
    Claverham
    BS49 4LF Bristol
    EnglandBritish1763600001
    HELGASON, Arni
    19
    Reykjavik
    Kambasel
    109
    Iceland
    Administrateur
    19
    Reykjavik
    Kambasel
    109
    Iceland
    IcelandIcelander137732190002
    KERMAN, Anthony David
    5 Saint Jamess Square
    SW1Y 4JU London
    Administrateur
    5 Saint Jamess Square
    SW1Y 4JU London
    United KingdomBritish72531870002
    KERMAN, Isidore
    11 Mansfield Street
    W1M 0AH London
    Administrateur
    11 Mansfield Street
    W1M 0AH London
    British35542530001
    KERMAN, Nicholas
    25 Eaton Mews South
    SW1W 9HR London
    Administrateur
    25 Eaton Mews South
    SW1W 9HR London
    EnglandBritish55578530001
    LORENZ, Robert Jacques
    97 St Johns Wood Terrace
    NW8 6PP London
    Administrateur
    97 St Johns Wood Terrace
    NW8 6PP London
    British3397220001
    OSBORNE, Clarke Anthony
    1 Malthouse Barn
    Barn Lane Chelwood
    BS18 4NN Bristol
    Administrateur
    1 Malthouse Barn
    Barn Lane Chelwood
    BS18 4NN Bristol
    British48713080003
    PRICHARD JONES, Kenneth Victor
    Field Place
    Broadbridge Heath
    RH12 3PB Horsham
    West Sussex
    Administrateur
    Field Place
    Broadbridge Heath
    RH12 3PB Horsham
    West Sussex
    United KingdomBritish118944980001
    PRICHARD JONES, Sebastian James
    Flat 4
    26/27 Great Tower Street
    EC3R 5AQ London
    Administrateur
    Flat 4
    26/27 Great Tower Street
    EC3R 5AQ London
    EnglandBritish69343350002
    PRICHARD-JONES, Dagmar Eve
    Field Place
    Broadbridge Heath
    RH12 3PB Horsham
    West Sussex
    Administrateur
    Field Place
    Broadbridge Heath
    RH12 3PB Horsham
    West Sussex
    British6556330001
    PRICHARD-JONES, Kenneth Victor
    1 Field Place
    Broadbridge Heath
    RH12 3PB Horsham
    West Sussex
    Administrateur
    1 Field Place
    Broadbridge Heath
    RH12 3PB Horsham
    West Sussex
    British37769570002
    SCHINDLER, Darren
    86 Stag Leys
    KT21 2TL Ashtead
    Surrey
    Administrateur
    86 Stag Leys
    KT21 2TL Ashtead
    Surrey
    British118944850001
    SIGURDSSON, Snaebjorn
    Kirkjusandi 2
    155 Reyjavik
    Islandsbanki Hf
    Iceland
    Administrateur
    Kirkjusandi 2
    155 Reyjavik
    Islandsbanki Hf
    Iceland
    IcelandIcelandic168776090001
    COLERIDGE PARTNERS LLP
    Field Place
    Broadbridge Heath
    RH12 3PB Horsham
    West Sussex
    Administrateur
    Field Place
    Broadbridge Heath
    RH12 3PB Horsham
    West Sussex
    120033030001
    CONSOLIDATED HOLDINGS PLC
    PO BOX 134 4th North Suite
    Town Mills Trinity Square
    GY1 3HN St Peter Port Guernsey
    Channel Islands
    Administrateur
    PO BOX 134 4th North Suite
    Town Mills Trinity Square
    GY1 3HN St Peter Port Guernsey
    Channel Islands
    109847110001
    DRAGON DIRECTORS LIMITED
    Field Place
    Broadbridge Heath
    RH12 3PB Horsham
    West Sussex
    Administrateur
    Field Place
    Broadbridge Heath
    RH12 3PB Horsham
    West Sussex
    85218910001
    ENTERPRISE CORPORATION
    P O Box 556 Charlestown
    Nevis
    West Indies
    Administrateur
    P O Box 556 Charlestown
    Nevis
    West Indies
    52245280001
    MANAGEMENT CORPORATION
    P O Box 556
    Charlestown
    Nevis
    West Indies
    Administrateur
    P O Box 556
    Charlestown
    Nevis
    West Indies
    51797180001
    STJORNARMENN ENF
    Skofarhlid 12
    FOREIGN Reykjavik
    105
    Iceland
    Administrateur
    Skofarhlid 12
    FOREIGN Reykjavik
    105
    Iceland
    126702600001
    STJORNARZ EHF
    Borgartun 18,
    FOREIGN Reykjavik
    105
    Iceland
    Administrateur
    Borgartun 18,
    FOREIGN Reykjavik
    105
    Iceland
    120033190001
    STJORNARZ EHF
    Borgartun 18,
    Reykjavik
    105
    Iceland
    Administrateur
    Borgartun 18,
    Reykjavik
    105
    Iceland
    120033190001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur LAVA CAPITAL UK LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Jason Scott Haigh
    CM23 4FS Bishops Stortford
    19 Ploughmans Close
    Hertfordshire
    England
    06 avr. 2016
    CM23 4FS Bishops Stortford
    19 Ploughmans Close
    Hertfordshire
    England
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.
    Mr Christopher James Duncan Mcdougall
    30 St Johns Road
    GU21 7SA Woking
    Chancery House
    Surrey
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    30 St Johns Road
    GU21 7SA Woking
    Chancery House
    Surrey
    United Kingdom
    Non
    Nationalité: Australian
    Pays de résidence: Australia
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.

    LAVA CAPITAL UK LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of priorities containing a charging clause
    Créé le 03 juil. 2009
    Livré le 21 juil. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the borrowers to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Any money or assets which the company receives in contravention of the deed which has not been agreed by the senior creditor see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 21 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mai 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of priorities
    Créé le 31 mars 2008
    Livré le 09 avr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from consero homes dartnell ave limited to the chargee and the senior creditor not exceeding £4,205,000 under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Any money or assets which the company receives in contravention of the deed, which has not been agreed by the senior creditor see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 09 avr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mai 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of priorities
    Créé le 24 oct. 2007
    Livré le 01 nov. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from consero more lane limited (the borrower) to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Any money or assets which the company receives. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 01 nov. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mai 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture and charge
    Créé le 12 mars 2007
    Livré le 29 mars 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All assets and undertaking of the company including uncalled capital and including all monies due under and all security for loans made by the company from time to time.
    Personnes ayant droit
    • Sparisjodur Velstjora
    Transactions
    • 29 mars 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mai 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 18 août 1992
    Livré le 21 août 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage bristol lawn tennis & squash centre, redland green, redland, bristol by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights affecting or concerning the property the plant machinery and fixtures and fittings, furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business of a licenced publican etc the benefit of all licences (see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 21 août 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 sept. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 31 mars 1992
    Livré le 04 avr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 04 avr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 juin 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge of licensed premises
    Créé le 31 mars 1992
    Livré le 04 avr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and buildings k/a 1 pont street l/b of kensington and chelsea, greater london title no. 334759 fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment the goodwill of the business the benefit of all justices, excise or other licences (see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 04 avr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 sept. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 18 oct. 1991
    Livré le 07 nov. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and buildings k/a 4-7 (inclusive) victoria buildings, terminus place, l/b of city of westminster, greater london, title no. 353505 fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture andequipment.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 07 nov. 1991Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 sept. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 02 mars 1987
    Livré le 12 mars 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Mirabelle restaurant 56 curzon street westminster fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 12 mars 1987Enregistrement d'une charge
    • 25 janv. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 02 mars 1987
    Livré le 12 mars 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Flat 9, 56 curzon street westminster fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipement.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 12 mars 1987Enregistrement d'une charge
    • 25 mai 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 27 févr. 1987
    Livré le 02 mars 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £1,200,000 and all other moneys due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    F/H premises at pickering place vaults (title no 106860) l/h premises at 5 st.jame's street (title no ln U04252) l/h premises at 4/7 victoria buildings (title no ln 65915). (see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Mr L Muller
    Transactions
    • 02 mars 1987Enregistrement d'une charge
    • 28 nov. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 26 janv. 1984
    Livré le 27 janv. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 81 & 83 buckingham alace road and 164 victoria street, london SW1 title no. 249201.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 27 janv. 1984Enregistrement d'une charge
    • 05 déc. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 10 janv. 1966
    Livré le 12 janv. 1966
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £150,000
    Brèves mentions
    1 & 2 great windmill street 18, 19, 20 coventry street W1.
    Personnes ayant droit
    • Legal & General Assurance Society LTD
    Transactions
    • 12 janv. 1966Enregistrement d'une charge
    • 25 mai 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0