LAVA CAPITAL UK LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | LAVA CAPITAL UK LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00224601 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe LAVA CAPITAL UK LIMITED ?
| Adresse du siège social | Chancery House 30 St Johns Road GU21 7SA Woking Surrey |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de LAVA CAPITAL UK LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2020 |
Quels sont les derniers dépôts pour LAVA CAPITAL UK LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 2 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2020 | 14 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 juin 2020 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2019 | 14 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 juin 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2018 | 14 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 juin 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2017 | 15 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 juin 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2016 | 14 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 juin 2016 avec mises à jour | 6 pages | CS01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 10 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 12 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 11 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 13 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2015 | 14 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 juin 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 30 juin 2014 | 19 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Philip James Curwen en tant que secrétaire le 29 juin 2013 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 juin 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2013 au 30 juin 2014 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Snaebjorn Sigurdsson en tant que directeur le 26 juin 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de So Director Limited en tant qu'administrateur le 26 juin 2014 | 2 pages | AP02 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de LAVA CAPITAL UK LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERRY, Alan | Administrateur | 30 St Johns Road GU21 7SA Woking Chancery House Surrey United Kingdom | England | British | 125162690001 | |||||||||
| SO DIRECTOR LIMITED | Administrateur | 30 St Johns Road GU21 7SA Woking Chancery House Surrey United Kingdom |
| 190248950001 | ||||||||||
| BLAND, Geoffrey Charles | Secrétaire | 1 Hollowmead Claverham BS49 4LF Bristol | British | 1763600001 | ||||||||||
| CURWEN, Philip James | Secrétaire | High Street Knaphill GU21 2PG Woking 1 Surrey United Kingdom | 155749400001 | |||||||||||
| CURWEN, Philip James | Secrétaire | High Street Knaphill GU21 2PG Woking 1 Surrey United Kingdom | British | 161979510001 | ||||||||||
| FOKES, Brian Ronald | Secrétaire | 34 Rowan Way Rottingdean BN2 7FP Brighton East Sussex | British | 14013980001 | ||||||||||
| PRICHARD-JONES, Kenneth Victor | Secrétaire | 1 Field Place Broadbridge Heath RH12 3PB Horsham West Sussex | British | 37769570002 | ||||||||||
| NETWORK SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire | Field Place Broadbridge Heath RH12 3PB Horsham West Sussex | 50353670001 | |||||||||||
| BENNISON, Peter James | Administrateur | 5 Ashley Close NW4 1PH London | England | British | 88640070003 | |||||||||
| BLAND, Geoffrey Charles | Administrateur | 1 Hollowmead Claverham BS49 4LF Bristol | England | British | 1763600001 | |||||||||
| HELGASON, Arni | Administrateur | 19 Reykjavik Kambasel 109 Iceland | Iceland | Icelander | 137732190002 | |||||||||
| KERMAN, Anthony David | Administrateur | 5 Saint Jamess Square SW1Y 4JU London | United Kingdom | British | 72531870002 | |||||||||
| KERMAN, Isidore | Administrateur | 11 Mansfield Street W1M 0AH London | British | 35542530001 | ||||||||||
| KERMAN, Nicholas | Administrateur | 25 Eaton Mews South SW1W 9HR London | England | British | 55578530001 | |||||||||
| LORENZ, Robert Jacques | Administrateur | 97 St Johns Wood Terrace NW8 6PP London | British | 3397220001 | ||||||||||
| OSBORNE, Clarke Anthony | Administrateur | 1 Malthouse Barn Barn Lane Chelwood BS18 4NN Bristol | British | 48713080003 | ||||||||||
| PRICHARD JONES, Kenneth Victor | Administrateur | Field Place Broadbridge Heath RH12 3PB Horsham West Sussex | United Kingdom | British | 118944980001 | |||||||||
| PRICHARD JONES, Sebastian James | Administrateur | Flat 4 26/27 Great Tower Street EC3R 5AQ London | England | British | 69343350002 | |||||||||
| PRICHARD-JONES, Dagmar Eve | Administrateur | Field Place Broadbridge Heath RH12 3PB Horsham West Sussex | British | 6556330001 | ||||||||||
| PRICHARD-JONES, Kenneth Victor | Administrateur | 1 Field Place Broadbridge Heath RH12 3PB Horsham West Sussex | British | 37769570002 | ||||||||||
| SCHINDLER, Darren | Administrateur | 86 Stag Leys KT21 2TL Ashtead Surrey | British | 118944850001 | ||||||||||
| SIGURDSSON, Snaebjorn | Administrateur | Kirkjusandi 2 155 Reyjavik Islandsbanki Hf Iceland | Iceland | Icelandic | 168776090001 | |||||||||
| COLERIDGE PARTNERS LLP | Administrateur | Field Place Broadbridge Heath RH12 3PB Horsham West Sussex | 120033030001 | |||||||||||
| CONSOLIDATED HOLDINGS PLC | Administrateur | PO BOX 134 4th North Suite Town Mills Trinity Square GY1 3HN St Peter Port Guernsey Channel Islands | 109847110001 | |||||||||||
| DRAGON DIRECTORS LIMITED | Administrateur | Field Place Broadbridge Heath RH12 3PB Horsham West Sussex | 85218910001 | |||||||||||
| ENTERPRISE CORPORATION | Administrateur | P O Box 556 Charlestown Nevis West Indies | 52245280001 | |||||||||||
| MANAGEMENT CORPORATION | Administrateur | P O Box 556 Charlestown Nevis West Indies | 51797180001 | |||||||||||
| STJORNARMENN ENF | Administrateur | Skofarhlid 12 FOREIGN Reykjavik 105 Iceland | 126702600001 | |||||||||||
| STJORNARZ EHF | Administrateur | Borgartun 18, FOREIGN Reykjavik 105 Iceland | 120033190001 | |||||||||||
| STJORNARZ EHF | Administrateur | Borgartun 18, Reykjavik 105 Iceland | 120033190001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur LAVA CAPITAL UK LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé |
|---|---|---|---|
| Mr Jason Scott Haigh | 06 avr. 2016 | CM23 4FS Bishops Stortford 19 Ploughmans Close Hertfordshire England | Non |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Christopher James Duncan Mcdougall | 06 avr. 2016 | 30 St Johns Road GU21 7SA Woking Chancery House Surrey United Kingdom | Non |
Nationalité: Australian Pays de résidence: Australia | |||
Nature du contrôle
| |||
LAVA CAPITAL UK LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of priorities containing a charging clause | Créé le 03 juil. 2009 Livré le 21 juil. 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the borrowers to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Any money or assets which the company receives in contravention of the deed which has not been agreed by the senior creditor see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of priorities | Créé le 31 mars 2008 Livré le 09 avr. 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from consero homes dartnell ave limited to the chargee and the senior creditor not exceeding £4,205,000 under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Any money or assets which the company receives in contravention of the deed, which has not been agreed by the senior creditor see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of priorities | Créé le 24 oct. 2007 Livré le 01 nov. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from consero more lane limited (the borrower) to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Any money or assets which the company receives. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture and charge | Créé le 12 mars 2007 Livré le 29 mars 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All assets and undertaking of the company including uncalled capital and including all monies due under and all security for loans made by the company from time to time. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 18 août 1992 Livré le 21 août 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions By way of legal mortgage bristol lawn tennis & squash centre, redland green, redland, bristol by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights affecting or concerning the property the plant machinery and fixtures and fittings, furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business of a licenced publican etc the benefit of all licences (see form 395 for full details). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 31 mars 1992 Livré le 04 avr. 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge of licensed premises | Créé le 31 mars 1992 Livré le 04 avr. 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H land and buildings k/a 1 pont street l/b of kensington and chelsea, greater london title no. 334759 fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment the goodwill of the business the benefit of all justices, excise or other licences (see form 395 for full details). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 18 oct. 1991 Livré le 07 nov. 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H land and buildings k/a 4-7 (inclusive) victoria buildings, terminus place, l/b of city of westminster, greater london, title no. 353505 fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture andequipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 02 mars 1987 Livré le 12 mars 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Mirabelle restaurant 56 curzon street westminster fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 02 mars 1987 Livré le 12 mars 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Flat 9, 56 curzon street westminster fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipement. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 27 févr. 1987 Livré le 02 mars 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti £1,200,000 and all other moneys due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions F/H premises at pickering place vaults (title no 106860) l/h premises at 5 st.jame's street (title no ln U04252) l/h premises at 4/7 victoria buildings (title no ln 65915). (see form 395 for full details). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 26 janv. 1984 Livré le 27 janv. 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H 81 & 83 buckingham alace road and 164 victoria street, london SW1 title no. 249201. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage | Créé le 10 janv. 1966 Livré le 12 janv. 1966 | Totalement satisfaite | Montant garanti £150,000 | |
Brèves mentions 1 & 2 great windmill street 18, 19, 20 coventry street W1. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0