NORFOLK CAPITAL HOTELS LIMITED

NORFOLK CAPITAL HOTELS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNORFOLK CAPITAL HOTELS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00224917
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NORFOLK CAPITAL HOTELS LIMITED ?

    • Hôtels et hébergement similaire (55100) / Hébergement et restauration

    Où se situe NORFOLK CAPITAL HOTELS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    St. James House 3rd Floor, South Wing
    27-43 Eastern Road
    RM1 3NH Romford
    Essex
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de NORFOLK CAPITAL HOTELS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2022

    Quels sont les derniers dépôts pour NORFOLK CAPITAL HOTELS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2022

    19 pagesAA

    État du capital au 28 sept. 2023

    • Capital: GBP 1
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Modification des détails de Norfolk Capital Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 07 août 2023

    2 pagesPSC05

    Changement d'adresse du siège social de Valor Hospitality Europe Ltd St. James House, 3rd Floor, South Wing 27-43 Eastern Road Romford Essex RM1 3NH United Kingdom à St. James House 3rd Floor, South Wing 27-43 Eastern Road Romford Essex RM1 3NH le 07 août 2023

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 09 juin 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Warunya Punawakul le 24 mars 2023

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Wanida Suksuwan le 24 mars 2023

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Hansa Susayan le 24 mars 2023

    2 pagesCH01

    Modification des détails de Norfolk Capital Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 24 mars 2023

    2 pagesPSC05

    Changement d'adresse du siège social de Queens Court 9-17 Eastern Road Romford Essex RM1 3NG à Valor Hospitality Europe Ltd St. James House, 3rd Floor, South Wing 27-43 Eastern Road Romford Essex RM1 3NH le 24 mars 2023

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2021

    18 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 09 juin 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2020

    20 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 09 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 002249170029 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2019

    22 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 09 juin 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Hansa Susayan en tant qu'administrateur le 10 déc. 2019

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de NORFOLK CAPITAL HOTELS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PUNAWAKUL, Warunya
    3rd Floor, South Wing
    27-43 Eastern Road
    RM1 3NH Romford
    St. James House
    Essex
    United Kingdom
    Administrateur
    3rd Floor, South Wing
    27-43 Eastern Road
    RM1 3NH Romford
    St. James House
    Essex
    United Kingdom
    ThailandThai265448120001
    SUKSUWAN, Wanida
    3rd Floor, South Wing
    27-43 Eastern Road
    RM1 3NH Romford
    St. James House
    Essex
    United Kingdom
    Administrateur
    3rd Floor, South Wing
    27-43 Eastern Road
    RM1 3NH Romford
    St. James House
    Essex
    United Kingdom
    ThailandThai265450970001
    SUSAYAN, Hansa
    3rd Floor, South Wing
    27-43 Eastern Road
    RM1 3NH Romford
    St. James House
    Essex
    United Kingdom
    Administrateur
    3rd Floor, South Wing
    27-43 Eastern Road
    RM1 3NH Romford
    St. James House
    Essex
    United Kingdom
    ThailandThai265450980001
    BURGESS, Keith John
    3 Queen Annes Gate
    White House Walk
    GU9 9AN Farnham
    Surrey
    Secrétaire
    3 Queen Annes Gate
    White House Walk
    GU9 9AN Farnham
    Surrey
    British7009790002
    CHRISTIAN, Tracy Joanne
    19 Lovell Walk
    RM13 7ND Rainham
    Essex
    Secrétaire
    19 Lovell Walk
    RM13 7ND Rainham
    Essex
    British102667300001
    COUGHLAN, Sally Ann
    Queens Court
    9-17 Eastern Road
    RM1 3NG Romford
    Queens Court
    Essex
    England
    Secrétaire
    Queens Court
    9-17 Eastern Road
    RM1 3NG Romford
    Queens Court
    Essex
    England
    British107832420001
    JONES, Vanessa
    Stables House
    Castle Hill
    RH1 4LB Bletchingley
    Surrey
    Secrétaire
    Stables House
    Castle Hill
    RH1 4LB Bletchingley
    Surrey
    British72146200001
    PURVIS, Martin Terence Alan
    Fenetters
    Melfort Road
    TN6 1QT Crowborough
    East Sussex
    Secrétaire
    Fenetters
    Melfort Road
    TN6 1QT Crowborough
    East Sussex
    British7901050001
    WALLER, Ronald John
    Brindles 118 Hanging Hill Lane
    CM13 2HN Brentwood
    Essex
    Secrétaire
    Brindles 118 Hanging Hill Lane
    CM13 2HN Brentwood
    Essex
    British1210620001
    WATERS, Jonathan Roy
    Maldon Road
    CO3 3BQ Colchester
    237
    Essex
    Secrétaire
    Maldon Road
    CO3 3BQ Colchester
    237
    Essex
    British129848360001
    ALLSOP, Heather Louise
    62 Prebend Street
    N1 8PS London
    Administrateur
    62 Prebend Street
    N1 8PS London
    British101912850001
    ARZI, David
    38th Floor
    NY 10036 New York
    One Bryant Park
    Usa
    Administrateur
    38th Floor
    NY 10036 New York
    One Bryant Park
    Usa
    United StatesAmerican190079640001
    BAIRSTOW, John
    Frieze Cottage Coxtie Green Road
    South Weald
    CM14 5RE Brentwood
    Essex
    Administrateur
    Frieze Cottage Coxtie Green Road
    South Weald
    CM14 5RE Brentwood
    Essex
    British537400001
    BELL, Gerald James
    Cavewood Rectory Lane
    Datchworth
    SG3 6RD Knebworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    Cavewood Rectory Lane
    Datchworth
    SG3 6RD Knebworth
    Hertfordshire
    British47018930002
    BOULD, Andrew Robin Douglas
    508 Uxbridge Road
    HA5 4SG Pinner
    Middlesex
    Administrateur
    508 Uxbridge Road
    HA5 4SG Pinner
    Middlesex
    British36875610001
    BRAIDLEY, Jonathan Patrick
    16 Palace Street
    SW1E 5JD London
    Mcap Global Finance (Uk) Llp
    United Kingdom
    Administrateur
    16 Palace Street
    SW1E 5JD London
    Mcap Global Finance (Uk) Llp
    United Kingdom
    United KingdomBritish190075510001
    CAIRNS, Michael Anthony
    Birchlands
    Old Avenue
    KT13 0PY Weybridge
    Surrey
    Administrateur
    Birchlands
    Old Avenue
    KT13 0PY Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritish36488470001
    COLES, Alan Clifford
    The Knoll
    Grendon
    NN7 1JG Northampton
    Beeches, 5
    Northamptonshire
    Administrateur
    The Knoll
    Grendon
    NN7 1JG Northampton
    Beeches, 5
    Northamptonshire
    EnglandBritish101144900002
    COLLYER, Brian Charles
    49 Route De Croissy
    78110 Le Vesinet
    France
    Administrateur
    49 Route De Croissy
    78110 Le Vesinet
    France
    Canadian101144260001
    COPPEL, Andrew Maxwell
    Orchard House
    8 Claremont Park Road
    KT10 9LT Esher
    Surrey
    Administrateur
    Orchard House
    8 Claremont Park Road
    KT10 9LT Esher
    Surrey
    EnglandBritish14330100002
    FINKLEMAN, Michael David
    Charlewood
    Manor Crescent, Seer Green
    HP9 2QX Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Charlewood
    Manor Crescent, Seer Green
    HP9 2QX Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British66057660001
    GOIN, Russell Todd
    4 Rue Jadin
    75017
    FOREIGN Paris
    France
    Administrateur
    4 Rue Jadin
    75017
    FOREIGN Paris
    France
    American108675490001
    HERSEY, David Michael
    Greenways
    Ridgeway Hutton Mount
    CM13 2LS Brentwood
    Essex
    Administrateur
    Greenways
    Ridgeway Hutton Mount
    CM13 2LS Brentwood
    Essex
    British17567250001
    KABALAN, Fadi
    Keyes House
    Dolphin Square
    SW1V 3NA London
    Suite 311
    Administrateur
    Keyes House
    Dolphin Square
    SW1V 3NA London
    Suite 311
    EnglandBritish133846470001
    KRAIS, Ashley Simon
    74 Marsh Lane
    NW7 4NT London
    Administrateur
    74 Marsh Lane
    NW7 4NT London
    United KingdomBritish105921220001
    KULA, Christopher Andre
    16 Palace Street
    SW1E 5JD London
    Mcap Global Finance (Uk) Llp
    United Kingdom
    Administrateur
    16 Palace Street
    SW1E 5JD London
    Mcap Global Finance (Uk) Llp
    United Kingdom
    United KingdomBritish,Canadian,German219684180001
    LE POIDEVIN, Andrew Daryl
    Kinneil
    34 Bulstrode Way
    SL9 7QU Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Kinneil
    34 Bulstrode Way
    SL9 7QU Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritish4958800007
    MAIDEN, George Barry
    Fourwinds Long Walk
    HP8 4AW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Fourwinds Long Walk
    HP8 4AW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British8832120001
    MARCUS, Martin Alan
    17 Monkhams Drive
    IG8 0LG Woodford Green
    Essex
    Administrateur
    17 Monkhams Drive
    IG8 0LG Woodford Green
    Essex
    British35543430001
    MENARD, Veronique Pascale Dominique
    Goldman Sachs International
    Peterborough Court, 133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Goldman Sachs International
    England
    Administrateur
    Goldman Sachs International
    Peterborough Court, 133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Goldman Sachs International
    England
    United KingdomFrench141156250001
    METCALFE, Michael Stuart
    Harwil 37 Howards Thicket
    SL9 7NT Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Harwil 37 Howards Thicket
    SL9 7NT Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritish40294180002
    MOORE, Richard John
    2 Maple Wood
    Bedhampton
    PO9 3JB Havant
    Hampshire
    Administrateur
    2 Maple Wood
    Bedhampton
    PO9 3JB Havant
    Hampshire
    EnglandBritish101144680001
    MULAHASANI, Heather Louise
    Goldman Sachs International
    Peterborough Court, 133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Goldman Sachs International
    Administrateur
    Goldman Sachs International
    Peterborough Court, 133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Goldman Sachs International
    EnglandBritish136994090001
    OGDEN, Kathryn
    14 Arundel Court
    43-47 Arundel Gardens
    W11 2LP London
    Administrateur
    14 Arundel Court
    43-47 Arundel Gardens
    W11 2LP London
    American114248790002
    PORTER, Allan William
    147 Worrin Road
    CM15 8JR Shenfield
    Essex
    Administrateur
    147 Worrin Road
    CM15 8JR Shenfield
    Essex
    British17567090001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur NORFOLK CAPITAL HOTELS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    3rd Floor, South Wing
    27-43 Eastern Road
    RM1 3NH Romford
    St. James House
    Essex
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    3rd Floor, South Wing
    27-43 Eastern Road
    RM1 3NH Romford
    St. James House
    Essex
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleUnited Kingdom (England)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement414351
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour NORFOLK CAPITAL HOTELS LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    09 juin 201725 janv. 2018La société n'a pas encore achevé les mesures raisonnables pour déterminer si une personne est une personne enregistrable ou une entité juridique pertinente enregistrable en relation avec la société.

    NORFOLK CAPITAL HOTELS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 28 nov. 2017
    Livré le 28 nov. 2017
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transactions
    • 28 nov. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 27 nov. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 23 juil. 2015
    Livré le 05 août 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Parts of the f/h property k/a best western reading moat house, mill lane, sindlesham t/no's BK271688 and BK235966.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag, London Branch as Security Agent
    Transactions
    • 05 août 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 09 août 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Security agreement
    Créé le 22 févr. 2011
    Livré le 02 mars 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    (For details of properties charged please refer to form MG01) fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transactions
    • 02 mars 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 19 août 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 23 févr. 2005
    Livré le 11 mars 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from an obligor or by some other person of each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    L/H property being the extension to the county hotel duckmill lane bedford bedfordshire t/n BD56894. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • G S Mortgage Funding No.1 Limited (As Security Trustee for the Finance Parties)
    Transactions
    • 11 mars 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 23 févr. 2005
    Livré le 11 mars 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due by an obligor or by some other person of each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Gs Mortgage Funding No.1 Limited (As Security Trustee for the Finance Parties)
    Transactions
    • 11 mars 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 23 févr. 2005
    Livré le 04 mars 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Bedford moat house, st. Mary's street, bedford, bedfordshire. L/h property being the extension to the county hotel, duckmill lane, bedford, bedfordshire t/no. BD56894.
    Personnes ayant droit
    • Goldman Sachs Credit Partners, L.P.
    Transactions
    • 04 mars 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 nov. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    A composite guarantee and debenture
    Créé le 23 févr. 2005
    Livré le 04 mars 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Goldman Sachs Credit Partners, L.P.
    Transactions
    • 04 mars 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 août 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 24 nov. 2004
    Livré le 14 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage all estates or interests in the f/h, l/h and other immovable property. By way of fixed charge all estates or interests in any f/h, l/h and other immovable property, all stocks shares debentures bonds notes and loan capital, the goodwill, all copyrights and patents. By way of floating charge the undertaking and all its property assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Goldman Sachs Credit Partners, L.P.
    Transactions
    • 14 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 mars 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 18 juin 2004
    Livré le 25 juin 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Law Debenture Trust Coproration PLC
    Transactions
    • 25 juin 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental deed to the composite guarantee and debenture
    Créé le 08 juin 2004
    Livré le 11 juin 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor including the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage the legally mortgaged property and sale thereof, by way of fixed charge all stocks, shares, the goodwill and uncalled capital, all copyrights, patents, by way of floating charge the undertaking, all property, assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (As Agent and Security Trustee for the Junior Term Lenders Defined in Theterm Facility Agreement)
    Transactions
    • 11 juin 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 nov. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge and release
    Créé le 28 mai 2004
    Livré le 02 juin 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The capital sum of £225,000 and the investments for the time being and from time to time representing the same.
    Personnes ayant droit
    • Capita Irg Trustees Limited
    Transactions
    • 02 juin 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 mars 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 25 mars 2004
    Livré le 26 mars 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor including the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage the legally mortgaged property and sale thereof, by way of fixed charge all stocks, shares, the goodwill and uncalled capital, all copyrights, patents, by way of floating charge the undertaking, all property, assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (As Agent and Security Trustee for the Junior Term Lenders)
    Transactions
    • 26 mars 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 nov. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of release and substitution
    Créé le 27 mars 1997
    Livré le 01 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    In favour of the chargee payment of the principal of and interest on the £15,000,000 12 per cent. First mortgage debenture stock 2013, on the £35,000,000 10 1/4 per cent. First mortgage debenture stock 2020, on the £70,000,000 10 1/4 per cent. First mortgage debenture stock 2020, on the £95,000,000 10 1/4 per cent. First mortgage debenture stock 2020 of queens moat houses PLC and all other moneys intended to be secured by the above deed and by the deeds dated 12.12.83, 5.6.85, 14.4.86, 19.5.89, 10.12.91, 10.12.91, 8.3.94, 28.4.95, 7.7.95, 27.6.96, 5.11.96, 28.11.96, 6.3.97, and 10.3.97 to which it is supplemental
    Brèves mentions
    By way of first legal mortgage all that f/h and l/h property described below together with all buildings and erections and fixtures (including tenants' and trade fixtures) and fixed plant and machinery for the time being thereon; property-f/h land being the county hotel and riverside towers st. Mary street bedford. T/n-BD12613. L/h land known as the extension to county hotel duckmill lane bedford t/n-BD56894. F/h land on the north side of duckmill lane t/n-BD109099.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC
    Transactions
    • 01 avr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 mars 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of release and substitution
    Créé le 10 mars 1997
    Livré le 12 mars 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Payment of the principal of and interest on the £15,000,000 12 per cent. First mortgage debenture stock 2013, on the £35,000,000 10 1/4 per cent. First mortgage debenture stock 2020, on the £70,000,000 10 1/4 per cent. First mortgage debenture stock 2020 on the £95,000,000 10 1/4 per cent. First mortgage debenture stock 2020 of queens moat houses PLC and all other monies due or to become due from the company to the chargee intended to be secured by the above deed and by the deeds dated 12.12.83, 5.6.85, 14.4.86, 19.5.89, 10.12.91, 10.12.91, 8.3.94, 28.4.95, 7.7.95, 27.6.96, 5.11.96, 28.11.96 and 6.3.97 to which it is supplemental
    Brèves mentions
    F/H property k/a the reading moat house registered as sindlesham mill, mill lane lower earley wokingham berkshire t/no: BK271688 and in part with possessory title t/no: BK235966. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC
    Transactions
    • 12 mars 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 mars 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of assurance
    Créé le 08 mars 1994
    Livré le 24 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the company to the chargee under the terms of the trust deeds constituting the £15,000,000 12% first mortgage debenture stock 2013 and the £200,000,000 10.25% first mortgage debenture stock 2020 of queens moat houses P.L.C.
    Brèves mentions
    Various f/hold and l/hold properties with all buildings,fixtures/fittings;fixed plant/machinery..........all rights,leases,agreements,covenants....etc.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC
    Transactions
    • 24 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juin 2004Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 29 juin 2004Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 10 juil. 2004Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 07 mars 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security
    Créé le 10 déc. 1991
    Livré le 13 déc. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The principal of and interest on the £95,000,000 10.25% first mortgage debenture stock 2020 of queens moat houses plcand all other monies due or to become due from the company to the chargee secured by or pursuant to a trust deed dated 12.12.83. and deeds supplemental thereto(including the principal of and interest on £15,000,000 12% first mortgage debenture stock 2013 and £105,000,00010.25% first mortgage debenture stock 2020 of queens moat houses PLC already issues)
    Brèves mentions
    The caledonian hotel,edinburgh comprisintwo areas of ground at rutland st/lothian rd,edinburgh and all buildings,erectios,fixtures and heritable fittings thereon and rights thereto.
    Personnes ayant droit
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC
    Transactions
    • 13 déc. 1991Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 mars 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Third supplemental trust deed
    Créé le 10 déc. 1991
    Livré le 10 déc. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The principal of and interest on the £95,000,000 10 1/4 per cent. First mortgage debenture stock 2020 of queens moat houses P.L.C. (the "new stock") and all other monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the trust deeds as defined therein
    Brèves mentions
    Freehold the royal crescent hotel, 15/16 royal crescent, bath, avon land adjoining eastern boundary of the angel hotel, cardiff comprising staircase and boiler see doc ref M739C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC
    Transactions
    • 10 déc. 1991Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 avr. 2001Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 29 juin 2004Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 29 juin 2004Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 07 mars 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security registered in scotland 14.11.86
    Créé le 14 nov. 1986
    Livré le 24 nov. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £5000,000 due from the company to the chargee.
    Brèves mentions
    North bristol hotel princes street edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • Gleneagles Hotels Public Limited Company
    Transactions
    • 24 nov. 1986Enregistrement d'une charge
    • 29 juin 2004Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 30 déc. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 29 févr. 1984
    Livré le 09 mars 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H 14 eccleston square london SW1.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 09 mars 1984Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 12 sept. 1983
    Livré le 15 sept. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H the new county hotel, southgate street, gloucester.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 15 sept. 1983Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 12 sept. 1983
    Livré le 15 sept. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H the angel hotel chippenham, wiltshire.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 15 sept. 1983Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 01 juil. 1983
    Livré le 02 juil. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from norfolk capital group PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    F/H land & premises shortly k/a the royal clarence hotel cathedral yard and 16 and 17 cathedral yard exeter with all fixtures.
    Personnes ayant droit
    • Whitebread and Company Public Limited Company
    Transactions
    • 02 juil. 1983Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 02 juin 1982
    Livré le 08 juin 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The angel hotel, castle garage 23 25 26 27 29 31 33 and 35 castle street cardiff title no. Wa 87715.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 08 juin 1982Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 06 avr. 1982
    Livré le 19 avr. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H the granby hotel harrogate yorkshire.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 19 avr. 1982Enregistrement d'une charge
    Mortgage
    Créé le 29 avr. 1980
    Livré le 30 avr. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land & premises being/situate at the norbreck castle hotel and conference centre queen's promenade north shore, blackpool. Tog. With all fixtures. Title no:- la 440672.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 30 avr. 1980Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0