LONDON IRISH RUGBY FOOTBALL GROUND LIMITED

LONDON IRISH RUGBY FOOTBALL GROUND LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLONDON IRISH RUGBY FOOTBALL GROUND LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00225815
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LONDON IRISH RUGBY FOOTBALL GROUND LIMITED ?

    • Activités des clubs de sport (93120) / Activités artistiques, de loisirs et de divertissement

    Où se situe LONDON IRISH RUGBY FOOTBALL GROUND LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Hazelwood Centre
    Croysdale Avenue
    TW16 6QU Sunbury-On-Thames
    Middlesex
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de LONDON IRISH RUGBY FOOTBALL GROUND LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour LONDON IRISH RUGBY FOOTBALL GROUND LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Achèvement de la liquidation

    1 pagesL64.07

    Ordonnance du tribunal pour liquider

    3 pagesCOCOMP

    Cessation de la nomination de Mark Laurence Bensted en tant que directeur le 30 sept. 2022

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 30 juin 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 juin 2021

    10 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 juin 2020

    15 pagesAA

    Cessation de la nomination de Brian William Ernest Facer en tant que directeur le 06 févr. 2021

    1 pagesTM01

    Inscription de la charge 002258150019, créée le 24 déc. 2020

    40 pagesMR01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 juin 2019

    14 pagesAA

    Nomination de Mr Adrian Alli en tant que secrétaire le 24 juil. 2020

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Paul Forsyth en tant que secrétaire le 24 juil. 2020

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 30 juin 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Période comptable précédente raccourcie du 30 juin 2019 au 29 juin 2019

    1 pagesAA01

    Déclaration de confirmation établie le 30 juin 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 juin 2018

    13 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 juin 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 juin 2017

    13 pagesAA

    Nomination de Mr Brian Facer en tant qu'administrateur le 16 oct. 2017

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 30 juin 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Mary Assumpta Cusack en tant que directeur le 28 mars 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Philip Francis Cusack en tant que directeur le 28 févr. 2017

    1 pagesTM01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 juin 2016

    13 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 juin 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de LONDON IRISH RUGBY FOOTBALL GROUND LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ALLI, Adrian
    Croysdale Avenue
    TW16 6QU Sunbury-On-Thames
    Hazelwood Centre
    Middlesex
    Secrétaire
    Croysdale Avenue
    TW16 6QU Sunbury-On-Thames
    Hazelwood Centre
    Middlesex
    272760590001
    CROSSAN, Michael Rowland
    Old Oak Sidings
    Off Scrubs Lane
    NW10 6RJ London
    Crossan House
    England
    Administrateur
    Old Oak Sidings
    Off Scrubs Lane
    NW10 6RJ London
    Crossan House
    England
    BritishBritishCompany Director183794460001
    ADAMS, Peter Charles
    10 Southerland Close
    KT13 9EN Weybridge
    Surrey
    Secrétaire
    10 Southerland Close
    KT13 9EN Weybridge
    Surrey
    BritishAccountant181387400001
    BYRNE, Trevor Anthony, Mr.
    Croysdale Avenue
    TW16 6QU Sunbury-On-Thames
    Hazelwood Centre
    Middlesex
    England
    Secrétaire
    Croysdale Avenue
    TW16 6QU Sunbury-On-Thames
    Hazelwood Centre
    Middlesex
    England
    186736810001
    FORSYTH, Paul
    Croysdale Avenue
    TW16 6QU Sunbury-On-Thames
    Hazelwood Centre
    Middlesex
    England
    Secrétaire
    Croysdale Avenue
    TW16 6QU Sunbury-On-Thames
    Hazelwood Centre
    Middlesex
    England
    198732360001
    GUMM, Paul
    The Avenue
    Sunbury On Thames
    TW16 5EQ Middlesex
    Secrétaire
    The Avenue
    Sunbury On Thames
    TW16 5EQ Middlesex
    British130071670002
    JAMES, David
    18-20 Southwark Street
    SE1 1TS London
    Secrétaire
    18-20 Southwark Street
    SE1 1TS London
    BritishSolicitor42416910001
    MC GAUGHEY, Patrick
    49 Harrowby Street
    W1H 5HF London
    Secrétaire
    49 Harrowby Street
    W1H 5HF London
    Irish15772640001
    MILES, Christopher
    The Avenue
    Sunbury On Thames
    TW16 5EQ Middlesex
    Secrétaire
    The Avenue
    Sunbury On Thames
    TW16 5EQ Middlesex
    165079020001
    STACPOOLE, John
    1 Queens Road
    Ealing
    W5 2SA London
    Secrétaire
    1 Queens Road
    Ealing
    W5 2SA London
    British39470570001
    WILLIAMS, Helen Wyn
    33 Andover Road
    TW2 6PD Twickenham
    Middlesex
    Secrétaire
    33 Andover Road
    TW2 6PD Twickenham
    Middlesex
    BritishFinancial Cont57143980001
    BENSTED, Mark Laurence
    Old Oak Sidings
    Off Scrubs Lane
    NW10 6RJ London
    Crossan House
    England
    Administrateur
    Old Oak Sidings
    Off Scrubs Lane
    NW10 6RJ London
    Crossan House
    England
    EnglandBritishCompany Director183794530001
    BRADY, Hugh Rochfort
    16 Selwood Terrace
    SW7 London
    Administrateur
    16 Selwood Terrace
    SW7 London
    BritishArchitect40514330001
    CONLAN, John Oliver
    Sunnydale
    Bellingdon
    HP5 2XU Chesham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Sunnydale
    Bellingdon
    HP5 2XU Chesham
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Director9020510001
    CUSACK, Mary Assumpta
    Holloway Road
    N7 6NJ London
    332-336
    England
    Administrateur
    Holloway Road
    N7 6NJ London
    332-336
    England
    EnglandIrishCompany Director183794520001
    CUSACK, Philip Francis
    Holloway Road
    N7 6NJ London
    332-336
    England
    Administrateur
    Holloway Road
    N7 6NJ London
    332-336
    England
    EnglandIrishCompany Director183794510001
    FACER, Brian William Ernest
    Croysdale Avenue
    TW16 6QU Sunbury-On-Thames
    Hazelwood Centre
    Middlesex
    Administrateur
    Croysdale Avenue
    TW16 6QU Sunbury-On-Thames
    Hazelwood Centre
    Middlesex
    EnglandBritishChief Executive239035370001
    FITZGERALD, David
    The Avenue
    TW16 5EQ Sunbury-On-Thames
    London Irish Rfc
    Middlesex
    England
    Administrateur
    The Avenue
    TW16 5EQ Sunbury-On-Thames
    London Irish Rfc
    Middlesex
    England
    EnglandIrishCompany Director183794500001
    FORSYTHE, James Roy
    104 Earls Court Road
    W8 6EG London
    Administrateur
    104 Earls Court Road
    W8 6EG London
    British15772650001
    JACKSON, David
    141 Argyle Road
    Ealing
    W13 8ER London
    Administrateur
    141 Argyle Road
    Ealing
    W13 8ER London
    United KingdomBritishAirline Executive2147720001
    JAMES, Peter
    10 Southerland Close
    KT13 9EN Weybridge
    Surrey
    Administrateur
    10 Southerland Close
    KT13 9EN Weybridge
    Surrey
    BritishDirector125239810001
    JOHNSTON, Ronald Mervyn
    19 Greenhill Close
    GU15 1PG Camberley
    Surrey
    Administrateur
    19 Greenhill Close
    GU15 1PG Camberley
    Surrey
    BritishMarketing And Training Consultant15772660001
    LITTLE, Brian Thomas
    Cobb Hall Cottage Backway
    Great Haseley
    OX44 7JS Oxford
    Administrateur
    Cobb Hall Cottage Backway
    Great Haseley
    OX44 7JS Oxford
    BritishRetired40499770001
    MC GAUGHEY, Patrick
    49 Harrowby Street
    W1H 5HF London
    Administrateur
    49 Harrowby Street
    W1H 5HF London
    IrishChartered Accountant15772640001
    MCPHILLIPS, Charles Declan Francis
    10 Abbottsmede Close
    TW1 4RL Twickenham
    Middlesex
    Administrateur
    10 Abbottsmede Close
    TW1 4RL Twickenham
    Middlesex
    BritishSolicitor47193040001
    MULLIN, Brendan
    Albert Lodge
    3 Stillorgan Road
    DUBLIN 4 Donnybrook
    Ireland
    Administrateur
    Albert Lodge
    3 Stillorgan Road
    DUBLIN 4 Donnybrook
    Ireland
    IrishCompany Director90335420001
    ONEILL, John Gerard
    Willows Farmhouse Stratton Audley
    OX6 9BA Bicester
    Oxfordshire
    Administrateur
    Willows Farmhouse Stratton Audley
    OX6 9BA Bicester
    Oxfordshire
    IrishFarmer55228900001
    STACPOOLE, James Edmund John
    Stylecroft Road
    HP8 4HX Chalfont St. Giles
    Dellcroft
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Stylecroft Road
    HP8 4HX Chalfont St. Giles
    Dellcroft
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector92096790003
    STACPOOLE, John
    1 Queens Road
    Ealing
    W5 2SA London
    Administrateur
    1 Queens Road
    Ealing
    W5 2SA London
    EnglandBritishCompany Director39470570001
    TAYLOR, Ian Charles Boucher
    Woodlands
    TA11 6NS Littleton
    Somerset
    Administrateur
    Woodlands
    TA11 6NS Littleton
    Somerset
    United Kingdom BritishDirector169792830001
    TRAYNOR, Noel
    29 Priory Crescent
    Sudbury
    HA0 2QR Wembley
    Middlesex
    Administrateur
    29 Priory Crescent
    Sudbury
    HA0 2QR Wembley
    Middlesex
    IrishCompany Director53605410001
    WALPOLE, Graham Martin
    Leslie Road
    GU24 8LB Chobham
    7
    Surrey
    Administrateur
    Leslie Road
    GU24 8LB Chobham
    7
    Surrey
    EnglandBritishCeo147000430001
    WHITESIDE, Peter Hamilton
    Woodrising
    Shooters Way
    HP4 3NN Berkhamsted
    Hertfordshire
    Administrateur
    Woodrising
    Shooters Way
    HP4 3NN Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomIrishCompany Director39170040001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur LONDON IRISH RUGBY FOOTBALL GROUND LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    London Irish Holdings Limited
    Hazelwood Drive
    TW16 6QU Sunbury-On-Thames
    Hazelwood
    Middlesex
    England
    14 juil. 2016
    Hazelwood Drive
    TW16 6QU Sunbury-On-Thames
    Hazelwood
    Middlesex
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    LONDON IRISH RUGBY FOOTBALL GROUND LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 24 déc. 2020
    Livré le 29 déc. 2020
    En cours
    Brève description
    N/A.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The English Sports Council
    Transactions
    • 29 déc. 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 22 août 2014
    Livré le 04 sept. 2014
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Oval Ventures Limited
    • Steve Palmer
    • John Conlon
    Transactions
    • 04 sept. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 18 août 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 22 août 2014
    Livré le 30 août 2014
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Oval Ventures Limited
    • Steve Palmer
    • John Conlan
    Transactions
    • 30 août 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 18 août 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 08 mars 2013
    Livré le 28 mars 2013
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the rugby bond noteholders and the security trustees on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All f/h land on the north side of manor lane and west of the avenue, sunbury t/no:SY456116 and all f/h land lying to the west of the avenue, sunbury t/no:SY456117, fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • John Conlan,Steve Palmer and Oval Ventures Limited the Parties Acting in the Capacity of Trustees for Themselves and the Noteholders (The Security Trustees)
    Transactions
    • 28 mars 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 18 août 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 08 mars 2013
    Livré le 28 mars 2013
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the noteholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All f/h land on the north side of manor lane and west of the avenue, sunbury t/no:SY456116 and all f/h land lying to the west of the avenue, sunbury t/no:SY456117, fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • John Conlan, Steve Palmer and Oval Ventures Limited the Parties Acting in the Capacity of Trustees for Themselves and the Noteholders (The Security Trustees)
    Transactions
    • 28 mars 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 18 août 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Security assignment
    Créé le 08 mars 2013
    Livré le 09 mars 2013
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of security the benefit of each relevant agreement, all rights in each relevant policy (being policy numbers UKDAOO07852112 and 774BLU/P493309A12/476883) including the proceeds of any claims and the benefit of all other contracts guarantees appointments warranties and other documents see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transactions
    • 09 mars 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 18 août 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage debenture
    Créé le 08 mars 2013
    Livré le 09 mars 2013
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transactions
    • 09 mars 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 18 août 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 08 mars 2013
    Livré le 09 mars 2013
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H land on the north of manor lane and west of the avenue sunbury t/no SY456116 and f/h land lying to the west of the avenue now forming part of gaflac sports ground sunbury t/no SY456117 any right title and interest in and to the land including the drainage channel comprised with it lying between the two aforementioned titles which is indicated as unregistered on the plan annexed hereto together with the absence of rights to drain surface water drainage into the channel lying between 151 an 153 the avenue sunbury on thames middlesex by way of specific charge, the goodwill & connection of the business or businesses & also by way of a floating security, all moveable plant, machinery, implements, furniture, equipment, stock-in-trade, work in progress & other chattels.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transactions
    • 09 mars 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 18 août 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 27 févr. 2013
    Livré le 06 mars 2013
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £3,445,400 due or to become due from the chargor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H land at the avenue sunbury on thames middlesex part to the land under t/no. SY678171 SY456116 and SY456117 and any part of it including all rights attached or appurtenant to it and all immoveable property including buildings fixtures and fixed plant and machinery from time to time situate on it see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Crest Nicholson Operations Limited
    Transactions
    • 06 mars 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 18 août 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 28 nov. 2011
    Livré le 19 déc. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H property k/a land on the north of manor lane and west of the avenue sunbury t/no's SY456116 and SY456117 and f/h property k/a the land on the west side of the avenue sunbury t/no SY678171 see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • John Conlan Steve Palmer and Oval Ventures Limited
    Transactions
    • 19 déc. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 18 août 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 15 déc. 2010
    Livré le 30 déc. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land on the north of manor lane and to the west side of the avenue sunbury on thames t/nos SY456116 & SY456117; by way of specific charge, the goodwill & connection of the business or businesses & also by way of a floating security, all moveable plant, machinery, implements, furniture, equipment, stock-in-trade, work in progress & other chattels.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transactions
    • 30 déc. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 18 août 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 21 avr. 2008
    Livré le 12 mai 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Land on the north of manor lane and west of the avenue sunbury t/no SY456116, the land lying to the west of the avenue now forming part of the gaflac sports ground sunbury t/no SY456117 and all buildings and fixtures on this land see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • John Conlan and Steve Palmer and Oval Ventures Limited
    Transactions
    • 12 mai 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 août 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 21 déc. 2007
    Livré le 03 janv. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land on the west side of the avenue, sunbury on thames and land being on the north of manor lane and west of the avenue sunbury t/nos SY456116 and SY456117. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC
    Transactions
    • 03 janv. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 22 nov. 2007
    Livré le 05 déc. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC
    Transactions
    • 05 déc. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 23 juin 2003
    Livré le 02 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All that land lying to the north of manor lane and west of the avenue sunbury t/no SY456116; all that land lying to the west of the avenue now forming part of the gaflac sports ground sunbury t/no SY456117.
    Personnes ayant droit
    • Powerscourt Nominees Limited, Labyrinth Investments Limited, Little Ship Investments Limitedand the Clancy Group PLC
    Transactions
    • 02 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 déc. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 06 juin 1995
    Livré le 07 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a land on the north of manor lane and west of the avenue sunbury together with land lying to the west of the avenue sunbury t/no SY456116 & SY456117 inc fixtures & fittings the goodwill of the business & A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 07 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 26 nov. 1987
    Livré le 10 déc. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £45,000 and all other moneys due or to become due from the company to the chargee & all other moneys due for goods or services supplied (as defined) under the terms of this deed
    Brèves mentions
    F/H land & premises on the north of manor lane and west of the avenue sunbury-on-thames, middlesex title nos. Sy 456116 & sy 456117 together with goodwill, book debts & other debts.
    Personnes ayant droit
    • Watney Coomb Reid & Truman Limited
    Transactions
    • 10 déc. 1987Enregistrement d'une charge
    • 07 juin 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 11 nov. 1985
    Livré le 25 nov. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £30,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 30/7/85
    Brèves mentions
    F/H land lying to the west of the avenue forming part of gafflac sports ground, sunbury, surrey t/nos. Sy 456116 & sy 456117 together with all fixtures whatsoever.
    Personnes ayant droit
    • Whitbread Company Public Limited Company
    Transactions
    • 25 nov. 1985Enregistrement d'une charge
    • 07 juin 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Collateral charge
    Créé le 08 nov. 1985
    Livré le 25 nov. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £40,000 and all other moneys due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement of even date
    Brèves mentions
    Land on the north of manor lane west of the avenue sunbury spelthorne surrey and land going to the west of the avenue sunbury now forming part of gaflac sports ground sunbury title nos: sy 456116 and sy 456117.
    Personnes ayant droit
    • Courage Limited
    Transactions
    • 25 nov. 1985Enregistrement d'une charge
    • 07 juin 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    LONDON IRISH RUGBY FOOTBALL GROUND LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    06 mars 2024Conclusion of winding up
    02 juin 2023Petition date
    19 juil. 2023Commencement of winding up
    12 juin 2024Dissolved on
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    The Official Receiver Or Croydon
    11th Floor Southern House
    Wellesley Grove
    CR0 1XN Croydon
    practitioner
    11th Floor Southern House
    Wellesley Grove
    CR0 1XN Croydon

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0