CITY WALL (HOLDINGS) LIMITED

CITY WALL (HOLDINGS) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCITY WALL (HOLDINGS) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00228008
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CITY WALL (HOLDINGS) LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe CITY WALL (HOLDINGS) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CITY WALL (HOLDINGS) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    RANK CITY WALL LIMITED11 févr. 192811 févr. 1928

    Quels sont les derniers comptes de CITY WALL (HOLDINGS) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour CITY WALL (HOLDINGS) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    7 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 14 déc. 2018

    8 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 14 déc. 2017

    8 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de 4th Floor, 30 Market Place London W1W 8AP England à 30 Finsbury Square London EC2P 2YU le 27 nov. 2017

    2 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2016 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de 30 Market Place London W1W 8AP England à 4th Floor, 30 Market Place London W1W 8AP le 05 sept. 2017

    1 pagesAD01

    Nomination de Noe Group (Corporate Services) Limited en tant qu'administrateur le 30 août 2017

    2 pagesAP02

    Changement d'adresse du siège social de 30 Market Place London W1W 8AP England à 30 Market Place London W1W 8AP le 30 août 2017

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de 30 Finsbury Square London EC2P 2YU à 30 Market Place London W1W 8AP le 30 août 2017

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de F&C Reit (Corporate Services) Limited en tant que secrétaire le 08 août 2017

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de F&C Reit (Corporate Services) Limited en tant que directeur le 08 août 2017

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de No 1 Dorset Street Southampton Hampshire SO15 2DP à 30 Finsbury Square London EC2P 2YU le 02 mai 2017

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Changement d'adresse du siège social de 5 Wigmore Street London W1U 1PB à No 1 Dorset Street Southampton Hampshire SO15 2DP le 20 janv. 2017

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 15 déc. 2016

    LRESSP

    Période comptable précédente raccourcie du 29 sept. 2015 au 28 sept. 2015

    2 pagesAA01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 11 juil. 2016

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 juil. 2016

    État du capital au 11 juil. 2016

    • Capital: GBP 26,490,138
    SH01

    Période comptable précédente raccourcie du 30 sept. 2015 au 29 sept. 2015

    2 pagesAA01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2014

    18 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de CITY WALL (HOLDINGS) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MEADS, Paul Graham
    Rockdene Close
    RH19 3HA East Grinstead
    15
    West Sussex
    United Kingdom
    Administrateur
    Rockdene Close
    RH19 3HA East Grinstead
    15
    West Sussex
    United Kingdom
    EnglandBritishSolicitor168880940001
    NOE GROUP (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    Market Place
    W1W 8AP London
    30
    England
    Administrateur
    Market Place
    W1W 8AP London
    30
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement10609062
    235013180001
    CLARKE, Peter Courtenay
    Langkawi
    2 Ashlea Road
    SL9 8NY Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Langkawi
    2 Ashlea Road
    SL9 8NY Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British78691990001
    EKPO, Ndiana
    Chislehurst Road
    BR5 1NR Petts Wood
    182
    Kent
    United Kingdom
    Secrétaire
    Chislehurst Road
    BR5 1NR Petts Wood
    182
    Kent
    United Kingdom
    Other138446320001
    SCUDAMORE, Rebecca Jane
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secrétaire
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Other72249480003
    F&C REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    Wigmore Street
    W1U 1PB London
    5
    Secrétaire
    Wigmore Street
    W1U 1PB London
    5
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement3143222
    147824490001
    BARZYCKI, Sarah Morrell
    Sandown Road
    KT10 9TT Esher
    27
    Surrey
    Administrateur
    Sandown Road
    KT10 9TT Esher
    27
    Surrey
    United KingdomBritishHead Of Finance58016770004
    BELL, Lucinda Margaret
    6 Priory Gardens
    Chiswick
    W4 1TT London
    Administrateur
    6 Priory Gardens
    Chiswick
    W4 1TT London
    EnglandBritishChartered Accountant32809050004
    BERRY, David Charles
    Portland Dene
    Valley Way
    SL9 7PN Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Portland Dene
    Valley Way
    SL9 7PN Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant166550001
    BOWDEN, Robert Edward
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    Administrateur
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    United KingdomBritishChartered Surveyor152497530001
    BRAINE, Anthony
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    Administrateur
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    United KingdomBritishChartered Secretary32809000002
    CLARKE, Peter Courtenay
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    Administrateur
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    United KingdomBritishChartered Secretary78691990003
    FORSHAW, Christopher Michael John
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    Administrateur
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director1898090001
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor146546000001
    GUNSTON, Michael Ian
    Larchmont
    Hambledon Road, Denmead
    PO7 6HB Waterlooville
    Hampshire
    Administrateur
    Larchmont
    Hambledon Road, Denmead
    PO7 6HB Waterlooville
    Hampshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor3079890002
    HESTER, Stephen Alan Michael
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    Administrateur
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    BritishChief Executive51688320001
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    Administrateur
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritishCompany Director82020730004
    KALMAN, Stephen Lionel
    81 Eastbury Road
    HA6 3AP Northwood
    Middlesex
    Administrateur
    81 Eastbury Road
    HA6 3AP Northwood
    Middlesex
    EnglandBritishChartered Surveyor1188110001
    METLISS, Cyril
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    Administrateur
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    BritishChartered Accountant3079600001
    RITBLAT, John, Sir
    The Doric Villa 20 York Terrace East
    Regents Park
    NW1 4PT London
    Administrateur
    The Doric Villa 20 York Terrace East
    Regents Park
    NW1 4PT London
    EnglandBritishChairman And Managing Director41694870001
    RITBLAT, Nicholas Simon Jonathan
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    Administrateur
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    United KingdomBritishCompany Director35758050004
    ROBERTS, Graham Charles
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    Administrateur
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    EnglandBritishChartered Accountant79807180002
    ROBERTS, Timothy Andrew
    Lorne House
    Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Lorne House
    Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    EnglandBritishChartered Surveyor63986410004
    SMITH, Stephen Paul
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director148183670001
    VANDEVIVERE, Jean-Marc
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomFrenchCompany Director170947050001
    WEBB, Nigel Mark
    Beech Lodge
    53 Crouch Hall Lane Redbourn
    AL3 7EU St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    Beech Lodge
    53 Crouch Hall Lane Redbourn
    AL3 7EU St Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Surveyor58059360001
    WESTON SMITH, John Harry
    10 Eldon Grove
    Hampstead
    NW3 5PT London
    Administrateur
    10 Eldon Grove
    Hampstead
    NW3 5PT London
    EnglandBritishChartered Secretary13547380001
    F&C REIT (CORPORATE DIRECTORS) LIMITED
    Wigmore Street
    W1U 1PB London
    5
    United Kingdom
    Administrateur
    Wigmore Street
    W1U 1PB London
    5
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement3239672
    183276050001
    F&C REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    Wigmore Street
    W1U 1PB London
    5
    United Kingdom
    Administrateur
    Wigmore Street
    W1U 1PB London
    5
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement3143222
    147824490001

    CITY WALL (HOLDINGS) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 18 nov. 2013
    Livré le 30 nov. 2013
    En cours
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Aareal Bank Ag, Wiesbaden as Security Trustee
    Transactions
    • 30 nov. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    Assignation in security
    Créé le 05 août 1997
    Livré le 06 août 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations monies and liabilities due or to become due from the obligants (as defined) to the chargee as trustee under the trust deed
    Brèves mentions
    All and whole the tenants interest under an agreement and lease among east kilbride development corporation city wall properties (scotland) limited and city wall properties limited of the subjects known and forming part of the plaza centre east kilbride and all the company's whole right and title under the trust agreement for full details of all charged assets please refer to form 395.
    Personnes ayant droit
    • L.D.C. Trustees Limited
    Transactions
    • 06 août 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 mars 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland
    Créé le 01 nov. 1996
    Livré le 07 nov. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the various documents (as defined therein)
    Brèves mentions
    All and whole the tenant's interest under an agreement and lease entered into between east kilbride development corporation, city wall properties (scotland) limited and city wall properties limited of subjects k/a and forming the plaza centre, east kilbride lying in the county of lanark.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • L.D.C. Trustees Limited
    Transactions
    • 07 nov. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 mars 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental deed
    Créé le 31 oct. 1996
    Livré le 06 nov. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The principal amount of and interest due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee pursuant to the terms of the trust deed dated 14/9/81 the first mortgage debenture stock 2019/24 and this deed
    Brèves mentions
    £3,140,000.
    Personnes ayant droit
    • Ldc Trustees Limited
    Transactions
    • 06 nov. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 août 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Trust deed
    Créé le 29 avr. 1993
    Livré le 13 mai 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £200,000,000 9 3/8 per cent. First mortgage debenture stock 2028 of the british land company PLC (the "parent") and all other moneys due from the parent to royal exchange trust company limited and all other persons or companies acting under the trust deed and any other deeds supplemental thereto as trustees, subject to a maximum of £1,000,000,000
    Brèves mentions
    F/Hold land/blds at bain clarkson house,harlands rd,yaywards heath,west sussex;t/no.wsx 15114; all fixtures,fittings,fixed plant/machinery....etc. See form 395.
    Personnes ayant droit
    • Royal Exchange Trust Company Limitedthe "Trustee"
    Transactions
    • 13 mai 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 oct. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of substitution and charge.
    Créé le 16 nov. 1987
    Livré le 20 nov. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Sterling pounds 5,000,000 due or to become due from the company and/or city wall properties limited and or merbridge properties limited to the chargee under the terms of the principal deeds
    Brèves mentions
    City wall house, eastrop basingstoke title no hp 108348 part title no hp 110271 (see doc M103/23 nuu/44).
    Personnes ayant droit
    • Royal Liver Trustees Limited
    Transactions
    • 20 nov. 1987Enregistrement d'une charge
    • 10 oct. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security
    Créé le 10 mars 1987
    Livré le 13 mars 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the british land company PLC to the chargeenot exceeding sterling pounds 10,000,000
    Brèves mentions
    Easterhouse township centre, waterhouse road, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 mars 1987Enregistrement d'une charge
    Deed of release and substitution
    Créé le 15 févr. 1978
    Livré le 17 févr. 1978
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Debenture stock amounting to sterling pounds 4,625,000
    Brèves mentions
    The freehold property known as brunel house the yard portsmouth.
    Personnes ayant droit
    • Eagle Stare Insurance Company Limited
    Transactions
    • 17 févr. 1978Enregistrement d'une charge
    • 15 août 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of release effecting substitution of security
    Créé le 10 juin 1976
    Livré le 23 juin 1976
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Securing debenture stock of the company amounting to £15,000,000 secured by a trust deed dated 8/5/73 and deeds supplemental thereto.
    Brèves mentions
    East kilbride shopping centre east kilbride, lanarkshire, scotland.
    Personnes ayant droit
    • Eagle Star Insurance Company Limited.
    Transactions
    • 23 juin 1976Enregistrement d'une charge
    Standard security presented for registration at the register of sasines on the 11/6/76
    Créé le 10 juin 1976
    Livré le 23 juin 1976
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For securing debenture stock of the company amounting to £15,000,000 secured by a trust deed dated 8/5/73 and deeds supplemental thereto
    Brèves mentions
    East kilbride shopping centre east kilbride, lanarkshire, scotland.
    Personnes ayant droit
    • Eagle Star Insurance Company Limited.
    Transactions
    • 23 juin 1976Enregistrement d'une charge
    • 14 févr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    15,000,000 inclusive of £14,000,000 secured by a trust deed doc 8/5/734 deeds supplemental
    Créé le 31 déc. 1975
    Livré le 08 janv. 1976
    Totalement satisfaite
    Personnes ayant droit
    • Eagle Star Insurance Company LTD
    Transactions
    • 08 janv. 1976Enregistrement d'une charge
    • 14 févr. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 20 déc. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of charge
    Créé le 31 déc. 1975
    Livré le 05 janv. 1976
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For securing debenture stock of the company amounting to £15,000,000
    Brèves mentions
    Headlease intended to be granted to the company pursuant to the provisions of an agreement act 7/8/1969.
    Personnes ayant droit
    • Eagle Star Insurance Co LTD
    Transactions
    • 05 janv. 1976Enregistrement d'une charge
    • 15 août 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 29 août 1975
    Livré le 04 sept. 1975
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Standard security presented for registration at the registar of sasines on the 29TH august 1975 and created by rank city wall limited for the purpose of securing debenture stock of the company amounting to £14,000,000 secured by a trust deed dated 1TH may 73 and deeds supplemental
    Brèves mentions
    The subjects described in a disposition by the trustees of for charles barrie in favour of united cinemas LTD dated 14TH and 16TH nov 35 & known as 1/5 paterson st & 126/128 strathmartine rd dundee.
    Personnes ayant droit
    • Eagle Star Insurance Co LTD
    Transactions
    • 04 sept. 1975Enregistrement d'une charge
    • 20 déc. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Series of debentures
    Créé le 29 août 1975
    Livré le 29 août 1975
    Totalement satisfaite
    Personnes ayant droit
    • Eagle Star Insurance Co LTD
    Transactions
    • 29 août 1975Enregistrement d'une charge
    • 20 déc. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security
    Créé le 24 mars 1975
    Livré le 21 avr. 1975
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Securing £12,350.000 debenture stock of the company secured by a trust deed dated 18TH may 1973 and deeds supplemental thereto.
    Brèves mentions
    Heritable subjects in the city of edinburgh extending to 6.545 acres as described in disposition by rank city wall overseas limited, to the company together with office clock thereon known as trinity park house, south trinity road, but excepting therefrom area of ground described therein extending 3886 metres west 34.138 metres on south, 29.261 metres on east and 24,544 metres on north.
    Personnes ayant droit
    • Eagle Star Insurance Co LTD.,
    Transactions
    • 21 avr. 1975Enregistrement d'une charge
    • 20 déc. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Series of debentures
    Créé le 02 janv. 1975
    Livré le 14 janv. 1975
    Totalement satisfaite
    Personnes ayant droit
    • Eagle Star Insurance Co. LTD.
    Transactions
    • 14 janv. 1975Enregistrement d'une charge
    • 20 déc. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Series of debentures
    Créé le 02 janv. 1974
    Livré le 18 janv. 1974
    Totalement satisfaite
    Personnes ayant droit
    • Eagle Star Insurance Company LTD
    Transactions
    • 18 janv. 1974Enregistrement d'une charge
    • 15 août 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Supplemental trust deed
    Créé le 31 oct. 1973
    Acquis le 31 oct. 1974
    Livré le 21 nov. 1974
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Debenture stock of the company amounting to £10,000,000 secured on property acquired by that company on the 31/10/74
    Brèves mentions
    The gloucester, harrington gardens, kensington, london.
    Personnes ayant droit
    • Eagle Star Insurance Co. LTD
    Transactions
    • 21 nov. 1974Enregistrement d'une charge
    • 15 août 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Trust deed
    Créé le 08 mai 1973
    Acquis le 31 oct. 1973
    Livré le 12 nov. 1973
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    A debenture stock amounting to £5,000.000 outstanding and secured on property acquired by the company on the 31ST oct 1973
    Brèves mentions
    F/H property known as as klingfield house portsmouth.(note this property was replaced under the terms of a deed of release dated 11TH june 1976 by property at east kilbride shopping centre).
    Personnes ayant droit
    • Eagle Star Insurance Company LTD
    Transactions
    • 12 nov. 1973Enregistrement d'une charge
    • 01 nov. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 18 août 1966
    Acquis le 29 oct. 1973
    Livré le 15 nov. 1973
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Sterling pounds 164,550
    Brèves mentions
    F/H part of the site birmingham garages navigation street and in site of 101 to 107 (odd) john bright street l/h part ofthe site of birmingham garages navigation street john parish.
    Personnes ayant droit
    • Scottish Life Assurance Companys Limited
    Transactions
    • 15 nov. 1973Enregistrement d'une charge
    Disposition presented for registration in register of sasines on 15TH july 1949
    Créé le 10 mai 1949
    Livré le 18 juil. 1949
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For securing £1,000,000 debenture stock and a premium of 1% in certain events secured by trust deeds dated 1/1/47 and 30/11/48
    Brèves mentions
    Rutland square picture house, edinburgh, the goodwill of the business carried on therein, the whole plant, machinery, furniture, fixtures, fittings & effects present & future and all war damage claims.
    Personnes ayant droit
    • The Law Debenture Corporation LTD
    Transactions
    • 18 juil. 1949Enregistrement d'une charge
    • 20 déc. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Disposition
    Créé le 20 janv. 1948
    Livré le 11 févr. 1948
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £1,000,000 deb. Stock & a premium of 1% in certain events secured by a trust deed dated 1 jan 1947.
    Brèves mentions
    St. Andrew square picture house, clyde street, edinburgh & the whole fixtures, furnishings, fittings & equipment therein contained.
    Personnes ayant droit
    • Law Debenture Corporation LTD.
    Transactions
    • 11 févr. 1948Enregistrement d'une charge
    • 20 déc. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental trust deed
    Créé le 31 mars 1942
    Livré le 08 avr. 1942
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Further security for £450,000 secured debenture stock secured by trust deed dated 4/2/36
    Brèves mentions
    Gaumont cinema, holloway road, tufnell park together with all buildings fixtures fixed plant & machinery thereon. And all rights powers and easements appurtenant thereto.
    Personnes ayant droit
    • Law Debenture Corporation LTD
    Transactions
    • 08 avr. 1942Enregistrement d'une charge
    • 15 août 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Supplemental trust deed
    Créé le 04 mars 1942
    Livré le 17 mars 1942
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Further security for £2,250,000 debenture stock secured by trust deed dated 16/10/38
    Brèves mentions
    Gaumont cinema, holloway road, tufnell park together with all buildings fixtures fixed plant & machinery thereon.
    Personnes ayant droit
    • Law Debenture Corporation LTD
    Transactions
    • 17 mars 1942Enregistrement d'une charge
    • 04 sept. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Trust deed supplemental to trust deed dated 16/10/28
    Créé le 15 août 1938
    Livré le 24 août 1938
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For securing £2,250,000 first mortgage debenture stock and premium of 3%
    Brèves mentions
    Certain holdings of subsidiary companies in haymarket capit LTD.
    Personnes ayant droit
    • Law Debenture Corporation LTD
    Transactions
    • 24 août 1938Enregistrement d'une charge
    • 15 août 2013Satisfaction d'une charge (MR04)

    CITY WALL (HOLDINGS) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    15 déc. 2016Commencement of winding up
    07 sept. 2019Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Alan John Roberts
    Kensington Chambers 46-50 Kensington Place
    St Helier
    JE1 1ET Jersey
    Channel Isles
    practitioner
    Kensington Chambers 46-50 Kensington Place
    St Helier
    JE1 1ET Jersey
    Channel Isles
    Sean Kenneth Croston
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    practitioner
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0