GARTMORE SMALLER COMPANIES TRUST P.L.C

GARTMORE SMALLER COMPANIES TRUST P.L.C

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGARTMORE SMALLER COMPANIES TRUST P.L.C
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société 00230109
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GARTMORE SMALLER COMPANIES TRUST P.L.C ?

    • (6523) /

    Où se situe GARTMORE SMALLER COMPANIES TRUST P.L.C ?

    Adresse du siège social
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de GARTMORE SMALLER COMPANIES TRUST P.L.C ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    LONDON & STRATHCLYDE TRUST P L C30 avr. 192830 avr. 1928

    Quels sont les derniers comptes de GARTMORE SMALLER COMPANIES TRUST P.L.C ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 août 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour GARTMORE SMALLER COMPANIES TRUST P.L.C ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 14 juin 2013

    5 pages4.68

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    3 pages4.71

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 02 févr. 2013

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 02 août 2012

    6 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 02 févr. 2012

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 02 août 2011

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 02 févr. 2011

    5 pages4.68

    Cessation de la nomination de Carol Ferguson en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Lynn Ruddick en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 02 août 2010

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 02 févr. 2010

    7 pages4.68

    legacy

    1 pages288b

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 03 févr. 2009

    LRESSP

    legacy

    1 pages287

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Company business 03/02/2009
    RES13

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    Résolutions

    Resolutions
    5 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01
    capital

    Résolution de modification des droits ou de la dénomination des actions

    RES12
    capital

    Résolutions

    Transfer agreement 26/01/2009
    RES13

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    Résolutions

    Resolutions
    61 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Re class shrs 26/01/2009
    RES13
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Qui sont les dirigeants de GARTMORE SMALLER COMPANIES TRUST P.L.C ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GARTMORE INVESTMENT LIMITED
    Gartmore House
    8 Fenchurch Place
    EC3M 4PB London
    Secrétaire
    Gartmore House
    8 Fenchurch Place
    EC3M 4PB London
    37566460002
    ALLAN, William Campbell
    34 Smith Street
    Chelsea
    SW3 4EP London
    Administrateur
    34 Smith Street
    Chelsea
    SW3 4EP London
    EnglandBritishCompany Director84460001
    BAILLIE, Robin Alexander Macdonald
    19 Post Office Square
    London Road
    TN1 1BQ Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    19 Post Office Square
    London Road
    TN1 1BQ Tunbridge Wells
    Kent
    BritishCompany Director26138380004
    FERGUSON, Carol Cecilia
    Oakdene Court
    613 Reading Road
    RG41 5UA Winnersh
    Vernalis Plc
    Berkshire
    Administrateur
    Oakdene Court
    613 Reading Road
    RG41 5UA Winnersh
    Vernalis Plc
    Berkshire
    IrelandBritishChartered Accountant13529700004
    KANE, William James
    Connaught Works
    251 Old Ford Road
    E3 5PS London
    54
    Administrateur
    Connaught Works
    251 Old Ford Road
    E3 5PS London
    54
    BritishManaging Director73972820003
    RICE, Peter Anthony
    6 Redington Road
    NW3 7RG London
    Administrateur
    6 Redington Road
    NW3 7RG London
    United KingdomBritishActuary18297230001
    RUDDICK, Lynn Christine
    Jasmine Cottage
    Riverside Road West
    PL8 1AD Newton Ferrers
    Devon
    Administrateur
    Jasmine Cottage
    Riverside Road West
    PL8 1AD Newton Ferrers
    Devon
    EnglandBritishNon Executive Director And Tru99381720001
    SEVIN, Phillipe
    20 Rue Louis David
    Paris 75 1116
    France
    Administrateur
    20 Rue Louis David
    Paris 75 1116
    France
    FrenchCompany Director32475180001
    STRUTHERS, Alastair James
    Craigmaddie
    Milngavie
    G62 8LB Glasgow
    Administrateur
    Craigmaddie
    Milngavie
    G62 8LB Glasgow
    ScotlandBritishCompany Director213130001
    WADDELL, Gordon Herbert
    43 Elm Park Gardens
    SW10 9PA London
    Administrateur
    43 Elm Park Gardens
    SW10 9PA London
    BritishCompany Director3200870005
    WALTON, Michael Edward D'Arcy
    39 Frewin Road
    SW18 3LR London
    Administrateur
    39 Frewin Road
    SW18 3LR London
    EnglandBritishCompany Director34866270001

    GARTMORE SMALLER COMPANIES TRUST P.L.C a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 18 déc. 1972
    Livré le 04 janv. 1973
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Second floating charge over all the company's undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital. (See doc 148).
    Personnes ayant droit
    • Manufacturers Hanover Trust Company
    Transactions
    • 04 janv. 1973Enregistrement d'une charge
    • 27 août 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 juin 1968
    Livré le 25 juin 1968
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Usd 1,000,000 (united state dollars)
    Brèves mentions
    Undertaking and all property present and future including uncalled capital. Second floating charge see doc 132 for pursuant details.
    Personnes ayant droit
    • Manufacturers Hanover Trust Company
    Transactions
    • 25 juin 1968Enregistrement d'une charge
    • 27 août 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental trust deed
    Créé le 01 juin 1950
    Livré le 20 août 1963
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Debenture stock and debentures not exceeding the nominal amount of the share capital of the company
    Personnes ayant droit
    • Royal Exchange Assurance
    Transactions
    • 20 août 1963Enregistrement d'une charge
    • 28 janv. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental trust deed
    Créé le 01 juin 1950
    Livré le 02 févr. 1959
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Debenture stock and debentures not exceeding the nominal amount of the share capital of the company
    Personnes ayant droit
    • Royal Exchange Assurance
    Transactions
    • 02 févr. 1959Enregistrement d'une charge
    • 28 janv. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental trust deed
    Créé le 01 juin 1950
    Livré le 23 déc. 1954
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Debenture stock and debentures not exceeding the nominal amount of the share capital of the company
    Personnes ayant droit
    • Royal Exchange Assurance
    Transactions
    • 23 déc. 1954Enregistrement d'une charge
    • 28 janv. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental trust deed
    Créé le 01 juin 1950
    Livré le 18 mars 1954
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Debenture stock and debentures not exceeding the amount of the nominal share capital of the company
    Personnes ayant droit
    • Royal Exchange Assurance
    Transactions
    • 18 mars 1954Enregistrement d'une charge
    • 28 janv. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental trust deed
    Créé le 01 juin 1950
    Livré le 09 déc. 1952
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Debenture stock and debentures not exceeding the nominal amount of the share capital of the company
    Personnes ayant droit
    • Royal Exchange Assurance
    Transactions
    • 09 déc. 1952Enregistrement d'une charge
    • 28 janv. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental trust deed
    Créé le 01 juin 1950
    Livré le 14 juil. 1951
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Debenture stock and debentures not exceeding the nominal amount of the share capital of the company
    Personnes ayant droit
    • Royal Exchange Assurance
    Transactions
    • 14 juil. 1951Enregistrement d'une charge
    • 28 janv. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental trust deed
    Créé le 01 juin 1950
    Livré le 02 juil. 1951
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Debenture stock and debentures not exceeding the nominal amount of the share capital of the company
    Personnes ayant droit
    • Royal Exchange Assurance
    Transactions
    • 02 juil. 1951Enregistrement d'une charge
    • 28 janv. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental trust deed
    Créé le 01 juin 1950
    Livré le 27 juil. 1950
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Debenture stock and debentures not exceeding the nominal amount of the share capital of the company
    Personnes ayant droit
    • Royal Exchange Assurance
    Transactions
    • 27 juil. 1950Enregistrement d'une charge
    • 28 janv. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 28 janv. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 30 janv. 2009
    Supplemental trust deed
    Créé le 01 juin 1950
    Livré le 20 juin 1950
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Debenture stock and debentures not exceeding the nominal amount of the share capital of the company
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Royal Exchange Assurance
    Transactions
    • 20 juin 1950Enregistrement d'une charge
    • 28 janv. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Trust deed.
    Créé le 10 sept. 1928
    Livré le 13 sept. 1928
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    An amount of deb. Stock not exceeding the nominal amt. Of the share capital for time being issued
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Royal Exchange Assurance
    Transactions
    • 13 sept. 1928Enregistrement d'une charge
    • 28 janv. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    GARTMORE SMALLER COMPANIES TRUST P.L.C a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    03 févr. 2009Commencement of winding up
    25 sept. 2013Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Patrick Joseph Brazzill
    Ernst & Young
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    practitioner
    Ernst & Young
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Colin Peter Dempster
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    practitioner
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0