00230111 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la société00230111 LIMITED
    Statut de la sociétéLiquidation
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00230111
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de 00230111 LIMITED ?

    • (6110) /

    Où se situe 00230111 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Bulman House Regent Centre
    Gosforth
    NE3 3LS Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de 00230111 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    POWELL DUFFRYN SHIPPING LIMITED 31 oct. 198631 oct. 1986
    STEPHENSON CLARKE (SHIPPING) LIMITED30 avr. 192830 avr. 1928

    Quels sont les derniers comptes de 00230111 LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 mars 2011
    Date d'échéance des prochains comptes31 déc. 2011
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2010

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour 00230111 LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au20 juin 2017
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation04 juil. 2017
    En retardOui

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour 00230111 LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour 00230111 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Restauration par ordonnance du tribunal - précédemment en liquidation volontaire de créanciers

    4 pagesREST-CVL

    Certificat de changement de nom

    Company name changed stephenson clarke shipping\certificate issued on 21/05/20
    pagesCERTNM

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    1 pagesDISS16(SOAS)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Restauration par ordonnance du tribunal

    4 pagesAC92

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    18 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 02 août 2013

    23 pages4.68

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    2 pagesF10.2

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    9 pages4.20

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation

    LRESEX

    Changement d'adresse du siège social de * Eldon Court Percy Street Newcastle upon Tyne NE99 1TD* le 01 août 2012

    2 pagesAD01

    legacy

    3 pagesMG04

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Qui sont les dirigeants de 00230111 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CAMPBELL, Russell Kenneth
    Highfield
    North Bank, Haydon Bridge
    NE47 6LY Hexham
    Northumberland
    Secrétaire
    Highfield
    North Bank, Haydon Bridge
    NE47 6LY Hexham
    Northumberland
    British26948290004
    CAMPBELL, Russell Kenneth
    Highfield
    North Bank, Haydon Bridge
    NE47 6LY Hexham
    Northumberland
    Administrateur
    Highfield
    North Bank, Haydon Bridge
    NE47 6LY Hexham
    Northumberland
    United KingdomBritishCompany Secrtary26948290004
    GILMOUR, Barry Edward Kerr
    Heatherlands House
    East Road
    NE65 8FY Longhorsley
    Northumberland
    Administrateur
    Heatherlands House
    East Road
    NE65 8FY Longhorsley
    Northumberland
    United KingdomBritishCompany Director20361920009
    PLANT, William Allan
    1 Barnard Court
    Woodstone Village
    DH4 6TS Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    Administrateur
    1 Barnard Court
    Woodstone Village
    DH4 6TS Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishCompany Director87465680003
    CHRISTIAN, Kevin
    12 Close Quane
    IM5 1PY Peel
    Isle Of Man
    Secrétaire
    12 Close Quane
    IM5 1PY Peel
    Isle Of Man
    BritishChartered Accountant54761610001
    MAHONY, Peter John
    8 Harlesden Road
    Harold Hill
    RM3 9HT Romford
    Essex
    Secrétaire
    8 Harlesden Road
    Harold Hill
    RM3 9HT Romford
    Essex
    British31909050001
    ANDREWS, William George
    Two Acres Cottage Middleton Road
    GU15 3TT Camberley
    Surrey
    Administrateur
    Two Acres Cottage Middleton Road
    GU15 3TT Camberley
    Surrey
    BritishCompany Director58542770001
    CHRISTIAN, Kevin
    12 Close Quane
    IM5 1PY Peel
    Isle Of Man
    Administrateur
    12 Close Quane
    IM5 1PY Peel
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritishChartered Accountant54761610001
    KINGSLEY-SMITH, Trevor
    Dyke Row Cottage
    Newbrough
    NE47 5BE Hexham
    Northumberland
    Administrateur
    Dyke Row Cottage
    Newbrough
    NE47 5BE Hexham
    Northumberland
    United KingdomBritishNaval Architect68419630005
    MCLEAN, Robert Urquhart
    8 Hadrian Court
    Ponteland
    NE20 9JU Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Administrateur
    8 Hadrian Court
    Ponteland
    NE20 9JU Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    BritishCompany Director29101050002
    MCLEAN, Robert Urquhart
    8 Hadrian Court
    Ponteland
    NE20 9JU Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Administrateur
    8 Hadrian Court
    Ponteland
    NE20 9JU Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    BritishFleet Manager29101050002
    PEACOCK, Gary Joseph
    1 Kiln Rise
    Whickham
    NE16 5QN Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Administrateur
    1 Kiln Rise
    Whickham
    NE16 5QN Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishChartering Director163677680001
    PEILE, Charles Henry Whitaker
    The Old Rectory
    Simonburn
    NE48 3AR Hexham
    Northumberland
    Administrateur
    The Old Rectory
    Simonburn
    NE48 3AR Hexham
    Northumberland
    United KingdomBritishManaging Director103171190001
    POWELL, Michael John Alexander
    Pondfield
    376 Sandhurst Lane
    TN25 4PF Ashford
    Kent
    Administrateur
    Pondfield
    376 Sandhurst Lane
    TN25 4PF Ashford
    Kent
    BritishCompany Director25791770002
    SHUTTLEWORTH, David Andrew
    158 Edge Hill
    Ponteland
    NE20 9JN Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Administrateur
    158 Edge Hill
    Ponteland
    NE20 9JN Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    BritishCompany Director67100520005
    WALKER, Geoffrey
    Ivy House 11 King Street
    PO10 7AX Emsworth
    Hampshire
    Administrateur
    Ivy House 11 King Street
    PO10 7AX Emsworth
    Hampshire
    BritishChartered Secretary918890001
    WATKINS, David Tyrrell
    Redheugh
    Tarset
    NE48 1NB Hexham
    Northumberland
    Administrateur
    Redheugh
    Tarset
    NE48 1NB Hexham
    Northumberland
    United KingdomBritishCompany Director15566730001

    00230111 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage debenture
    Créé le 25 nov. 2011
    Livré le 30 nov. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transactions
    • 30 nov. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Second priority statutory ship mortgage
    Créé le 25 juil. 2011
    Livré le 10 août 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    M.V.newcastle official no 9091931 and her boats and appurtenances see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC
    Transactions
    • 10 août 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 22 août 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Second priority statutory ship mortgage
    Créé le 25 juil. 2011
    Livré le 05 août 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    100% shares in the vessel M.V. durrington official number 390778 and her boats and appurtenances see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC
    Transactions
    • 05 août 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 04 janv. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Second priority statutory ship mortgage
    Créé le 25 juil. 2011
    Livré le 05 août 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    100% shares in the vessel M.V. storrington official number 399033 and her boats and appurtenances see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC
    Transactions
    • 05 août 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 04 janv. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A second deed of assignment
    Créé le 25 juil. 2011
    Livré le 05 août 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The earnings insurances and requisition compensation in relation to M.V. newcastle official number 9191931 see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC
    Transactions
    • 05 août 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 22 août 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A second deed of assignment
    Créé le 25 juil. 2011
    Livré le 05 août 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The earnings insurances and requisition compensation in relation to M.V. durrington official number 390778 see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC
    Transactions
    • 05 août 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 04 janv. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A second deed of assignment
    Créé le 25 juil. 2011
    Livré le 05 août 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The earnings insurances and requisition compensation in relation to M.V. storrington official number 399033 see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC
    Transactions
    • 05 août 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 04 janv. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A second deed of covenants
    Créé le 25 juil. 2011
    Livré le 05 août 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The earnings insurances and requisition compensation in relation to M.V. storrington official number 399033 see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC
    Transactions
    • 05 août 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 04 janv. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A second deed of covenants
    Créé le 25 juil. 2011
    Livré le 05 août 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The earnings insurances and requisition compensation in relation to M.V. durrington official number 390778 see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC
    Transactions
    • 05 août 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 04 janv. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A second deed of covenants
    Créé le 25 juil. 2011
    Livré le 05 août 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The earnings insurances and requisition compensation in relation to M.V. newcastle official number 9191931 see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC
    Transactions
    • 05 août 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 22 août 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of covenants
    Créé le 09 juin 2008
    Livré le 21 juin 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Assign the earnings, insurances and requisition compensation see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC
    Transactions
    • 21 juin 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 août 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    First priority statutory ship mortgage
    Créé le 09 juin 2008
    Livré le 21 juin 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The mortgagor assigns the mortgage over 100% of the shares of the vessel being mv newcastle ex mv sandy official no. 9191931 see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC
    Transactions
    • 21 juin 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 août 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of assignment
    Créé le 09 juin 2008
    Livré le 21 juin 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The earnings insurances and requisition compensation see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC
    Transactions
    • 21 juin 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 août 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Statutory mortgage
    Créé le 05 août 2005
    Livré le 19 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    64/64THS shares of and in M.V. kielder registered in the name of the company under isle of man flag at the port of douglas under official number 737083.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juil. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of covenant
    Créé le 05 août 2005
    Livré le 19 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The mortgaged property being the ship, the earnings and the requisition compensation. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juil. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Statutory mortgage
    Créé le 15 sept. 1997
    Livré le 30 sept. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current regulated by a composite guarantee and debenture dated 13TH september 1997 and a deed of covenant also dated 13TH september 1997
    Brèves mentions
    Sixty-four sixty fourths (64/64THS) shares of and in M.V.birling registered in the name of the company under isle of man flag at the port of douglas under official number 377461.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 sept. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 oct. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Statutory mortgage
    Créé le 15 sept. 1997
    Livré le 30 sept. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current regulated by a composite guarantee and debenture dated 13TH september 1997 and a deed of covenant also dated 13TH september 1997
    Brèves mentions
    Sixty-four sixty fourths (64/64THS) shares of and in M.V.durrington registered in the name of the company under isle of man flag at the port of douglas under official number 390778.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 sept. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 janv. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Statutory mortgage
    Créé le 15 sept. 1997
    Livré le 30 sept. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current regulated by a composite guarantee and debenture dated 13TH september 1997 and a deed of covenant also dated 13TH september 1997
    Brèves mentions
    Sixty-four sixty fourths (64/64THS) shares of and in M.v sea amethyst registered in the name of the company under isle of man flag at the port of douglas under official number 722397.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 sept. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juil. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Statutory mortgage
    Créé le 15 sept. 1997
    Livré le 30 sept. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current regulated by a composite guarantee and debenture dated 13TH september 1997 and a deed of covenant also dated 13TH september 1997
    Brèves mentions
    Sixty-four sixty fourths (64/64THS) shares of and in M.V.donnington registered in the name of the company under isle of man flag at the port of douglas under official number 365896.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 sept. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Statutory mortgage
    Créé le 15 sept. 1997
    Livré le 30 sept. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current regulated by a composite guarantee and debenture dated 13TH september 1997 and a deed of covenant also dated 13TH september 1997
    Brèves mentions
    Sixty-four sixty fourths (64/64THS) shares of and in M.V.dallington registered in the name of the company under isle of man flag at the port of douglas under official number 365968.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 sept. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 02 avr. 2009
    • 27 mai 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Statutory mortgage
    Créé le 15 sept. 1997
    Livré le 30 sept. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current regulated by a composite guarantee and debenture dated 13TH september 1997 and a deed of covenant also dated 13TH september 1997
    Brèves mentions
    Sixty-four sixty fourths (64/64THS) shares of and in M.V.steyning registerd in the name of the company under isle of man flag at the port of douglas under official number 705450.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 sept. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 juil. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Statutory mortgage
    Créé le 15 sept. 1997
    Livré le 30 sept. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current regulated by a composite guarantee and debenture dated 13TH september 1997 and a deed of covenant also dated 13TH september 1997
    Brèves mentions
    Sixty-four sixty fourths (64/64THS) shares of and in M.V.harting registered in the name of the company under isle of man flag at the port of douglas under official number 390920.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 sept. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 mars 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Statutory mortgage
    Créé le 15 sept. 1997
    Livré le 30 sept. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current regulated by a composite guarantee and debenture dated 13TH september 1997 and a deed of covenant also dated 13TH september 1997
    Brèves mentions
    Sixty-four sixty fourths (64/64THS) shares of and in M.V.emerald registered in the name of the company under isle of man flag at the port of douglas under official number 377571.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 sept. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Statutory mortgage
    Créé le 15 sept. 1997
    Livré le 30 sept. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current regulated by a composite guarantee and debenture dated 13TH september 1997 and a deed of covenant also dated 13TH september 1997
    Brèves mentions
    Sixty-four sixty fourths (64/64THS) shares of and in M.V.storrington registered in the name of the company under isle of man flag at the port of douglas under official number 399033.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 sept. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 janv. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Assignment
    Créé le 13 sept. 1997
    Livré le 03 oct. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the security documents (as defined)
    Brèves mentions
    The ship (as defined) as it is constructed; the shipbuilding contract (as defined) including the right to take delivery of the ship and the refund guarantees (as defined) including all sums at any time payable to the company pursuant to or as damages or agreed compensation for breach of, or by way of payment in respect of any termination or amendment or any of them. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 03 oct. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    00230111 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    03 août 2012Commencement of winding up
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Allan David Kelly
    Tenon House Ferryboat Lane
    SR5 3JN Sunderland
    Tyne And Wear
    practitioner
    Tenon House Ferryboat Lane
    SR5 3JN Sunderland
    Tyne And Wear
    Gordon Smythe Goldie
    Tait Walker
    Bulman House
    NE3 3LS Regent Centre, Gosforth
    Newcastle Upon Tyne
    practitioner
    Tait Walker
    Bulman House
    NE3 3LS Regent Centre, Gosforth
    Newcastle Upon Tyne

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0