EUROPA PUBLICATIONS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | EUROPA PUBLICATIONS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00230964 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe EUROPA PUBLICATIONS LIMITED ?
| Adresse du siège social | Mortimer House 37-41 Mortimer Street W1T 3JH London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de EUROPA PUBLICATIONS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2011 |
Quels sont les derniers dépôts pour EUROPA PUBLICATIONS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Emily Louise Martin le 03 août 2012 | 2 pages | CH03 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
État du capital au 28 juin 2012
| 4 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011 | 9 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Rupert John Joseph Hopley le 01 mars 2012 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 29 janv. 2012 avec liste complète des actionnaires | 8 pages | AR01 | ||||||||||
Nomination de Rupert John Joseph Hopley en tant qu'administrateur le 01 nov. 2011 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Rachel Elizabeth Jacobs en tant que directeur le 16 sept. 2011 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de John William Burton en tant que directeur le 31 août 2011 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Gareth Richard Wright le 19 août 2011 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Roger Graham Horton le 11 févr. 2011 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2010 | 12 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Emily Louise Martin en tant que secrétaire | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Mark Kerswell en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 29 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires | 10 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Miss Julie Louise Wilson le 27 sept. 2010 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Adam Christopher Walker le 05 oct. 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Peter Stephen Rigby le 05 oct. 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Subdivision des actions au 02 sept. 2010 | 5 pages | SH02 | ||||||||||
Subdivision des actions au 02 sept. 2010 | 5 pages | SH02 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de EUROPA PUBLICATIONS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN, Emily Louise | Secrétaire | 37-41 Mortimer Street W1T 3JH London Mortimer House United Kingdom | 160502330001 | |||||||
| WOOLLARD, Julie Louise | Secrétaire | 37/41 Mortimer Street W1T 3JH London Mortimer House England | British | 139159370002 | ||||||
| HOPLEY, Rupert John Joseph | Administrateur | 6300 Zug Gubelstrasse 11 Switzerland | Switzerland | British | 164632060002 | |||||
| HORTON, Roger Graham | Administrateur | Mill Lane Shiplake RG9 3LY Henley-On-Thames Rivermead Oxfordshire United Kingdom | England | British | 56485660003 | |||||
| RIGBY, Peter Stephen | Administrateur | 37/41 Mortimer Street W1T 3JH London Mortimer House England | Switzerland | British | 69164290007 | |||||
| WALKER, Adam Christopher | Administrateur | 37/41 Mortimer Street W1T 3JH London Mortimer House England | Switzerland | British | 129368430002 | |||||
| WRIGHT, Gareth Richard | Administrateur | 37/41 Mortimer Street W1T 3JH London Mortimer House England | England | British | 131115190002 | |||||
| CALLABY, Andrea Mary | Secrétaire | 5 Thornton Drive CO4 5WB Colchester Essex | British | 70352690002 | ||||||
| FOYE, Anthony Martin | Secrétaire | Lynwood White Lane RG26 5TN Hannington Hampshire | British | 99515780001 | ||||||
| HICKFORD, Colin James | Secrétaire | 23 Thornash Close Horsell GU21 4UP Woking Surrey | British | 27692940001 | ||||||
| MILTON, Michael Robin | Secrétaire | Tudor Court Finch Lane Knotty Green HP9 2TL Beaconsfield Buckinghamshire | British | 9149150001 | ||||||
| RICHMOND, Sonia Anna | Secrétaire | 8 Viscount Gardens KT14 6HE Byfleet Surrey | British | 118535490002 | ||||||
| THOMASSON, Jeffrey Scott | Secrétaire | 24 Webster Road SE16 4DF London | American | 64473410003 | ||||||
| BURTON, John William | Administrateur | Mortimer House 37-41 Mortimer Street W1T 3JH London | United Kingdom | British | 113684810001 | |||||
| CONIBEAR, Jonathan James Garnham | Administrateur | The Grange Mill Street OX5 2SY Islip Oxon | United Kingdom | British | 258970950001 | |||||
| DESMOND, James Philip | Administrateur | 11 Grasmere Road N10 2DH London | England | British | 73339390001 | |||||
| FOYE, Anthony Martin | Administrateur | Lynwood White Lane RG26 5TN Hannington Hampshire | United Kingdom | British | 99515780001 | |||||
| GILBERTSON, David Stuart | Administrateur | Casa Maria Spaniard's End Hampstead NW3 7JG London | United Kingdom | British | 10921820004 | |||||
| HUGHES, Rodney Martin | Administrateur | 8 Kerdistone Close Little Heath EN6 1LG Potters Bar Hertfordshire | British | 27669690001 | ||||||
| HUTTON, Jeremy John | Administrateur | Stagden Cross House High Easter CM1 4QY Chelmsford Essex | British | 50613140001 | ||||||
| JACKSON, Peter George Clark | Administrateur | 44 West Drive Cheam SM2 7NA Sutton Surrey | British | 27669700001 | ||||||
| JACOBS, Rachel Elizabeth | Administrateur | 37/41 Mortimer Street W1T 3JH London Mortimer House England | United Kingdom | British | 92334500004 | |||||
| KELLY, Paul Francis | Administrateur | 59 Argyle Gardens RM14 3HH Upminster Essex | British | 57049650001 | ||||||
| KERSWELL, Mark Henry | Administrateur | 37/41 Mortimer Street W1T 3JH London Mortimer House England | England | British | 82609620003 | |||||
| MARTIN, Clive Haydn, Sir | Administrateur | Weatherbury 16 Heath Road EN6 1LN Potters Bar Hertfordshire | England | British | 7690350001 | |||||
| MCGINLEY, Patrick Anthony | Administrateur | 6 Hazelmere Road Petts Wood BR5 1PB Orpington Kent | British | 27669710001 | ||||||
| MILTON, Michael Robin | Administrateur | The Hollies Soldridge Road Medstead GU34 5JF Alton Hampshire | British | 9149150002 | ||||||
| NEAL, Stephen Bryan | Administrateur | 5 Acer Avenue TN2 5JQ Tunbridge Wells Kent | British | 23978960001 | ||||||
| OLIVER, Alan Geoffrey | Administrateur | 23 Beresford Road Chingford E4 6ED London | British | 27669720001 | ||||||
| QUINNEY, John | Administrateur | Button Hide Seven Hills Road KT11 1ER Cobham Surrey | British | 9149160001 | ||||||
| R, Peter | Administrateur | Appledown House The Croft GL7 4BB Fairford Gloucestershire | British | 125327660001 | ||||||
| SELVEY, Anthony Rochford | Administrateur | 14 Monterey Close DA5 2BX Bexley Kent | British | 6037980001 | ||||||
| SMITH, David John | Administrateur | 10 South Close RG40 2DJ Wokingham Berkshire | England | British | 81852060001 | |||||
| THOMASSON, Jeffrey Scott | Administrateur | 24 Webster Road SE16 4DF London | England | American | 64473410003 |
EUROPA PUBLICATIONS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 08 mai 1987 Livré le 14 mai 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of accession | Créé le 26 févr. 1986 Livré le 04 mars 1986 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever and all other monies due to citibank na. Under the terms of a composite guarantee and debenture dated 30.9.85. | |
Brèves mentions (Please see doc M120). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0