FIRST CARTON PAZO LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFIRST CARTON PAZO LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00238339
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FIRST CARTON PAZO LTD ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe FIRST CARTON PAZO LTD ?

    Adresse du siège social
    C/O Teneo Restructuring Limited 156 Great Charles Street
    Queensway
    B3 3HN Birmingham
    West Midlands
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de FIRST CARTON PAZO LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    LAWSON MARDON PAZO LTD.01 mai 199401 mai 1994
    LMG PAZO LIMITED30 mars 198930 mars 1989
    PAZO COMPANY LIMITED(THE)30 mars 192930 mars 1929

    Quels sont les derniers comptes de FIRST CARTON PAZO LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour FIRST CARTON PAZO LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    11 pagesLIQ13

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Suite 5, 2nd Floor, Aspect House Bennerley Road Nottingham United Kingdom NG6 8WR

    2 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Suite 5, 2nd Floor, Aspect House Bennerley Road Nottingham United Kingdom NG6 8WR

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN à C/O Teneo Restructuring Limited 156 Great Charles Street Queensway Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN le 06 sept. 2021

    2 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de Hill House, 1 Little New Street London EC4A 3TR à 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN le 28 juin 2021

    2 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 11 mai 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de Suite 5, 2nd Floor Aspect House Nottingham NG6 8WR United Kingdom à Hill House, 1 Little New Street London EC4A 3TR le 27 mars 2021

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Déclaration de solvabilité

    6 pagesLIQ01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 08 mars 2021

    LRESSP

    legacy

    2 pagesSH20

    État du capital au 19 févr. 2021

    • Capital: GBP 1.375
    3 pagesSH19

    legacy

    2 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Changement d'adresse du siège social de Millennium Way West Phoenix Centre Nottingham Nottinghamshire NG8 6AW à Suite 5, 2nd Floor Aspect House Nottingham NG6 8WR le 16 nov. 2020

    1 pagesAD01

    Nomination de Mr David Hickey Sharkey Ii en tant qu'administrateur le 04 nov. 2020

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Neil Wilkinson en tant que directeur le 04 nov. 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Andrew Darrington en tant que directeur le 04 nov. 2020

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 11 mai 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2019

    9 pagesAA

    Nomination de Mr Neil Wilkinson en tant qu'administrateur le 28 nov. 2019

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Kevin Alden Maxwell en tant qu'administrateur le 28 nov. 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Mark Richard Priestley en tant que secrétaire le 28 nov. 2019

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Mark Richard Priestley en tant que directeur le 28 nov. 2019

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de FIRST CARTON PAZO LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MAXWELL, Kevin Alden
    Abernathy Road Ne
    Suite 125
    30328 Atlanta
    1000
    Ga
    United States
    Administrateur
    Abernathy Road Ne
    Suite 125
    30328 Atlanta
    1000
    Ga
    United States
    United StatesAmericanAttorney256366640001
    SHARKEY II, David Hickey
    Abernathy Road Ne
    30328 Atlanta
    1000
    Ga
    United States
    Administrateur
    Abernathy Road Ne
    30328 Atlanta
    1000
    Ga
    United States
    United StatesAmericanSvp Tax276234820001
    ANTHONY WILKINSON, Katherine Frances
    Cranbrook 65 Long Ashton Road
    Long Ashton
    BS41 9HW Bristol
    Avon
    Secrétaire
    Cranbrook 65 Long Ashton Road
    Long Ashton
    BS41 9HW Bristol
    Avon
    BritishSolicitor75095790002
    DE VROOME, Peter John
    39a Avenue Gardens
    W3 8HB London
    Secrétaire
    39a Avenue Gardens
    W3 8HB London
    British47914660001
    HALSTEAD, John Stephen
    Cherry Trees Old Hill
    Flyford Flavell
    WR7 4DA Worcester
    Worcestershire
    Secrétaire
    Cherry Trees Old Hill
    Flyford Flavell
    WR7 4DA Worcester
    Worcestershire
    British22085100001
    HASELDEN, Mark Gordon Holderer
    Pedders Way
    Stratford Road Loxley
    CV35 9JN Warwick
    Warwickshire
    Secrétaire
    Pedders Way
    Stratford Road Loxley
    CV35 9JN Warwick
    Warwickshire
    BritishCompany Director64851340002
    KUDO, Machiko
    76 St Peters Street
    N1 8JS London
    Secrétaire
    76 St Peters Street
    N1 8JS London
    British84667740002
    MARCHIONNE, Sergio
    Mugerenmatt 25
    Cham
    Ch 6330
    Switzerland
    Secrétaire
    Mugerenmatt 25
    Cham
    Ch 6330
    Switzerland
    CanadianGroup Vice President34262600002
    PRIESTLEY, Mark Richard
    Old Farm Court
    HP18 0SU Grendon Underwood
    2 Old Farm Court
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Old Farm Court
    HP18 0SU Grendon Underwood
    2 Old Farm Court
    Buckinghamshire
    British275589400001
    SCULLY, Richard Andrew
    6 Sawmill Road
    Longwick
    HP27 9TD Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    6 Sawmill Road
    Longwick
    HP27 9TD Princes Risborough
    Buckinghamshire
    British63194950001
    SISEC LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Secrétaire
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    38545840001
    BLOOMFIELD, Terence James
    Windaby Whyburn Lane
    Hucknall
    NG15 6QN Nottingham
    Administrateur
    Windaby Whyburn Lane
    Hucknall
    NG15 6QN Nottingham
    BritishCompany Director61684540001
    DARRINGTON, Andrew
    Millennium Way West
    Phoenix Centre
    NG8 6AW Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Millennium Way West
    Phoenix Centre
    NG8 6AW Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishFinancial Controller207397840001
    DONOGHUE, Alan Barry
    8 Nobury Hill
    Midsummer Park
    WR7 4HA Inkberrow
    Worcestershire
    Administrateur
    8 Nobury Hill
    Midsummer Park
    WR7 4HA Inkberrow
    Worcestershire
    BritishCompany Director10542730001
    FALLER, Guy Nicholas Anthony
    180 Hermitage Road
    GU21 8XQ Woking
    Surrey
    Administrateur
    180 Hermitage Road
    GU21 8XQ Woking
    Surrey
    United KingdomBritishCorporate Controller108529830002
    GALLAGHER, Graham
    23 Church Street
    WR11 6DY Evesham
    Worcestershire
    Administrateur
    23 Church Street
    WR11 6DY Evesham
    Worcestershire
    BritishCompany Director74498190002
    GILCHRIST, Keith
    Tudor House
    Devonshire Avenue
    HP6 5JF Amersham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Tudor House
    Devonshire Avenue
    HP6 5JF Amersham
    Buckinghamshire
    BritishDirector124301670001
    GRASSELLI, Massimo
    Via Compagnoni 42
    20129 Milan
    Italy
    Administrateur
    Via Compagnoni 42
    20129 Milan
    Italy
    ItalianGroup Vice President37223040002
    HALSTEAD, John Stephen
    Cherry Trees Old Hill
    Flyford Flavell
    WR7 4DA Worcester
    Worcestershire
    Administrateur
    Cherry Trees Old Hill
    Flyford Flavell
    WR7 4DA Worcester
    Worcestershire
    BritishChartered Accountant22085100001
    HALSTEAD, John Stephen
    Church Garth Radford Road
    Flyford Flavell
    WR7 4BS Worcester
    Administrateur
    Church Garth Radford Road
    Flyford Flavell
    WR7 4BS Worcester
    BritishDirector22085100002
    HASELDEN, Mark Gordon Holderer
    Pedders Way
    Stratford Road Loxley
    CV35 9JN Warwick
    Warwickshire
    Administrateur
    Pedders Way
    Stratford Road Loxley
    CV35 9JN Warwick
    Warwickshire
    BritishCompany Director64851340002
    HOULE, Leo
    35 Rue De La Pompe
    75116 Paris
    France
    Administrateur
    35 Rue De La Pompe
    75116 Paris
    France
    CanadianGroup Vice President42198540002
    JERMAN, Allen James Crawford
    14 Hartopp Road
    Fouroaks
    B74 2RQ Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    14 Hartopp Road
    Fouroaks
    B74 2RQ Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director154902080001
    JOHNSTONE, Alan Thomas
    Church Farm
    Valley Road Hughenden Valley
    HP14 4LB High Wycombe
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Church Farm
    Valley Road Hughenden Valley
    HP14 4LB High Wycombe
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director57268270001
    MARCHIONNE, Sergio
    Mugerenmatt 25
    Cham
    Ch 6330
    Switzerland
    Administrateur
    Mugerenmatt 25
    Cham
    Ch 6330
    Switzerland
    CanadianGroup Vice President34262600002
    MATTIUSSI, Andrea
    Via Broletto 30
    20121 Milan 20121
    Italy
    Administrateur
    Via Broletto 30
    20121 Milan 20121
    Italy
    ItalianPresident & Chief Executive Of34192000002
    MIRANDA, Ainsley John
    74 Settrington Road
    SW6 3BA London
    Administrateur
    74 Settrington Road
    SW6 3BA London
    BritishCompany Director45100920002
    NEILL, James
    Manor Cottage Caythorpe Road
    Caythorpe
    NG14 7EB Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Manor Cottage Caythorpe Road
    Caythorpe
    NG14 7EB Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishCompany Director10542720001
    O'CONNELL, Martin Hartley
    Abbeylands
    Stackhouse
    BD24 0DN Settle
    North Yorkshire
    Administrateur
    Abbeylands
    Stackhouse
    BD24 0DN Settle
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector111609860001
    PATMORE, Alan William
    71 Church Road
    Combe Down
    BA2 5JQ Bath
    Avon
    Administrateur
    71 Church Road
    Combe Down
    BA2 5JQ Bath
    Avon
    United KingdomBritishAccountant8590040001
    PIERCE, Stephen Keith
    16 All Saints Avenue
    SL6 6EW Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    16 All Saints Avenue
    SL6 6EW Maidenhead
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director101528490001
    PILON, Marcel Jean-Paul
    36 Downleaze Sneyd Park
    Stoke Bishop
    BS9 1LY Bristol
    Avon
    Administrateur
    36 Downleaze Sneyd Park
    Stoke Bishop
    BS9 1LY Bristol
    Avon
    CanadianCoo Cartons,Trades49088390003
    PRIESTLEY, Mark Richard
    2 Old Farm Court
    HP18 0SU Grendon Underwood
    Buckinghamshire
    Administrateur
    2 Old Farm Court
    HP18 0SU Grendon Underwood
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishAccountant275589400001
    REGNIERS, Yves
    Woodhouse Gardens
    NG11 6BF Ruddington
    62
    United Kingdom
    Administrateur
    Woodhouse Gardens
    NG11 6BF Ruddington
    62
    United Kingdom
    United KingdomBelgianFinance Director159048480002
    RUSHTON, David Jeffrey
    Waverley Wolverton Fields
    Norton Lindsey
    CV35 8JN Warwick
    Administrateur
    Waverley Wolverton Fields
    Norton Lindsey
    CV35 8JN Warwick
    BritishCompany Director10542690001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur FIRST CARTON PAZO LTD ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Field First Limited
    Millennium Way West
    Phoenix Centre
    NG8 6AW Nottingham
    Mps
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Millennium Way West
    Phoenix Centre
    NG8 6AW Nottingham
    Mps
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Autorité légaleEngland And Wales
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) détiennent, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    FIRST CARTON PAZO LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of amendment,accession and supplemental charge
    Créé le 28 juin 1999
    Livré le 09 juil. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    That the company irrevocably and unconditionally guaranteed that it will on demand (made at any time that demand may be made under the second loan note instrument or the deed) (I) procure the due performance by the parent (as defined) under or oursuant to the second loan note instrument or the deed and (ii) pay all moneys and discharge,all liabilities due or to become due to the equity parties (as defined) or any of them under or pursuant to the second loan note instrument,the deed,or either of them
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ppm Ventures Limited as Security Trustee for the Equity Parties
    Transactions
    • 09 juil. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 févr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of amendment accession and supplemental charge
    Créé le 10 mai 1999
    Livré le 17 mai 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The due performance of the obligations of first carton group LTD under or pursuant to the loan note documents (as defined) and the payment of all moneys due or owing at the date of the original debenture (as defined) from first carton group LTD to the equity parties (as defined) or any of them under or pursuant to the loan note documents
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ppm Ventures Limited
    Transactions
    • 17 mai 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 févr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 02 mars 1998
    Livré le 23 mars 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations and liabilities due or to become due from the company (formerly known as lawson mardon pazo limited) to the chargee or to the finance parties (as defined) or any of them under or pursuant to the finance documents (as defined) and all obligations of each other obligor (as defined) under or pursuant to the finance documents and all monies and liabilities due or to become due from each other obligor and by any other present or future subsidiary of the parent or of any obligor to the finance parties under or pursuant to the finance documents
    Brèves mentions
    Land on the east side of bromford road,oldbury west midlands t/no: WM468333 and land fronting fountain lane and bromford road oldbury west midlands t/no: WM542. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Robert Fleming & Co. Limited as the Security Agent
    Transactions
    • 23 mars 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 févr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 02 mars 1998
    Livré le 17 mars 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    In favour of ppm ventures limited (as security trustee) (I) the due performance by the parent (being first cartons LTD) of all its obligations under or pursuant to the loan note documents to which it is a party; and (ii) the payment of all moneys and discharge of all liabilities now or hereafter due, owing or incurred to the equity parties (being the investors and security trustee) or any of them under or pursuant to the loan note documents by the parent (as defined)
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ppm Ventures Limited (As Security Trustee)
    Transactions
    • 17 mars 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 févr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite trust debenture
    Créé le 26 nov. 1985
    Livré le 04 déc. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of or pursuant to a secured credit facility agreement dated 29.8.85, an agreement dated 26.11.85 supplement chevets, the indemnities & security documents as diferent in the debenture and, all monies due or to become due from the company to the chargee or any of the banks or other companies named in the charge under the terms or pursuant to the documents referred to above
    Brèves mentions
    Stocks shares & all other securities. (See doc. M130 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Citibank, N.A.
    Transactions
    • 04 déc. 1985Enregistrement d'une charge
    Composite trust debenture
    Créé le 30 août 1985
    Livré le 10 sept. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee fursuant to the trust agreement dated 30TH august 1985 and the security documents as defined therein
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Citibank Na
    Transactions
    • 10 sept. 1985Enregistrement d'une charge

    FIRST CARTON PAZO LTD a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    08 mars 2021Commencement of winding up
    15 mars 2022Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Stephen Roland Browne
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    practitioner
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    Richard Michael Hawes
    5 Callaghan Square
    CF10 5BT Cardiff
    practitioner
    5 Callaghan Square
    CF10 5BT Cardiff

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0