2 CARE

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la société2 CARE
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social
    Numéro de société 00242188
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de 2 CARE ?

    • Activités de soins résidentiels pour troubles d'apprentissage, santé mentale et abus de substances (87200) / Activités de santé humaine et d'action sociale

    Où se situe 2 CARE ?

    Adresse du siège social
    80 Holloway Road
    N7 8JG London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de 2 CARE ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    S.O.S.SOCIETY(THE)06 sept. 192906 sept. 1929

    Quels sont les derniers comptes de 2 CARE ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour 2 CARE ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Déclaration de confirmation établie le 30 janv. 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    4 pagesDS01

    Retrait d'une société en tant que bailleur social

    2 pagesHC02

    Nomination de Mr Brian Leslie Glicksman en tant qu'administrateur le 17 mars 2016

    2 pagesAP01

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 janv. 2016 sans liste des membres

    4 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2015

    29 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Alan Powell le 25 juin 2015

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Diane French en tant que directeur le 10 juin 2015

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 12 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    1 pagesMR04

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge 3

    2 pagesMR05

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 11 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 10 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 15 en totalité

    1 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de 2 CARE ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BRINDLE, David John
    Holloway Road
    N7 8JG London
    80
    United Kingdom
    Administrateur
    Holloway Road
    N7 8JG London
    80
    United Kingdom
    EnglandBritishJournalist100058320001
    CAREN, Derek Patrick
    Holloway Road
    N7 8JG London
    80
    United Kingdom
    Administrateur
    Holloway Road
    N7 8JG London
    80
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director171432050001
    GLICKSMAN, Brian Leslie
    Holloway Road
    N7 8JG London
    80
    Administrateur
    Holloway Road
    N7 8JG London
    80
    EnglandBritishRetired101418510001
    HARRISON, Charlotte Anne, Doctor
    Holloway Road
    N7 8JG London
    80
    United Kingdom
    Administrateur
    Holloway Road
    N7 8JG London
    80
    United Kingdom
    Great BritainBritishPsychiatrist155675280001
    LAKHANI, Rajesh
    Holloway Road
    N7 8JG London
    80
    United Kingdom
    Administrateur
    Holloway Road
    N7 8JG London
    80
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant134288970001
    POWELL, Alan
    Holloway Road
    N7 8JG London
    80
    United Kingdom
    Administrateur
    Holloway Road
    N7 8JG London
    80
    United Kingdom
    EnglandBritishNone9996530003
    WATSON, Claire
    Holloway Road
    N7 8JG London
    80
    United Kingdom
    Administrateur
    Holloway Road
    N7 8JG London
    80
    United Kingdom
    United KingdomBritishConsultant55099600002
    O'SULLIVAN, Elizabeth Caroline Ruth
    7 Osterley Park View Road
    W7 2HG London
    Secrétaire
    7 Osterley Park View Road
    W7 2HG London
    British2380350001
    APETROAIE, Neculai
    23 Stanley Road
    TW3 1YA Hounslow
    Middlesex
    Administrateur
    23 Stanley Road
    TW3 1YA Hounslow
    Middlesex
    BritishSocial Services54255800001
    ARMSTRONG, June Patricia
    Arkle New Street
    HR8 2EL Ledbury
    Herefordshire
    Administrateur
    Arkle New Street
    HR8 2EL Ledbury
    Herefordshire
    BritishRetired4447700002
    ASHBY, Robert Leslie
    65 Corkscrew Hill
    BR4 9BA West Wickham
    Kent
    Administrateur
    65 Corkscrew Hill
    BR4 9BA West Wickham
    Kent
    BritishConsultant Surveyor24775530001
    BUXTON, William Arnold George, The Reverend
    The Old House
    45 The Mint
    TN31 7EN Rye
    East Sussex
    Administrateur
    The Old House
    45 The Mint
    TN31 7EN Rye
    East Sussex
    BritishRetired28420900002
    CHAMPERNOWNE, Wilhelmina Barbara Maria
    20 Manor Court
    CB3 9BE Cambridge
    Cambridgeshire
    Administrateur
    20 Manor Court
    CB3 9BE Cambridge
    Cambridgeshire
    BritishRetired Teacher24775540001
    CLARKE, Rosemary
    21 Deanhill Court
    SW14 7DJ London
    Administrateur
    21 Deanhill Court
    SW14 7DJ London
    BritishRetired Speech Therapist24775550001
    CONSTANTINIDI, Sheila Mary
    Marsh Mills House Wargrave Road
    RG9 3HY Henley On Thames
    Oxfordshire
    Administrateur
    Marsh Mills House Wargrave Road
    RG9 3HY Henley On Thames
    Oxfordshire
    BritishHousewife24775560001
    COOMBES, William
    Vardalu Pet Hotel
    Watford Road
    WD6 3BG Elstree
    Herts
    Administrateur
    Vardalu Pet Hotel
    Watford Road
    WD6 3BG Elstree
    Herts
    BritishKennels Manager/Owner24775630001
    CORLEY, Peter Francis
    Holloway Road
    N7 8JG London
    80
    United Kingdom
    Administrateur
    Holloway Road
    N7 8JG London
    80
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector158580290001
    CROSS, Derek William
    Brenchley Road
    Brenchley
    TN12 7PB Tonbridge
    11
    Kent
    England
    Administrateur
    Brenchley Road
    Brenchley
    TN12 7PB Tonbridge
    11
    Kent
    England
    United KingdomBritishRetired23580870001
    CROSS, Jennifer Ann
    Holloway Road
    N7 8JG London
    80
    United Kingdom
    Administrateur
    Holloway Road
    N7 8JG London
    80
    United Kingdom
    EnglandBritishSocial Worker23580860001
    DE ROEMER, Martin Charles
    Overwey
    Tilford
    GU10 2BS Farnham
    Surrey
    Administrateur
    Overwey
    Tilford
    GU10 2BS Farnham
    Surrey
    BritishRetired Stockbroker13557760001
    ENNIS, Charles Henry Burkinshaw
    39 Perrymead Street
    SW6 3SN London
    Administrateur
    39 Perrymead Street
    SW6 3SN London
    BritishRetired3669860001
    FINCH, Ernest John
    Vimeiro
    20 Sovereign Drive
    GU15 1PJ Camberley
    Surrey
    Administrateur
    Vimeiro
    20 Sovereign Drive
    GU15 1PJ Camberley
    Surrey
    BritishCommercial Executive65997730001
    FITZGERALD, Adrian James Andrew, Sir
    16 Clareville Street
    SW7 5AW London
    Administrateur
    16 Clareville Street
    SW7 5AW London
    United KingdomBritishBorough Councillor17707260001
    FRENCH, Diane
    Holloway Road
    N7 8JG London
    80
    United Kingdom
    Administrateur
    Holloway Road
    N7 8JG London
    80
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector Of Performance & Quality155617730001
    GILLIES, Crawford Scott
    19 Roedean Crescent
    Roehampton
    SW15 5JX London
    Administrateur
    19 Roedean Crescent
    Roehampton
    SW15 5JX London
    BritishManagement Consultant42352800001
    GLICKSMAN, Brian Leslie
    18 Worcester Road
    SM2 6PG Sutton
    Surrey
    Administrateur
    18 Worcester Road
    SM2 6PG Sutton
    Surrey
    EnglandBritishRetired Civil Servant101418510001
    GLICKSMAN, Jacqueline Patricia
    Worcester Road
    SM2 6PG Sutton
    11
    Surrey
    Great Britain
    Administrateur
    Worcester Road
    SM2 6PG Sutton
    11
    Surrey
    Great Britain
    United KingdomBritishRetired156518410001
    HARRIS, Susan
    Five Chimneys
    Mill Road
    TN36 4EJ Winchelsea
    East Sussex
    Administrateur
    Five Chimneys
    Mill Road
    TN36 4EJ Winchelsea
    East Sussex
    BritishRetired Lecturer88110850002
    HAWKEN, Gillian
    17 Foxgrove Road
    BR3 2AR Beckenham
    Kent
    Administrateur
    17 Foxgrove Road
    BR3 2AR Beckenham
    Kent
    BritishTeacher24775620001
    HOLDER, Edward John Ring
    Windy Ridge
    7 Shear Hill
    GU31 4BQ Petersfield
    Hants
    Administrateur
    Windy Ridge
    7 Shear Hill
    GU31 4BQ Petersfield
    Hants
    BritishRetired Chartered Accountant24775610001
    HOLDER, Richard John, Dr
    48 College Street
    GU31 4AF Petersfield
    Hampshire
    Administrateur
    48 College Street
    GU31 4AF Petersfield
    Hampshire
    EnglishArchitectural Historian59623710003
    HYSEL, Margaret
    Holloway Road
    N7 8JG London
    80
    United Kingdom
    Administrateur
    Holloway Road
    N7 8JG London
    80
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Executive158579790001
    JONES, David Llewelyn Edwards
    Houghton House
    Houghton
    BN18 9LW Arundel
    West Sussex
    Administrateur
    Houghton House
    Houghton
    BN18 9LW Arundel
    West Sussex
    EnglandBriitishRetired83141830002
    JONES, Jean
    Houghton House
    Houghton
    BN18 9LW Arundel
    11
    West Sussex
    England
    Administrateur
    Houghton House
    Houghton
    BN18 9LW Arundel
    11
    West Sussex
    England
    United KingdomBritishRetired156746880001
    JUDGE, Percy William
    Redroofs Lawn Road
    BR3 1RH Beckenham
    Kent
    Administrateur
    Redroofs Lawn Road
    BR3 1RH Beckenham
    Kent
    BritishBank Manager35927690001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur 2 CARE ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    The Richmond Fellowship
    Holloway Road
    N7 8JG London
    80
    England
    06 avr. 2016
    Holloway Road
    N7 8JG London
    80
    England
    Non
    Forme juridiqueCompany Limited By Guarantee
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Acts
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement00662712
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    2 CARE a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 24 juil. 2001
    Livré le 13 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    16 carlton drive putney l/b of wandsworth t/no.LN214041.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mai 2009Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 14 mai 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 23 mai 2001
    Livré le 06 juin 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Barclays bank PLC re 2 care business premium account (or treasurers deposit) account number 90758140. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 juin 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 avr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 nov. 1995
    Livré le 11 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Cotswold house, church road, cainscross, gloucestershire t/no: GR119311.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 déc. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mai 2009Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 14 mai 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed supplemental to a legal charge
    Créé le 30 nov. 1995
    Livré le 11 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the legal charge dated 30TH november 1995
    Brèves mentions
    All the goodwill of the business carried on from time to time at the mortgaged property k/a cotswold house, church road, cainscross gloucestershire t/no : GR119311. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 déc. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mars 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 13 mai 2009Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 18 mai 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed supplemental to the legal charge dated 31ST october 1995
    Créé le 31 oct. 1995
    Livré le 13 nov. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the legal charge dated 31ST october 1995
    Brèves mentions
    All the goodwill of the business carried on from time to time at the mortgaged property k/a 2 & 4 albert road cosham portsmouth t/n HP313922.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 nov. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mai 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 31 oct. 1995
    Livré le 13 nov. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    2 & 4 albert road cosham portsmouth hampshire t/n HP313922.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 nov. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mai 2009Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 13 mai 2009Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 14 mai 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed supplemental to a legal charge
    Créé le 14 août 1995
    Livré le 24 août 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the legal charge of even date
    Brèves mentions
    All the goodwill of the business carried on from time to time at the f/h property k/a longforth nursing home longforth road wellington somerset t/n st 39188.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 24 août 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mai 2009Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 14 mai 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 14 août 1995
    Livré le 24 août 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Longforth nursing home longforth road wellington somerset t/n st 39188.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 24 août 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mai 2009Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 14 mai 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 27 août 1992
    Livré le 29 août 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan agreement and the charge
    Brèves mentions
    F/H winston house brooklands avenue cambridge t/n P176301.
    Personnes ayant droit
    • The Housing Corporation
    Transactions
    • 29 août 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mai 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 25 mars 1991
    Livré le 26 mars 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that f/h land and property situate at and k/a 272 colney hatch lane friern barnet, l/borough of barnet t/no:- ngl 676091.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 26 mars 1991Enregistrement d'une charge
    • 13 mai 2009Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 14 mai 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 23 nov. 1987
    Livré le 27 nov. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    36/38 kensington park road l/b of kensington & chelsea T.n's 167346 310325.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 27 nov. 1987Enregistrement d'une charge
    • 13 mai 2009Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 14 mai 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Assignment & legal charge
    Créé le 21 sept. 1979
    Livré le 26 sept. 1979
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 263, camden road, islington, london title no. 257437.
    Personnes ayant droit
    • The Housing Corporation of Maple House
    Transactions
    • 26 sept. 1979Enregistrement d'une charge
    • 31 mars 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge
    Créé le 23 août 1978
    Livré le 29 août 1978
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Sterling pounds 55,000 and all other monies due or to become due from th e borrower to the chargee supplemental to a legal charge dated 10/8/76
    Brèves mentions
    Hill house high street, elstree in the london borough of barnett.
    Personnes ayant droit
    • The Mayor, Aldermen and Burgesses of the London Borough of Barnett
    Transactions
    • 29 août 1978Enregistrement d'une charge
    • 13 mai 2009Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 14 mai 2015L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    • 18 mai 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 10 août 1976
    Livré le 12 août 1976
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For securing sterling pounds 7,569 and further advances not exceeding sterling pounds 25,000 in the aggregate therewith.
    Brèves mentions
    Hill house high street, elstree, london borough of barnet.
    Personnes ayant droit
    • The Mayor Alderman and Burgesses of Barnet.
    Transactions
    • 12 août 1976Enregistrement d'une charge
    • 13 mai 2009Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 14 mai 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 15 nov. 1967
    Livré le 22 nov. 1967
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Sterling pounds 12,000.
    Brèves mentions
    1, southlands grove, bickley, bromley.
    Personnes ayant droit
    • Alliance Assurance Company LTD.
    Transactions
    • 22 nov. 1967Enregistrement d'une charge
    • 13 mai 2009Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 14 mai 2015Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0