JOHN H.HOLT,LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéJOHN H.HOLT,LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00252302
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de JOHN H.HOLT,LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe JOHN H.HOLT,LIMITED ?

    Adresse du siège social
    MAZARS LLP
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de JOHN H.HOLT,LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2016
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2017
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour JOHN H.HOLT,LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Modification des coordonnées de l'administrateur Miss Deborah Grimason le 13 oct. 2016

    2 pagesCH01

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pages4.71

    Période comptable actuelle prolongée du 30 juin 2016 au 31 déc. 2016

    1 pagesAA01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2015

    1 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de Lodge Way House, Lodge Way Harlestone Road Northampton NN5 7UG à 45 Church Street Birmingham B3 2RT le 06 janv. 2016

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 21 déc. 2015

    LRESSP

    Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2014 au 30 juin 2015

    1 pagesAA01

    Cessation de la nomination de John Peter Carter en tant que directeur le 10 sept. 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Anthony David Buffin en tant que directeur le 10 sept. 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Miss Deborah Grimason en tant qu'administrateur le 10 sept. 2015

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital18 mai 2015

    État du capital au 18 mai 2015

    • Capital: GBP 5,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    1 pagesAA

    Cessation de la nomination de Andrew Stephen Pike en tant que secrétaire le 23 sept. 2014

    1 pagesTM02

    Nomination de Tp Directors Ltd en tant qu'administrateur le 19 sept. 2014

    2 pagesAP02

    Résolutions

    Resolutions
    16 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 mai 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 juin 2014

    État du capital au 10 juin 2014

    • Capital: GBP 5,000
    SH01

    Nomination de Mr John Peter Carter en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Geoffrey Cooper en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Anthony David Buffin le 12 nov. 2013

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    1 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 mai 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Nomination de Anthony Buffin en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de JOHN H.HOLT,LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GRIMASON, Deborah
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    Administrateur
    Church Street
    B3 2RT Birmingham
    45
    EnglandBritishCompany Secretary185755960002
    TP DIRECTORS LTD
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Administrateur
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement03480295
    191205550001
    JONES, Edward Arthur
    Holly House
    Manchester Road
    WA16 0NT Knutsford
    Cheshire
    Secrétaire
    Holly House
    Manchester Road
    WA16 0NT Knutsford
    Cheshire
    British36961940004
    MARLAND, Jeffrey Norman
    105 Norris Road
    M33 3GS Sale
    Cheshire
    Secrétaire
    105 Norris Road
    M33 3GS Sale
    Cheshire
    British13224730001
    PIKE, Andrew Stephen
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Travis Perkins Plc
    Northamptonshire
    Secrétaire
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Travis Perkins Plc
    Northamptonshire
    British65678800002
    SPARK, Robert Norman
    7 Pennine Drive
    WA14 4NH Altrincham
    Cheshire
    Secrétaire
    7 Pennine Drive
    WA14 4NH Altrincham
    Cheshire
    BritishCompany Director141430670001
    BUFFIN, Anthony David
    Lodge Way House, Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Administrateur
    Lodge Way House, Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    EnglandBritishCompany Director178011680002
    CARTER, John Peter
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Administrateur
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector46226920007
    COOPER, Geoffrey Ian
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritishChief Executive104472550001
    GEARY, David
    2 Dyers Lane
    WA13 9QL Lymm
    Cheshire
    Administrateur
    2 Dyers Lane
    WA13 9QL Lymm
    Cheshire
    BritishBuilders Merchant64305720002
    HAMPDEN SMITH, Paul Nigel
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritishChartered Accountant72135950007
    MCKAY, Francis John
    Lodge Way House
    Lodge Way
    NN5 7UG Harlestone Road
    Northampton
    Administrateur
    Lodge Way House
    Lodge Way
    NN5 7UG Harlestone Road
    Northampton
    BritishCompany Director78787530001
    SMITH, Gerard Charles
    28 Glenside Drive
    SK9 1EH Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    28 Glenside Drive
    SK9 1EH Wilmslow
    Cheshire
    BritishManaging Director63738050002
    SMITH, Gerard Charles
    21 Stothard Road
    Stretford
    M32 9HA Manchester
    Administrateur
    21 Stothard Road
    Stretford
    M32 9HA Manchester
    BritishSales63738050001
    SPARK, Andrew Joseph
    Burnside
    Smith Lane, Mobberley
    WA16 7QF Knutsford
    Cheshire
    Administrateur
    Burnside
    Smith Lane, Mobberley
    WA16 7QF Knutsford
    Cheshire
    EnglandBritishCompany Director141430680001
    SPARK, Robert Norman
    7 Pennine Drive
    WA14 4NH Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    7 Pennine Drive
    WA14 4NH Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritishCompany Director141430670001
    TEASDALE, Keith
    55 Briarlands Avenue
    M33 4DD Sale
    Cheshire
    Administrateur
    55 Briarlands Avenue
    M33 4DD Sale
    Cheshire
    BritishSales Manager65331040002

    JOHN H.HOLT,LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal mortgage
    Créé le 01 mai 1998
    Livré le 08 mai 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Builders house and yard manor road altrincham cheshire.. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 08 mai 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 sept. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 27 mars 1998
    Livré le 31 mars 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 31 mars 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 sept. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 18 déc. 1997
    Livré le 23 déc. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge all book and other debts both present and future and the benefit of all contracts and policies of insurance in relation to such book and other debts.floating charge the undertaking and all property assets and rights of the company whatsoever and wheresoever both present and future including the assets comprised in the fixed charges.
    Personnes ayant droit
    • Euro Sales Finance PLC
    Transactions
    • 23 déc. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 févr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed equitable charge
    Créé le 19 mars 1997
    Livré le 04 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All debts the subject of an agreement for the factoring or discounting of debts between the company & the security holder which fail to vest. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Venture Factors PLC
    Transactions
    • 04 avr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 avr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed equitable charge
    Créé le 01 nov. 1994
    Livré le 03 nov. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed equitable charge all debts the subject of an agreement for the factoring or discounting of debts, all other debts, rights etc. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Venture Factors PLC
    Transactions
    • 03 nov. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 avr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 12 nov. 1993
    Livré le 17 nov. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H flat c charlotte court old hall lane fallowfield manchester and the proceeds of sale thereof and an assignment of goodwill and full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 nov. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 avr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 12 nov. 1993
    Livré le 17 nov. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H flat a charlotte court old hall lane fallowfield manchester and/or the proceeds of sale and assigns goodwill and benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 nov. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 avr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 28 sept. 1993
    Livré le 11 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 11 oct. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 sept. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 07 juin 1984
    Livré le 19 juin 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a: manor road builders yard & warehouse & aire dwellinghouses numbered 6, 8,14 borough rd, and 2 to 12 even numbers inclusive hamon rd, a ltrincham , trafford, greater manchester, and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 19 juin 1984Enregistrement d'une charge
    • 28 sept. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    JOHN H.HOLT,LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    21 déc. 2015Commencement of winding up
    09 mai 2017Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Scott Christian Bevan
    Mazars Llp 45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    practitioner
    Mazars Llp 45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Simon David Chandler
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    practitioner
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0