JOHN H.HOLT,LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | JOHN H.HOLT,LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00252302 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe JOHN H.HOLT,LIMITED ?
Adresse du siège social | MAZARS LLP 45 Church Street B3 2RT Birmingham |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de JOHN H.HOLT,LIMITED ?
En retard | Oui |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2016 |
Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2017 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2015 |
Quels sont les derniers dépôts pour JOHN H.HOLT,LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Miss Deborah Grimason le 13 oct. 2016 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 6 pages | 4.71 | ||||||||||
Période comptable actuelle prolongée du 30 juin 2016 au 31 déc. 2016 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2015 | 1 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Lodge Way House, Lodge Way Harlestone Road Northampton NN5 7UG à 45 Church Street Birmingham B3 2RT le 06 janv. 2016 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 3 pages | 4.70 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 1 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2014 au 30 juin 2015 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de John Peter Carter en tant que directeur le 10 sept. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Anthony David Buffin en tant que directeur le 10 sept. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Miss Deborah Grimason en tant qu'administrateur le 10 sept. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 11 mai 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013 | 1 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew Stephen Pike en tant que secrétaire le 23 sept. 2014 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Tp Directors Ltd en tant qu'administrateur le 19 sept. 2014 | 2 pages | AP02 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 16 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 11 mai 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Mr John Peter Carter en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Geoffrey Cooper en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Anthony David Buffin le 12 nov. 2013 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012 | 1 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 11 mai 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Nomination de Anthony Buffin en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de JOHN H.HOLT,LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIMASON, Deborah | Administrateur | Church Street B3 2RT Birmingham 45 | England | British | Company Secretary | 185755960002 | ||||||||
TP DIRECTORS LTD | Administrateur | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom |
| 191205550001 | ||||||||||
JONES, Edward Arthur | Secrétaire | Holly House Manchester Road WA16 0NT Knutsford Cheshire | British | 36961940004 | ||||||||||
MARLAND, Jeffrey Norman | Secrétaire | 105 Norris Road M33 3GS Sale Cheshire | British | 13224730001 | ||||||||||
PIKE, Andrew Stephen | Secrétaire | Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton Travis Perkins Plc Northamptonshire | British | 65678800002 | ||||||||||
SPARK, Robert Norman | Secrétaire | 7 Pennine Drive WA14 4NH Altrincham Cheshire | British | Company Director | 141430670001 | |||||||||
BUFFIN, Anthony David | Administrateur | Lodge Way House, Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton | England | British | Company Director | 178011680002 | ||||||||
CARTER, John Peter | Administrateur | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 46226920007 | ||||||||
COOPER, Geoffrey Ian | Administrateur | Travis Perkins Plc, Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton Northamptonshire | United Kingdom | British | Chief Executive | 104472550001 | ||||||||
GEARY, David | Administrateur | 2 Dyers Lane WA13 9QL Lymm Cheshire | British | Builders Merchant | 64305720002 | |||||||||
HAMPDEN SMITH, Paul Nigel | Administrateur | Travis Perkins Plc, Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton Northamptonshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 72135950007 | ||||||||
MCKAY, Francis John | Administrateur | Lodge Way House Lodge Way NN5 7UG Harlestone Road Northampton | British | Company Director | 78787530001 | |||||||||
SMITH, Gerard Charles | Administrateur | 28 Glenside Drive SK9 1EH Wilmslow Cheshire | British | Managing Director | 63738050002 | |||||||||
SMITH, Gerard Charles | Administrateur | 21 Stothard Road Stretford M32 9HA Manchester | British | Sales | 63738050001 | |||||||||
SPARK, Andrew Joseph | Administrateur | Burnside Smith Lane, Mobberley WA16 7QF Knutsford Cheshire | England | British | Company Director | 141430680001 | ||||||||
SPARK, Robert Norman | Administrateur | 7 Pennine Drive WA14 4NH Altrincham Cheshire | England | British | Company Director | 141430670001 | ||||||||
TEASDALE, Keith | Administrateur | 55 Briarlands Avenue M33 4DD Sale Cheshire | British | Sales Manager | 65331040002 |
JOHN H.HOLT,LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Legal mortgage | Créé le 01 mai 1998 Livré le 08 mai 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Builders house and yard manor road altrincham cheshire.. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 27 mars 1998 Livré le 31 mars 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 18 déc. 1997 Livré le 23 déc. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed charge all book and other debts both present and future and the benefit of all contracts and policies of insurance in relation to such book and other debts.floating charge the undertaking and all property assets and rights of the company whatsoever and wheresoever both present and future including the assets comprised in the fixed charges. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Fixed equitable charge | Créé le 19 mars 1997 Livré le 04 avr. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All debts the subject of an agreement for the factoring or discounting of debts between the company & the security holder which fail to vest. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Fixed equitable charge | Créé le 01 nov. 1994 Livré le 03 nov. 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed equitable charge all debts the subject of an agreement for the factoring or discounting of debts, all other debts, rights etc. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 12 nov. 1993 Livré le 17 nov. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions L/H flat c charlotte court old hall lane fallowfield manchester and the proceeds of sale thereof and an assignment of goodwill and full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 12 nov. 1993 Livré le 17 nov. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions L/H flat a charlotte court old hall lane fallowfield manchester and/or the proceeds of sale and assigns goodwill and benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture | Créé le 28 sept. 1993 Livré le 11 oct. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 07 juin 1984 Livré le 19 juin 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H property k/a: manor road builders yard & warehouse & aire dwellinghouses numbered 6, 8,14 borough rd, and 2 to 12 even numbers inclusive hamon rd, a ltrincham , trafford, greater manchester, and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
JOHN H.HOLT,LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0