ENSEMBLE CLOTHING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéENSEMBLE CLOTHING LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00261096
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ENSEMBLE CLOTHING LIMITED ?

    • fabrication d'autres vêtements pour femmes (14132) / Industries manufacturières

    Où se situe ENSEMBLE CLOTHING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o ZOLFO COOPER
    The Zenith Building
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ENSEMBLE CLOTHING LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CCL CORPORATE WORKWEAR LIMITED03 déc. 201203 déc. 2012
    THE CO-OPERATIVE CLOTHING LIMITED05 mars 200805 mars 2008
    ROBERT HOWARTH LIMITED23 mai 198823 mai 1988
    ROBERT HOWARTH (NEW HEY) LIMITED14 déc. 193114 déc. 1931

    Quels sont les derniers comptes de ENSEMBLE CLOTHING LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2013

    Quels sont les derniers dépôts pour ENSEMBLE CLOTHING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    18 pages4.72

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    9 pages600

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    3 pagesF10.2

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 03 juin 2015

    20 pages2.24B

    Cessation de la nomination de Terry George Stannard en tant que directeur le 30 sept. 2014

    2 pagesTM01

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    1 pages2.34B

    Avis d'approbation réputée des propositions

    1 pagesF2.18

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    30 pages2.17B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    8 pages2.16B

    Changement d'adresse du siège social de 10 Stephenson Road Stephenson Industrial Estate Washington Tyne and Wear NE37 3HR à C/O Zolfo Cooper the Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB le 28 janv. 2015

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    24 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 sept. 2014

    État du capital au 23 sept. 2014

    • Capital: GBP 10,000
    SH01

    Cessation de la nomination de Nicholas James O'donovan en tant que directeur le 30 juil. 2014

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Mark Wilkinson en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Changement de nom ou de désignation de la catégorie d'actions

    2 pagesSH08

    Changement de nom ou de désignation de la catégorie d'actions

    2 pagesSH08

    Nomination de Mr Nicholas James O'donovan en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mrs Zoe Willingham en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Shane William Bray en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Terry George Stannard en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    21 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * C/O Co-Operative House Unit 3 Rutherford Road Stephenson Industrial Estate Washington Tyne and Wear NE37 3HX United Kingdom* le 04 oct. 2013

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 oct. 2013

    État du capital au 03 oct. 2013

    • Capital: GBP 10,000
    SH01

    Qui sont les dirigeants de ENSEMBLE CLOTHING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ALLEN, John Carl
    c/o Zolfo Cooper
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    The Zenith Building
    Secrétaire
    c/o Zolfo Cooper
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    The Zenith Building
    179621220001
    ALLEN, John Carl
    c/o Zolfo Cooper
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    The Zenith Building
    Administrateur
    c/o Zolfo Cooper
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    The Zenith Building
    EnglandBritish132967150001
    BRAY, Shane William
    Granary Close
    Kibworth
    LE8 0HZ Leicester
    2
    England
    Administrateur
    Granary Close
    Kibworth
    LE8 0HZ Leicester
    2
    England
    EnglandBritish137331200001
    MARCHANT, Barry Guy
    c/o Zolfo Cooper
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    The Zenith Building
    Administrateur
    c/o Zolfo Cooper
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    The Zenith Building
    EnglandBritish129756410001
    PALMER, Simon Anthony
    c/o Zolfo Cooper
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    The Zenith Building
    Administrateur
    c/o Zolfo Cooper
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    The Zenith Building
    EnglandBritish166215030001
    WILLINGHAM, Zoe
    Poplar Hill
    IP14 2AX Stowmarket
    82
    Suffolk
    England
    Administrateur
    Poplar Hill
    IP14 2AX Stowmarket
    82
    Suffolk
    England
    EnglandBritish181958210001
    LEES, Moira Ann
    389 Bury Road
    Edgworth
    BL7 0BU Bolton
    Lancashire
    Secrétaire
    389 Bury Road
    Edgworth
    BL7 0BU Bolton
    Lancashire
    British34646780001
    SELLERS, Caroline Jane
    PO BOX 53
    New Century House
    M60 4ES Manchester
    Secrétaire
    PO BOX 53
    New Century House
    M60 4ES Manchester
    British45801060004
    WHITTAKER, Katherine Alison
    4 Elderfield Drive
    Bredbury
    SK6 2QA Stockport
    Cheshire
    Secrétaire
    4 Elderfield Drive
    Bredbury
    SK6 2QA Stockport
    Cheshire
    British29899300001
    ALLAN, Stephen Murray
    89 Whitburn Road
    Cleadon
    SR6 7QY Sunderland
    Tyne & Wear
    Administrateur
    89 Whitburn Road
    Cleadon
    SR6 7QY Sunderland
    Tyne & Wear
    British71153380001
    AUSTIN, Mike
    Heron Close
    Steeton
    BD20 6UN Keighley
    6
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Heron Close
    Steeton
    BD20 6UN Keighley
    6
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish128557010001
    CARROLL, James Mcardle
    2 Thropton Close
    Leam Lane
    NE10 8SP Gateshead
    Tyne & Wear
    Administrateur
    2 Thropton Close
    Leam Lane
    NE10 8SP Gateshead
    Tyne & Wear
    British58842910001
    HOWARTH, Thomas James
    112 Woodplumpton Road
    Woodplumpton
    PR4 0LJ Preston
    Lancashire
    Administrateur
    112 Woodplumpton Road
    Woodplumpton
    PR4 0LJ Preston
    Lancashire
    British27577930001
    HUGHES, Dennis Trevor
    7 Meadow Court
    Darrhhall Ponteland
    NE20 9RB Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Administrateur
    7 Meadow Court
    Darrhhall Ponteland
    NE20 9RB Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    EnglandBritish109764460001
    MORGAN, Zoe Jeanette
    Pumphouse Lane
    B97 5PH Upper Bentley
    Raglis Cottage
    Worcestershire
    Administrateur
    Pumphouse Lane
    B97 5PH Upper Bentley
    Raglis Cottage
    Worcestershire
    EnglandBritish139424250001
    O'DONOVAN, Nicholas James
    Epworth Court
    Quorn
    LE12 8FR Loughborough
    10
    Leicestershire
    England
    Administrateur
    Epworth Court
    Quorn
    LE12 8FR Loughborough
    10
    Leicestershire
    England
    United KingdomBritish148050490002
    PRESCOTT, William Alan
    Woodlea 11 Wellington Road
    Atherton
    M49 9HE Manchester
    Administrateur
    Woodlea 11 Wellington Road
    Atherton
    M49 9HE Manchester
    British8101580001
    SCOTT, Claire Samantha
    c/o Co-Operative House
    Rutherford Road
    Stephenson Industrial Estate
    NE37 3HX Washington
    Unit 3
    Tyne And Wear
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Co-Operative House
    Rutherford Road
    Stephenson Industrial Estate
    NE37 3HX Washington
    Unit 3
    Tyne And Wear
    United Kingdom
    United KingdomBritish146599070001
    SLOCOMBE, Paul Richard
    16 Doves Croft
    ME9 8LQ Tunstall
    Kent
    Administrateur
    16 Doves Croft
    ME9 8LQ Tunstall
    Kent
    British119988930001
    STANNARD, Terry George
    Manor Close
    Penn
    HP10 8HZ High Wycombe
    Larchwood
    Buckinghamshire
    England
    Administrateur
    Manor Close
    Penn
    HP10 8HZ High Wycombe
    Larchwood
    Buckinghamshire
    England
    United KingdomBritish140573740001
    TACON, Christine Mary
    Blakelow Farm
    Blakelow Road
    SK11 7ED Macclesfield
    Cheshire
    Administrateur
    Blakelow Farm
    Blakelow Road
    SK11 7ED Macclesfield
    Cheshire
    EnglandBritish76748660003
    WILKINSON, Mark
    The Limes 57 Sutton Road
    NG17 8GY Kirkby In Ashfield
    Nottinghamshire
    Administrateur
    The Limes 57 Sutton Road
    NG17 8GY Kirkby In Ashfield
    Nottinghamshire
    EnglandBritish58842860002
    WILSON, Brian Grant
    North View
    Slaley
    NE47 0AA Hexham
    Northumberland
    Administrateur
    North View
    Slaley
    NE47 0AA Hexham
    Northumberland
    EnglandBritish64217870001

    ENSEMBLE CLOTHING LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 30 avr. 2013
    Livré le 03 mai 2013
    En cours
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank Leumi (UK) PLC
    Transactions
    • 03 mai 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 30 avr. 2013
    Livré le 02 mai 2013
    En cours
    Brève description
    N/A. notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Leumi Abl Limited
    Transactions
    • 02 mai 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 23 nov. 2012
    Livré le 30 nov. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company formerly known as the co-operative clothing limited or any member of the group to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, receivables, uncalled capital see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Centric Spv 1 Limited
    Transactions
    • 30 nov. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 02 mai 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Guarantee and debenture
    Créé le 23 nov. 2012
    Livré le 28 nov. 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Co-Operative Specialist Businesses Holdings Limited (The "Security Trustee")
    Transactions
    • 28 nov. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)

    ENSEMBLE CLOTHING LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    15 janv. 2015Administration started
    03 juin 2015Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Sarah O'Toole
    The Zenith Buildings 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    practitioner
    The Zenith Buildings 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Anne Clare O'Keefe
    The Zenith Building 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    practitioner
    The Zenith Building 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Peter Mark Saville
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    practitioner
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    2
    DateType
    03 juin 2015Commencement of winding up
    02 nov. 2016Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Sarah O'Toole
    The Zenith Buildings 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    proposed liquidator
    The Zenith Buildings 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Anne Clare O'Keefe
    The Zenith Building, 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    proposed liquidator
    The Zenith Building, 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Sarah O'Toole
    The Zenith Buildings 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    practitioner
    The Zenith Buildings 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Anne Clare O'Keefe
    The Zenith Building, 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    practitioner
    The Zenith Building, 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Peter Mark Saville
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    practitioner
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Peter Mark Saville
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    proposed liquidator
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0