E.A.BARKER LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | E.A.BARKER LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00276180 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe E.A.BARKER LIMITED ?
| Adresse du siège social | 15th Floor 6 Bevis Marks EC3A 7BA London England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de E.A.BARKER LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2021 |
Quels sont les derniers dépôts pour E.A.BARKER LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Lisa Susanne Gray en tant que directeur le 15 juil. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 09 juil. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
État du capital au 08 avr. 2022
| 5 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Sheraz Afzal en tant que directeur le 06 avr. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Ms Marie-Anne Bousaba en tant qu'administrateur le 29 mars 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2021 | 6 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mrs Lisa Susanne Gray en tant qu'administrateur le 01 févr. 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 09 juil. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2020 | 6 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Unit 1 Castle Marina Road Nottingham NG7 1TN England à 15th Floor 6 Bevis Marks London EC3A 7BA le 12 nov. 2020 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 10 juil. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2019 | 6 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Alpesh Kumar Patel en tant que directeur le 07 oct. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Sheraz Afzal en tant qu'administrateur le 07 oct. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 10 juil. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew James Smith en tant que directeur le 08 mai 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Alpesh Kumar Patel en tant qu'administrateur le 22 mars 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Kevin Richard Kaye en tant que directeur le 22 mars 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2018 | 6 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de E.A.BARKER LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOUSABA, Marie-Anne | Administrateur | 6 Bevis Marks EC3A 7BA London 15th Floor England | United Kingdom | Australian | 293005440001 | |||||
| BIONDI, Lorna | Secrétaire | Abbeyfield Road NG7 2SZ Nottingham Cardinal House England | 196291410001 | |||||||
| FISHER, Mark | Secrétaire | The Cottage London Road SG8 9LT Royston Hertfordshire | British | 61931900002 | ||||||
| FISHER, Mark | Secrétaire | The Cottage London Road SG8 9LT Royston Hertfordshire | British | 61931900002 | ||||||
| GOLD, Nick | Secrétaire | 126 Hamilton Terrace St John's Wood NW8 9UT London | British | 111562560001 | ||||||
| GREGG, Terence Michael | Secrétaire | 6 Chilterns End Close RG9 1SQ Henley On Thames Oxfordshire | British | 64357220001 | ||||||
| HARRINGTON, Nicholas Joseph | Secrétaire | 9 Kingsmead Avenue KT4 8XB Worcester Park Surrey | British | 1273670001 | ||||||
| MCKENZIE, Robbie | Secrétaire | Bevis Marks EC3A 7BA London 6 United Kingdom | 195400190001 | |||||||
| PAGE, Elizabeth | Secrétaire | Flat 3 5 St Leonards Road, Ealing W13 8PN London | British | 34006010001 | ||||||
| PRIOR, Mark Lee | Secrétaire | Bevis Marks EC3A 7BA London 6 United Kingdom | 178629510001 | |||||||
| REID, Michael John | Secrétaire | 49 Waldemar Avenue W13 9PZ London | Irish | 950490001 | ||||||
| RIVERS, Paul Edward | Secrétaire | Fox Cottage 1a Abingdon Road Tubney OX13 5QL Abingdon Oxfordshire | British | 62321110002 | ||||||
| WALTON, Caroline Debra | Secrétaire | 77 Gracechurch Street EC3V 0AS London 6th Floor | British | 151302380001 | ||||||
| ADAMS, David Alexander Robertson | Administrateur | Applegarth Three Elm Lane Hadlow TN11 0AB Tonbridge Kent | England | British | 55757700003 | |||||
| AFZAL, Sheraz | Administrateur | 6 Bevis Marks EC3A 7BA London 15th Floor England | United Kingdom | British | 251073350001 | |||||
| ATTALLAH, Naim Ibrahim | Administrateur | Flat 15 51 South Street W1Y 5PA London | United Kingdom | British | 25646240001 | |||||
| BERKMEN, Gillian | Administrateur | Orchard View 27 Woodhill Avenue SL9 8DP Gerrards Cross South Buckinghamshire | Gb | British | 92154270001 | |||||
| BRAGG, Roy Alec | Administrateur | 80 West Hill KT19 8LF Epsom Surrey | British | 14124670001 | ||||||
| BROWN, Andrew Saville | Administrateur | 123 Edenfield Gardens KT4 7DX Worcester Park Surrey | United Kingdom | British | 69874610002 | |||||
| BRYAN, Robert Andrew | Administrateur | 77 Gracechurch Street EC3V 0AS London 6th Floor | England | British | 122733810001 | |||||
| CLARK, Keith Dudley | Administrateur | Brock House 30 The Hedgerow Grove Green ME14 5TG Maidstone Kent | British | 30702450003 | ||||||
| CLAYMAN, Paul Sidney | Administrateur | 18 Keepier Wharf 12 Narrow Street E14 8DH London | British | 14436120006 | ||||||
| COOPER, Caroline | Administrateur | 222 Caraway 2 Cayenne Court 32 Shad Thames SE1 2PP London | British | 92733900001 | ||||||
| COREPAL, Sanjiv Kumar | Administrateur | 77 Gracechurch Street EC3V 0AS London 6th Floor | United Kingdom | British | 205239750001 | |||||
| DAHL, Ian Xavier | Administrateur | 2 Heathfield Lodge Carron Lane GU29 9LD Midhurst West Sussex | British | 66486140001 | ||||||
| DEAKIN, Tony | Administrateur | Castle Marina Road NG7 1TN Nottingham Unit 1 England | United Kingdom | British | 210862440001 | |||||
| ERICKSON, Eric George | Administrateur | Bevis Marks EC3A 7BA London 6 United Kingdom | Usa | Usa | 224104020001 | |||||
| EVANS, Nicholas David | Administrateur | 6 Raddington Road W10 5TF London | United Kingdom | British | 57490310002 | |||||
| FILECCIA, Piero | Administrateur | 77 Gracechurch Street EC3V 0AS London 6th Floor | England | British | 116096800001 | |||||
| FISHER, Mark | Administrateur | The Cottage London Road SG8 9LT Royston Hertfordshire | British | 61931900002 | ||||||
| GOLD, Nicholas Paul | Administrateur | 126 Hamilton Terrace St Johns Wood NW8 9UT London | England | British | 53606570002 | |||||
| GRAY, Lisa Susanne | Administrateur | 6 Bevis Marks EC3A 7BA London 15th Floor England | England | British | 262153810001 | |||||
| GREGG, Terence Michael | Administrateur | 6 Chilterns End Close RG9 1SQ Henley On Thames Oxfordshire | British | 64357220001 | ||||||
| HIBBERD, Roy Wayne | Administrateur | 77 Gracechurch Street EC3V 0AS London 6th Floor | Usa | United States | 158609380001 | |||||
| HOWARD, Stuart John | Administrateur | Abbeyfield Road NG7 2SZ Nottingham Cardinal House England | England | British | 192909600002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur E.A.BARKER LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan & Co (Birmingham) Limited | 06 avr. 2016 | Bevis Marks EC3A 7BA London 6 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
E.A.BARKER LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 22 nov. 2005 Livré le 06 déc. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of debenture made between the company and others as chargors and burdale financial limited as agent and trustee for itself and each of the finance parties | Créé le 05 juin 2001 Livré le 13 juin 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All present and future obligations and liabilities of each obligor to the finance parties (or any of them) under the finance documents (all terms as defined) | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Guarantee & debenture | Créé le 24 déc. 1998 Livré le 02 janv. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the loan documents (as defined) | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Guarantee and debenture under the tranche b loan agreement dated 24TH december 1998 between the company and the agent | Créé le 24 déc. 1998 Livré le 02 janv. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0