E.A.BARKER LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéE.A.BARKER LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00276180
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de E.A.BARKER LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe E.A.BARKER LIMITED ?

    Adresse du siège social
    15th Floor 6 Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de E.A.BARKER LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour E.A.BARKER LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Lisa Susanne Gray en tant que directeur le 15 juil. 2022

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 09 juil. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    État du capital au 08 avr. 2022

    • Capital: GBP 0.60
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Cessation de la nomination de Sheraz Afzal en tant que directeur le 06 avr. 2022

    1 pagesTM01

    Nomination de Ms Marie-Anne Bousaba en tant qu'administrateur le 29 mars 2022

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2021

    6 pagesAA

    Nomination de Mrs Lisa Susanne Gray en tant qu'administrateur le 01 févr. 2022

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 09 juil. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2020

    6 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de Unit 1 Castle Marina Road Nottingham NG7 1TN England à 15th Floor 6 Bevis Marks London EC3A 7BA le 12 nov. 2020

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 10 juil. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2019

    6 pagesAA

    Cessation de la nomination de Alpesh Kumar Patel en tant que directeur le 07 oct. 2019

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Sheraz Afzal en tant qu'administrateur le 07 oct. 2019

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 10 juil. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Andrew James Smith en tant que directeur le 08 mai 2019

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Alpesh Kumar Patel en tant qu'administrateur le 22 mars 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Kevin Richard Kaye en tant que directeur le 22 mars 2019

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2018

    6 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de E.A.BARKER LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BOUSABA, Marie-Anne
    6 Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    15th Floor
    England
    Administrateur
    6 Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    15th Floor
    England
    United KingdomAustralian293005440001
    BIONDI, Lorna
    Abbeyfield Road
    NG7 2SZ Nottingham
    Cardinal House
    England
    Secrétaire
    Abbeyfield Road
    NG7 2SZ Nottingham
    Cardinal House
    England
    196291410001
    FISHER, Mark
    The Cottage
    London Road
    SG8 9LT Royston
    Hertfordshire
    Secrétaire
    The Cottage
    London Road
    SG8 9LT Royston
    Hertfordshire
    British61931900002
    FISHER, Mark
    The Cottage
    London Road
    SG8 9LT Royston
    Hertfordshire
    Secrétaire
    The Cottage
    London Road
    SG8 9LT Royston
    Hertfordshire
    British61931900002
    GOLD, Nick
    126 Hamilton Terrace
    St John's Wood
    NW8 9UT London
    Secrétaire
    126 Hamilton Terrace
    St John's Wood
    NW8 9UT London
    British111562560001
    GREGG, Terence Michael
    6 Chilterns End Close
    RG9 1SQ Henley On Thames
    Oxfordshire
    Secrétaire
    6 Chilterns End Close
    RG9 1SQ Henley On Thames
    Oxfordshire
    British64357220001
    HARRINGTON, Nicholas Joseph
    9 Kingsmead Avenue
    KT4 8XB Worcester Park
    Surrey
    Secrétaire
    9 Kingsmead Avenue
    KT4 8XB Worcester Park
    Surrey
    British1273670001
    MCKENZIE, Robbie
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    United Kingdom
    Secrétaire
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    United Kingdom
    195400190001
    PAGE, Elizabeth
    Flat 3
    5 St Leonards Road, Ealing
    W13 8PN London
    Secrétaire
    Flat 3
    5 St Leonards Road, Ealing
    W13 8PN London
    British34006010001
    PRIOR, Mark Lee
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    United Kingdom
    Secrétaire
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    United Kingdom
    178629510001
    REID, Michael John
    49 Waldemar Avenue
    W13 9PZ London
    Secrétaire
    49 Waldemar Avenue
    W13 9PZ London
    Irish950490001
    RIVERS, Paul Edward
    Fox Cottage 1a Abingdon Road
    Tubney
    OX13 5QL Abingdon
    Oxfordshire
    Secrétaire
    Fox Cottage 1a Abingdon Road
    Tubney
    OX13 5QL Abingdon
    Oxfordshire
    British62321110002
    WALTON, Caroline Debra
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    Secrétaire
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    British151302380001
    ADAMS, David Alexander Robertson
    Applegarth Three Elm Lane
    Hadlow
    TN11 0AB Tonbridge
    Kent
    Administrateur
    Applegarth Three Elm Lane
    Hadlow
    TN11 0AB Tonbridge
    Kent
    EnglandBritish55757700003
    AFZAL, Sheraz
    6 Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    15th Floor
    England
    Administrateur
    6 Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    15th Floor
    England
    United KingdomBritish251073350001
    ATTALLAH, Naim Ibrahim
    Flat 15
    51 South Street
    W1Y 5PA London
    Administrateur
    Flat 15
    51 South Street
    W1Y 5PA London
    United KingdomBritish25646240001
    BERKMEN, Gillian
    Orchard View 27 Woodhill Avenue
    SL9 8DP Gerrards Cross
    South Buckinghamshire
    Administrateur
    Orchard View 27 Woodhill Avenue
    SL9 8DP Gerrards Cross
    South Buckinghamshire
    GbBritish92154270001
    BRAGG, Roy Alec
    80 West Hill
    KT19 8LF Epsom
    Surrey
    Administrateur
    80 West Hill
    KT19 8LF Epsom
    Surrey
    British14124670001
    BROWN, Andrew Saville
    123 Edenfield Gardens
    KT4 7DX Worcester Park
    Surrey
    Administrateur
    123 Edenfield Gardens
    KT4 7DX Worcester Park
    Surrey
    United KingdomBritish69874610002
    BRYAN, Robert Andrew
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    Administrateur
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    EnglandBritish122733810001
    CLARK, Keith Dudley
    Brock House 30 The Hedgerow
    Grove Green
    ME14 5TG Maidstone
    Kent
    Administrateur
    Brock House 30 The Hedgerow
    Grove Green
    ME14 5TG Maidstone
    Kent
    British30702450003
    CLAYMAN, Paul Sidney
    18 Keepier Wharf
    12 Narrow Street
    E14 8DH London
    Administrateur
    18 Keepier Wharf
    12 Narrow Street
    E14 8DH London
    British14436120006
    COOPER, Caroline
    222 Caraway 2 Cayenne Court
    32 Shad Thames
    SE1 2PP London
    Administrateur
    222 Caraway 2 Cayenne Court
    32 Shad Thames
    SE1 2PP London
    British92733900001
    COREPAL, Sanjiv Kumar
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    Administrateur
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    United KingdomBritish205239750001
    DAHL, Ian Xavier
    2 Heathfield Lodge
    Carron Lane
    GU29 9LD Midhurst
    West Sussex
    Administrateur
    2 Heathfield Lodge
    Carron Lane
    GU29 9LD Midhurst
    West Sussex
    British66486140001
    DEAKIN, Tony
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Unit 1
    England
    Administrateur
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Unit 1
    England
    United KingdomBritish210862440001
    ERICKSON, Eric George
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    United Kingdom
    Administrateur
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    United Kingdom
    UsaUsa224104020001
    EVANS, Nicholas David
    6 Raddington Road
    W10 5TF London
    Administrateur
    6 Raddington Road
    W10 5TF London
    United KingdomBritish57490310002
    FILECCIA, Piero
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    Administrateur
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    EnglandBritish116096800001
    FISHER, Mark
    The Cottage
    London Road
    SG8 9LT Royston
    Hertfordshire
    Administrateur
    The Cottage
    London Road
    SG8 9LT Royston
    Hertfordshire
    British61931900002
    GOLD, Nicholas Paul
    126 Hamilton Terrace
    St Johns Wood
    NW8 9UT London
    Administrateur
    126 Hamilton Terrace
    St Johns Wood
    NW8 9UT London
    EnglandBritish53606570002
    GRAY, Lisa Susanne
    6 Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    15th Floor
    England
    Administrateur
    6 Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    15th Floor
    England
    EnglandBritish262153810001
    GREGG, Terence Michael
    6 Chilterns End Close
    RG9 1SQ Henley On Thames
    Oxfordshire
    Administrateur
    6 Chilterns End Close
    RG9 1SQ Henley On Thames
    Oxfordshire
    British64357220001
    HIBBERD, Roy Wayne
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    Administrateur
    77 Gracechurch Street
    EC3V 0AS London
    6th Floor
    UsaUnited States158609380001
    HOWARD, Stuart John
    Abbeyfield Road
    NG7 2SZ Nottingham
    Cardinal House
    England
    Administrateur
    Abbeyfield Road
    NG7 2SZ Nottingham
    Cardinal House
    England
    EnglandBritish192909600002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur E.A.BARKER LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Nathan & Co (Birmingham) Limited
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    England
    06 avr. 2016
    Bevis Marks
    EC3A 7BA London
    6
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleEnglish Law
    Lieu d'enregistrementRegister Of Uk Companies, Companies House
    Numéro d'enregistrement00533432
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    E.A.BARKER LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 22 nov. 2005
    Livré le 06 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Burdale Financial Limited as Trustee for the Finance Parties (The Agent)
    Transactions
    • 06 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of debenture made between the company and others as chargors and burdale financial limited as agent and trustee for itself and each of the finance parties
    Créé le 05 juin 2001
    Livré le 13 juin 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities of each obligor to the finance parties (or any of them) under the finance documents (all terms as defined)
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Burdale Financial Limited
    Transactions
    • 13 juin 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 24 déc. 1998
    Livré le 02 janv. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the loan documents (as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bankboston N.A.(As Agent and Trustee for the Lenders)
    Transactions
    • 02 janv. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juin 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture under the tranche b loan agreement dated 24TH december 1998 between the company and the agent
    Créé le 24 déc. 1998
    Livré le 02 janv. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bankboston N.A.(As Agent and Trustee for the Lenders)
    Transactions
    • 02 janv. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0