WEST LONDON LEASEHOLDS LIMITED

WEST LONDON LEASEHOLDS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWEST LONDON LEASEHOLDS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00279600
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WEST LONDON LEASEHOLDS LIMITED ?

    • (7011) /

    Où se situe WEST LONDON LEASEHOLDS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de WEST LONDON LEASEHOLDS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour WEST LONDON LEASEHOLDS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Lucinda Bell en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Timothy Roberts en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Anthony Braine en tant que directeur

    1 pagesTM01

    État du capital au 15 avr. 2010

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Cessation de la nomination de Anthony Braine en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Sarah Barzycki en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Peter Clarke en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination d'un directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination d'un directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Nigel Webb en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Graham Roberts en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées du secrétaire Ndiana Ekpo le 01 oct. 2009

    1 pagesCH03

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2009 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2009

    18 pagesAA

    Cessation de la nomination de Andrew Jones en tant que directeur

    1 pagesTM01

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    6 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 mars 2008

    18 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de WEST LONDON LEASEHOLDS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    EKPO, Ndiana
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Secrétaire
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Other138446320001
    FORSHAW, Christopher Michael John
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    Administrateur
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    EnglandBritish1898090001
    CLARKE, Peter Courtenay
    Langkawi
    2 Ashlea Road
    SL9 8NY Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Langkawi
    2 Ashlea Road
    SL9 8NY Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British78691990001
    SCUDAMORE, Rebecca Jane
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secrétaire
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Other72249480003
    BARZYCKI, Sarah Morrell
    Sandown Road
    KT10 9TT Esher
    27
    Surrey
    Administrateur
    Sandown Road
    KT10 9TT Esher
    27
    Surrey
    United KingdomBritish58016770004
    BELL, Lucinda Margaret
    6 Priory Gardens
    Chiswick
    W4 1TT London
    Administrateur
    6 Priory Gardens
    Chiswick
    W4 1TT London
    EnglandBritish32809050004
    BERRY, David Charles
    Portland Dene
    Valley Way
    SL9 7PN Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Portland Dene
    Valley Way
    SL9 7PN Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British166550001
    BOWDEN, Robert Edward
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    Administrateur
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    United KingdomBritish152497530001
    BRAINE, Anthony
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    Administrateur
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    United KingdomBritish32809000002
    CLARKE, Peter Courtenay
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    Administrateur
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    United KingdomBritish78691990003
    GUNSTON, Michael Ian
    Larchmont
    Hambledon Road, Denmead
    PO7 6HB Waterlooville
    Hampshire
    Administrateur
    Larchmont
    Hambledon Road, Denmead
    PO7 6HB Waterlooville
    Hampshire
    United KingdomBritish3079890002
    HESTER, Stephen Alan Michael
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    Administrateur
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    British51688320001
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    Administrateur
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritish82020730004
    KALMAN, Stephen Lionel
    81 Eastbury Road
    HA6 3AP Northwood
    Middlesex
    Administrateur
    81 Eastbury Road
    HA6 3AP Northwood
    Middlesex
    EnglandBritish1188110001
    METLISS, Cyril
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    Administrateur
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    British3079600001
    RITBLAT, Nicholas Simon Jonathan
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    Administrateur
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    United KingdomBritish35758050004
    ROBERTS, Graham Charles
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    Administrateur
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    EnglandBritish79807180002
    ROBERTS, Timothy Andrew
    Lorne House
    Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Lorne House
    Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish63986410003
    RUTHERFORD, John Beach
    19 The Ridings
    Blatchington Green
    BN25 3HW Seaford
    East Sussex
    Administrateur
    19 The Ridings
    Blatchington Green
    BN25 3HW Seaford
    East Sussex
    British32816480001
    WEBB, Nigel Mark
    Beech Lodge
    53 Crouch Hall Lane Redbourn
    AL3 7EU St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    Beech Lodge
    53 Crouch Hall Lane Redbourn
    AL3 7EU St Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritish58059360001
    WESTON SMITH, John Harry
    10 Eldon Grove
    Hampstead
    NW3 5PT London
    Administrateur
    10 Eldon Grove
    Hampstead
    NW3 5PT London
    EnglandBritish13547380001
    WILSON, Alan James
    30 Broxbourne Road
    BR6 0AY Orpington
    Kent
    Administrateur
    30 Broxbourne Road
    BR6 0AY Orpington
    Kent
    EnglandBritish3078220001

    WEST LONDON LEASEHOLDS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of substitution & charge
    Créé le 04 mars 1988
    Acquis le 05 mai 1988
    Livré le 24 mai 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £5,000,000
    Brèves mentions
    Vale lodge 1, vale avenue tunbridge wells, kent title no k 188903.
    Personnes ayant droit
    • Royal Liver Trustees Limited
    Transactions
    • 24 mai 1988Enregistrement d'une charge
    • 10 oct. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of subsitution & charge
    Créé le 16 nov. 1987
    Acquis le 27 janv. 1989
    Livré le 09 févr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £5,000,000
    Brèves mentions
    1) 14, 16, 20, 22 & 24 adelaide street & 74 bank hey street blackpool, lancashire titel no. La 513555 2) 26 & 28 adelaide street blackpool, lancashire title no la 513554.
    Personnes ayant droit
    • Royal Liver Trustees Limited
    Transactions
    • 09 févr. 1989Enregistrement d'une charge
    • 10 oct. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 oct. 1986
    Livré le 20 oct. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or the british land company PLC under the terms of the facility letter dated 27 may 1986 to the chargee
    Brèves mentions
    8, 9 and 10 cornwall terrace regents park, london NW1.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Canada
    Transactions
    • 20 oct. 1986Enregistrement d'une charge
    • 19 août 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 21 nov. 1977
    Livré le 24 nov. 1977
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property known as:- 7 faraday close, holywell industrial estate rickmansworth hertfordshire title no:- hd 60746. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland LTD
    Transactions
    • 24 nov. 1977Enregistrement d'une charge
    • 19 août 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of variation amending a legal mortgage
    Créé le 07 juil. 1977
    Livré le 19 juil. 1977
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Diletion of appendix to clause one of origenal charge dated 10 may 1976
    Brèves mentions
    F/H property at 26, cloyhead way handsworth birmingham title no wk 87895.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank International France LTD
    Transactions
    • 19 juil. 1977Enregistrement d'une charge
    • 19 août 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 10 mai 1976
    Livré le 11 mai 1976
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For further securing all moneys now due or to become due from the british land company LTD & the chargee on any account whatsoever nor exceeding £550,000 secured by five other charges each dated 8TH september 1975
    Brèves mentions
    Property known as 26 holyhed way, birmingham.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank International (France) LTD
    Transactions
    • 11 mai 1976Enregistrement d'une charge
    • 19 août 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 19 déc. 1975
    Livré le 19 déc. 1975
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For further securing all monies due or to become due under the terms of a charge dated 19TH jan, 1973 and a deed of variation dated 19TH december, 1975
    Brèves mentions
    Property situate at west coppice road, brownhills, staffordshire.
    Personnes ayant droit
    • Leopold Joseph & Sons LTD
    Transactions
    • 19 déc. 1975Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0