WEST LONDON LEASEHOLDS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | WEST LONDON LEASEHOLDS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00279600 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe WEST LONDON LEASEHOLDS LIMITED ?
| Adresse du siège social | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de WEST LONDON LEASEHOLDS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2009 |
Quels sont les derniers dépôts pour WEST LONDON LEASEHOLDS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Lucinda Bell en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Timothy Roberts en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Anthony Braine en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
État du capital au 15 avr. 2010
| 4 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Anthony Braine en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Sarah Barzycki en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Peter Clarke en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination d'un directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination d'un directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Nigel Webb en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Graham Roberts en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Ndiana Ekpo le 01 oct. 2009 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2009 avec liste complète des actionnaires | 8 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2009 | 18 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew Jones en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
legacy | 6 pages | 363a | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2008 | 18 pages | AA | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de WEST LONDON LEASEHOLDS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKPO, Ndiana | Secrétaire | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | Other | 138446320001 | ||||||
| FORSHAW, Christopher Michael John | Administrateur | 44 Kerris Way Lower Earley RG6 5UW Reading Berkshire | England | British | 1898090001 | |||||
| CLARKE, Peter Courtenay | Secrétaire | Langkawi 2 Ashlea Road SL9 8NY Chalfont St Peter Buckinghamshire | British | 78691990001 | ||||||
| SCUDAMORE, Rebecca Jane | Secrétaire | 40 Canbury Avenue KT2 6JP Kingston Upon Thames Surrey | Other | 72249480003 | ||||||
| BARZYCKI, Sarah Morrell | Administrateur | Sandown Road KT10 9TT Esher 27 Surrey | United Kingdom | British | 58016770004 | |||||
| BELL, Lucinda Margaret | Administrateur | 6 Priory Gardens Chiswick W4 1TT London | England | British | 32809050004 | |||||
| BERRY, David Charles | Administrateur | Portland Dene Valley Way SL9 7PN Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 166550001 | ||||||
| BOWDEN, Robert Edward | Administrateur | The Chase Ongar Road CM15 0DG Kelvedon Hatch Essex | United Kingdom | British | 152497530001 | |||||
| BRAINE, Anthony | Administrateur | 21 Woodville Road Ealing W5 2SE London | United Kingdom | British | 32809000002 | |||||
| CLARKE, Peter Courtenay | Administrateur | Oakmeade Park Road SL2 4PG Stoke Poges Berkshire | United Kingdom | British | 78691990003 | |||||
| GUNSTON, Michael Ian | Administrateur | Larchmont Hambledon Road, Denmead PO7 6HB Waterlooville Hampshire | United Kingdom | British | 3079890002 | |||||
| HESTER, Stephen Alan Michael | Administrateur | 3 Ilchester Place W14 8AA London | British | 51688320001 | ||||||
| JONES, Andrew Marc | Administrateur | Hazlewell Road Putney SW15 6LH London 2 | England | British | 82020730004 | |||||
| KALMAN, Stephen Lionel | Administrateur | 81 Eastbury Road HA6 3AP Northwood Middlesex | England | British | 1188110001 | |||||
| METLISS, Cyril | Administrateur | 25 Foscote Road Hendon NW4 3SE London | British | 3079600001 | ||||||
| RITBLAT, Nicholas Simon Jonathan | Administrateur | 37 Queens Grove NW8 6HN London | United Kingdom | British | 35758050004 | |||||
| ROBERTS, Graham Charles | Administrateur | 6a Lower Belgrave Street SW1W 0LJ London | England | British | 79807180002 | |||||
| ROBERTS, Timothy Andrew | Administrateur | Lorne House Oxshott Way KT11 2RU Cobham Surrey | United Kingdom | British | 63986410003 | |||||
| RUTHERFORD, John Beach | Administrateur | 19 The Ridings Blatchington Green BN25 3HW Seaford East Sussex | British | 32816480001 | ||||||
| WEBB, Nigel Mark | Administrateur | Beech Lodge 53 Crouch Hall Lane Redbourn AL3 7EU St Albans Hertfordshire | England | British | 58059360001 | |||||
| WESTON SMITH, John Harry | Administrateur | 10 Eldon Grove Hampstead NW3 5PT London | England | British | 13547380001 | |||||
| WILSON, Alan James | Administrateur | 30 Broxbourne Road BR6 0AY Orpington Kent | England | British | 3078220001 |
WEST LONDON LEASEHOLDS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of substitution & charge | Créé le 04 mars 1988 Acquis le 05 mai 1988 Livré le 24 mai 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti £5,000,000 | |
Brèves mentions Vale lodge 1, vale avenue tunbridge wells, kent title no k 188903. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of subsitution & charge | Créé le 16 nov. 1987 Acquis le 27 janv. 1989 Livré le 09 févr. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti £5,000,000 | |
Brèves mentions 1) 14, 16, 20, 22 & 24 adelaide street & 74 bank hey street blackpool, lancashire titel no. La 513555 2) 26 & 28 adelaide street blackpool, lancashire title no la 513554. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 01 oct. 1986 Livré le 20 oct. 1986 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or the british land company PLC under the terms of the facility letter dated 27 may 1986 to the chargee | |
Brèves mentions 8, 9 and 10 cornwall terrace regents park, london NW1. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal mortgage | Créé le 21 nov. 1977 Livré le 24 nov. 1977 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions L/H property known as:- 7 faraday close, holywell industrial estate rickmansworth hertfordshire title no:- hd 60746. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of variation amending a legal mortgage | Créé le 07 juil. 1977 Livré le 19 juil. 1977 | Totalement satisfaite | Montant garanti Diletion of appendix to clause one of origenal charge dated 10 may 1976 | |
Brèves mentions F/H property at 26, cloyhead way handsworth birmingham title no wk 87895. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal mortgage | Créé le 10 mai 1976 Livré le 11 mai 1976 | Totalement satisfaite | Montant garanti For further securing all moneys now due or to become due from the british land company LTD & the chargee on any account whatsoever nor exceeding £550,000 secured by five other charges each dated 8TH september 1975 | |
Brèves mentions Property known as 26 holyhed way, birmingham. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 19 déc. 1975 Livré le 19 déc. 1975 | Totalement satisfaite | Montant garanti For further securing all monies due or to become due under the terms of a charge dated 19TH jan, 1973 and a deed of variation dated 19TH december, 1975 | |
Brèves mentions Property situate at west coppice road, brownhills, staffordshire. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0