MORSE CONTROLS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMORSE CONTROLS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00282259
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MORSE CONTROLS LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe MORSE CONTROLS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Teleflex Medical Uk
    Stirling Road
    HP12 3ST Cressex Business Park
    High Wycombe
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MORSE CONTROLS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TELEFLEX MORSE LIMITED04 déc. 193304 déc. 1933

    Quels sont les derniers comptes de MORSE CONTROLS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour MORSE CONTROLS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 juil. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 sept. 2010

    État du capital au 28 sept. 2010

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    1 pagesAD02

    Retrait de la demande de radiation de la société

    2 pagesDS02

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    2 pagesSH20

    État du capital au 17 oct. 2009

    • Capital: GBP 1
    1 pagesSH19

    legacy

    2 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Share prem a/c cnacelled
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 juil. 2009 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes établis au 31 déc. 2008

    9 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    11 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages190

    legacy

    1 pages353

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de MORSE CONTROLS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MCCAFFREY, Gerard Daniel
    6 Earlsfort
    BT67 0LY Moira
    County Armagh
    Northern Ireland
    Secrétaire
    6 Earlsfort
    BT67 0LY Moira
    County Armagh
    Northern Ireland
    IrishCompany Director127397580001
    MCCAFFREY, Gerard Daniel
    6 Earlsfort
    BT67 0LY Moira
    County Armagh
    Northern Ireland
    Administrateur
    6 Earlsfort
    BT67 0LY Moira
    County Armagh
    Northern Ireland
    Northern IrelandIrishCompany Director127397580001
    WILLIAMS, Charles Edward
    1402 Arrowhead Drive
    Brentwood
    Tennessee 37027
    Usa
    Administrateur
    1402 Arrowhead Drive
    Brentwood
    Tennessee 37027
    Usa
    United StatesAmericanCorp Controller122869170001
    BARNETT, Raymond Steven
    7 Hayes Barton
    Thorpe Bay
    SS1 3TS Southend On Sea
    Essex
    Secrétaire
    7 Hayes Barton
    Thorpe Bay
    SS1 3TS Southend On Sea
    Essex
    BritishFin Controller116482760001
    BIRD, Thomas Joseph
    1211 Karen Lane
    19087 Radnor
    Pennsylvania
    Usa
    Secrétaire
    1211 Karen Lane
    19087 Radnor
    Pennsylvania
    Usa
    UsaBusinessman33616600001
    COOPER, James Sidney William
    11 The Croft
    Meriden
    CV7 7NQ Coventry
    Secrétaire
    11 The Croft
    Meriden
    CV7 7NQ Coventry
    BritishAccountant33253280001
    HEANUE, Nicholas James
    223 Shobnall Road
    DE14 2BE Burton On Trent
    Staffordshire
    Secrétaire
    223 Shobnall Road
    DE14 2BE Burton On Trent
    Staffordshire
    BritishAccountant62562220002
    LAWSON, Steven Kenneth
    49 Rue De Victoire
    Paris
    75009
    France
    Secrétaire
    49 Rue De Victoire
    Paris
    75009
    France
    FrenchDivisional Vp Finance122049100001
    MCCALLION, Jane
    46 Nevern Road
    SS6 7PE Rayleigh
    Essex
    Secrétaire
    46 Nevern Road
    SS6 7PE Rayleigh
    Essex
    BritishFinancial Controller71945940002
    NELSON-GRACIE, Roderick
    The Firs
    Maidstone Road Nettlestead Green
    ME18 5HG Maidstone
    Kent
    Secrétaire
    The Firs
    Maidstone Road Nettlestead Green
    ME18 5HG Maidstone
    Kent
    British40991790001
    SCHOFIELD, Martin Howard
    Norwood Farmhouse
    EX31 3JS Hiscott
    Devon
    Secrétaire
    Norwood Farmhouse
    EX31 3JS Hiscott
    Devon
    BritishEuropean Controller103274200001
    STREETER, Andrew Charles
    38 Albert Road
    SS4 3EZ Rochford
    Essex
    Secrétaire
    38 Albert Road
    SS4 3EZ Rochford
    Essex
    BritishAccountant69339090001
    AGOCS, Stephen Francis
    128 Upper Ferry Road
    Trenton New Jersey
    FOREIGN Usa
    Administrateur
    128 Upper Ferry Road
    Trenton New Jersey
    FOREIGN Usa
    AmericanBusinessman34721300001
    BARNETT, Raymond Steven
    7 Hayes Barton
    Thorpe Bay
    SS1 3TS Southend On Sea
    Essex
    Administrateur
    7 Hayes Barton
    Thorpe Bay
    SS1 3TS Southend On Sea
    Essex
    BritishFin Controller116482760001
    BIRD, Thomas Joseph
    1211 Karen Lane
    19087 Radnor
    Pennsylvania
    Usa
    Administrateur
    1211 Karen Lane
    19087 Radnor
    Pennsylvania
    Usa
    UsaBusinessman33616600001
    BOND, Harvey Paul
    No 1 The Dovecote Ladds Lane
    PE6 9HD Maxey
    Cambridgeshire
    Administrateur
    No 1 The Dovecote Ladds Lane
    PE6 9HD Maxey
    Cambridgeshire
    BritishPresident76507470001
    BOND, Harvey Paul
    No 1 The Dovecote Ladds Lane
    PE6 9HD Maxey
    Cambridgeshire
    Administrateur
    No 1 The Dovecote Ladds Lane
    PE6 9HD Maxey
    Cambridgeshire
    BritishGeneral Manager76507470001
    BRADLEY, George Edward William
    6639 Congressional Terrace
    Fayetteville
    P A 17222
    Usa
    Administrateur
    6639 Congressional Terrace
    Fayetteville
    P A 17222
    Usa
    AmericanPresident76157540001
    BUSHELL, Anthony Thomas
    Woodburcote
    Moat Lane, Prestwood
    HP16 9DF Great Missenden
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Woodburcote
    Moat Lane, Prestwood
    HP16 9DF Great Missenden
    Buckinghamshire
    BritishSales Director69190050001
    COOPER, James Sidney William
    11 The Croft
    Meriden
    CV7 7NQ Coventry
    Administrateur
    11 The Croft
    Meriden
    CV7 7NQ Coventry
    BritishAccountant33253280001
    DAWSON-GOODEY, Andrew John
    9 Wroxham Gardens
    EN6 3DH Potters Bar
    Hertfordshire
    Administrateur
    9 Wroxham Gardens
    EN6 3DH Potters Bar
    Hertfordshire
    BritishGeneral Manager56963660001
    GILL, John George
    Grovebury The Green
    Chignal St James
    CM1 4TY Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    Grovebury The Green
    Chignal St James
    CM1 4TY Chelmsford
    Essex
    BritishCompany Director58095740001
    HALL, Allan Robert Macalister
    26 Coltbridge Terrace
    EH12 6AE Edinburgh
    Scotland
    Administrateur
    26 Coltbridge Terrace
    EH12 6AE Edinburgh
    Scotland
    BritishAccountant68216820001
    HEANUE, Nicholas James
    223 Shobnall Road
    DE14 2BE Burton On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    223 Shobnall Road
    DE14 2BE Burton On Trent
    Staffordshire
    BritishAccountant62562220002
    KING, Ian Robert
    Pond Cottage
    Bentley
    GU10 5HU Farnham
    Surrey
    Administrateur
    Pond Cottage
    Bentley
    GU10 5HU Farnham
    Surrey
    EnglandBritishManaging Director103274150002
    LAW, Michael Barry
    Chapters
    50 Galton Road
    SS0 8LA Westcliff On Sea
    Essex
    Administrateur
    Chapters
    50 Galton Road
    SS0 8LA Westcliff On Sea
    Essex
    BritishManaging Director95044260001
    LAWSON, Steven Kenneth
    49 Rue De Victoire
    Paris
    75009
    France
    Administrateur
    49 Rue De Victoire
    Paris
    75009
    France
    FrenchDivisional Vp Finance122049100001
    MCCALLION, Jane
    46 Nevern Road
    SS6 7PE Rayleigh
    Essex
    Administrateur
    46 Nevern Road
    SS6 7PE Rayleigh
    Essex
    United KingdomBritishFinancial Controller71945940002
    MCCANN, Terence Michael Paul
    103 Cutenhoe Road
    LU1 3NG Luton
    Bedfordshire
    Administrateur
    103 Cutenhoe Road
    LU1 3NG Luton
    Bedfordshire
    BritishAccountant61786230001
    NELSON-GRACIE, Roderick
    The Firs
    Maidstone Road Nettlestead Green
    ME18 5HG Maidstone
    Kent
    Administrateur
    The Firs
    Maidstone Road Nettlestead Green
    ME18 5HG Maidstone
    Kent
    United KingdomBritishCompany Director40991790001
    OWEN, David
    Giffords Farm House
    Warrenden Road
    CM3 8DG Rettendon Common
    Chelmsford
    Administrateur
    Giffords Farm House
    Warrenden Road
    CM3 8DG Rettendon Common
    Chelmsford
    BritishBusinessman74909960002
    SCHOFIELD, Martin Howard
    Norwood Farmhouse
    EX31 3JS Hiscott
    Devon
    Administrateur
    Norwood Farmhouse
    EX31 3JS Hiscott
    Devon
    BritishEuropean Controller103274200001
    SHARP, Clayton Brant
    105 Marigold Court
    Chester Springs
    Pennsylvania Pa 19425
    Usa
    Administrateur
    105 Marigold Court
    Chester Springs
    Pennsylvania Pa 19425
    Usa
    AmericanVp Taxes116373390001

    MORSE CONTROLS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Suplemental charge.
    Créé le 26 nov. 1993
    Livré le 17 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Charge over all stocks shares and securities belonging to the company. Please see doc .
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC,
    Transactions
    • 17 déc. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juin 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 22 juil. 1993
    Livré le 05 août 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H all that piece or parcel of land in basildon essex having a frontage to the south side of christopher martin road the east side of honywood road and north side of paycocke road and the proceeds of sale thereof and an assignment of goodwill and connection of any business and full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 05 août 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 mai 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 28 mai 1993
    Livré le 08 juin 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 juin 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 mai 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0