VITAMOL LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | VITAMOL LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00285257 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe VITAMOL LIMITED ?
| Adresse du siège social | Oldham Road Middleton M24 2DB Manchester |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de VITAMOL LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2019 |
Quels sont les derniers dépôts pour VITAMOL LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||||||
Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2020 au 28 févr. 2021 | 1 pages | AA01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Ian William Robb le 16 juil. 2021 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 02 mai 2021 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||||||
État du capital au 06 nov. 2020
| 4 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 4 pages | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 4 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019 | 13 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 02 mai 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2018 | 17 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 02 mai 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr David John Kowal en tant qu'administrateur le 15 avr. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Mohammed Omar Shafi Khan en tant qu'administrateur le 12 avr. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Colin Michael Josephs en tant que directeur le 31 mars 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Ian William Robb en tant qu'administrateur le 07 janv. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Jonathan Mark Cheele en tant que directeur le 31 déc. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2017 | 17 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 02 mai 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2016 | 16 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 02 mai 2017 avec mises à jour | 6 pages | CS01 | ||||||||||||||
Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré Oldham Road Middleton Manchester M24 2DB | 1 pages | AD04 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2015 | 17 pages | AA | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de VITAMOL LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITA INDUSTRIAL (UK) LIMITED | Secrétaire | Middleton M24 2DB Manchester Oldham Road England |
| 110906090002 | ||||||||||
| KOWAL, David John | Administrateur | Middleton M24 2DB Manchester Oldham Road | England | British | 257559980001 | |||||||||
| O'RIORDAN, Daniel Joseph, Mr. | Administrateur | Middleton M24 2DB Manchester Oldham Road | England | British | 176979900001 | |||||||||
| ROBB, Ian William | Administrateur | Middleton M24 2DB Manchester Oldham Road | United Kingdom | British | 263073080001 | |||||||||
| SHAFI KHAN, Mohammed Omar | Administrateur | Middleton M24 2DB Manchester Oldham Road | United Kingdom | British | 239506860001 | |||||||||
| STIRZAKER, Mark Robert | Secrétaire | Lower Dunishbooth House Lane Head OL12 6BH Rochdale Lancashire | British | 78366970002 | ||||||||||
| TEAGUE, Alan Richard | Secrétaire | 26 Orchard Street Stockton Heath WA4 6LH Warrington | British | 290650004 | ||||||||||
| BURLEY, Nicholas James | Administrateur | 45 Pall Mall SW1Y 5JG London Times Place | United Kingdom | British | 122799590001 | |||||||||
| CHEELE, Jonathan Mark | Administrateur | Middleton M24 2DB Manchester Oldham Road | England | British | 127959950003 | |||||||||
| DOBSON, Roy | Administrateur | 248 Compstall Road Romiley SK6 4JG Stockport Cheshire | British | 6930380002 | ||||||||||
| EATON, Francis Joseph | Administrateur | Croichley Fold Hawkshaw BL8 4JE Bury Lancashire | British | 915070001 | ||||||||||
| FRANCIS, Stephen Ronald William | Administrateur | Belvedere Lodge 18 Highbury Road Wimbledon Village SW19 7PR London | England | British | 105961550001 | |||||||||
| HARRIS, Howard Elliott | Administrateur | 15 Queen's Gate Gardens SW7 5LY London | British | 93378750001 | ||||||||||
| HAY, Nigel Bruce | Administrateur | Middleton M24 2DB Manchester Oldham Road England | United Kingdom | British | 124316170001 | |||||||||
| HAY, Nigel Bruce | Administrateur | 6 Carr Holme Gardens Green Lane East Cabus PR6 7QH Garstang Lancashire | British | 79273660002 | ||||||||||
| JOSEPHS, Colin Michael | Administrateur | Middleton M24 2DB Manchester Oldham Road | England | British | 208845620001 | |||||||||
| MAUNDRELL, Graham Lloyd | Administrateur | Middleton M24 2DB Manchester Oldham Road England | United Kingdom | British | 56093930002 | |||||||||
| MELTHAM, John David | Administrateur | Middleton M24 2DB Manchester Oldham Road England | United Kingdom | British | 74570910001 | |||||||||
| MENENDEZ, Joseph Henry | Administrateur | c/o Vita Cellular Foams (Uk) Limited Oldham Road Middleton M24 2DB Manchester N/A England | Usa | American | 127225800003 | |||||||||
| MERCER, Jim | Administrateur | 21 Egerton Park M28 4TR Worsley Manchester | British | 6753530001 | ||||||||||
| O'CONNOR, Calvin James John | Administrateur | 10 Moss Lane Timperley WA15 6SZ Altrincham Cheshire | United Kingdom | British | 16253240001 | |||||||||
| OLIVER, John Lancaster | Administrateur | The Croft House 4 Hawkshill Close KT10 8JY Esher Surrey | United Kingdom | United Kingdom | 116941050001 | |||||||||
| TURNER, Christopher Peter | Administrateur | 38 Rectory Close Croston PR26 9SH Preston | British | 54817970001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur VITAMOL LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita (Group) Unlimited | 06 avr. 2016 | Oldham Road Middleton M24 2DB Manchester Oldham Road England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
VITAMOL LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 23 avr. 2009 Livré le 01 mai 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 07 déc. 2007 Livré le 21 déc. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from or by a principal to each of the secured parties, all monies due or to become due from the principals and/or british vita unlimited to the secured parties and all monies due or to become due to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 23 août 2005 Livré le 12 sept. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the chargor and each other company to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions By way of first fixed charge all right title and interest in the tangible moveable property any account that is a mandatory prepayment account the intellectual property any goodwill and rights in relation to the uncalled capital. Assigned the proceeds of any insurance policy and all related rights and the specific contracts. By way of floating charge all assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0