EXEL FINANCE LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | EXEL FINANCE LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00286932 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe EXEL FINANCE LIMITED ?
Adresse du siège social | 2 Mountview Court 310 Friern Barnet Lane Whetstone N20 0YZ London |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de EXEL FINANCE LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2013 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour EXEL FINANCE LIMITED ?
Bilan annuel |
|
---|
Quels sont les derniers dépôts pour EXEL FINANCE LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 14 pages | 4.71 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Ocean House the Ring Bracknell Berkshire RG12 1AN à 2 Mountview Court 310 Friern Barnet Lane Whetstone London N20 0YZ le 13 oct. 2014 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
Déclaration de solvabilité | 3 pages | 4.70 | ||||||||||||||
Résolution d'insolvabilité Resolution INSOLVENCY:Special Resolution ;- "In Specie" | 1 pages | LIQ MISC RES | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 1 pages | 600 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Keith Roy Smith en tant qu'administrateur le 15 août 2014 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Paul Taylor en tant que directeur le 15 août 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Jane Li le 25 juil. 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2013 | 15 pages | AA | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
État du capital au 17 févr. 2014
| 4 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Dermot Woolliscroft en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Exel Secretarial Services Limited en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Nomination de Mrs Jane Li en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 16 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2012 | 14 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 16 janv. 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * the Merton Centre 45 St Peters Street Bedford MK40 2UB* le 08 oct. 2012 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2011 | 14 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 16 janv. 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||||||
Nomination de Dermot Francis Woolliscroft en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de EXEL FINANCE LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire | The Ring RG12 1AN Bracknell Ocean House Berkshire United Kingdom |
| 32524900007 | ||||||||||
LI, Jane | Administrateur | 310 Friern Barnet Lane Whetstone N20 0YZ London 2 Mountview Court | United Kingdom | British | Company Secretary | 134292740003 | ||||||||
SMITH, Keith Roy | Administrateur | 310 Friern Barnet Lane Whetstone N20 0YZ London 2 Mountview Court | England | British | Finance Director | 140889200001 | ||||||||
N F C SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire | The Merton Centre 45 St Peters Street MK40 2UB Bedford Bedfordshire | 32524900003 | |||||||||||
BENNETT, Robert Allan | Administrateur | 48 Cleat Hill MK41 8AN Bedford Bedfordshire | United Kingdom | British | Treasurer | 152405020001 | ||||||||
BUMSTEAD, Jonathan Culver | Administrateur | Eastland Cottage Hall Place GU6 8LA Cranleigh Surrey | United Kingdom | British | Director | 72820970001 | ||||||||
DAY, Julian Michael | Administrateur | 51 Enmore Gardens SW14 8RF London | British | Deputy Treasurer | 70484050001 | |||||||||
DUNNE, Ronan James | Administrateur | The Firs Firfields KT13 0UD Weybridge Surrey | England | Irish | Treasurer | 187615620001 | ||||||||
GODBOLD, Philip Charles | Administrateur | 10 Oaklands Close KT9 1NT Chessington Surrey | British | Interim Group Treasurer | 99737040001 | |||||||||
KELLY, Martin | Administrateur | Cheyne House Sycamore Road HP6 6BB Amersham Buckinghamshire | Irish | Director | 56967550002 | |||||||||
LARMAN, Trevor George | Administrateur | Thurlwood House Loudwater Lane Croxley Green WD3 3JD Rickmansworth Hertfordshire | England/Hertfordshire | British | Finance Director | 10878930001 | ||||||||
LARMAN, Trevor George | Administrateur | Thurlwood House Loudwater Lane Croxley Green WD3 3JD Rickmansworth Hertfordshire | England/Hertfordshire | British | Finance Director | 10878930001 | ||||||||
LETCHFORD, Jeremy William Charles | Administrateur | 38 Chesterton Hall Crescent CB4 1AP Cambridge Cambridgeshire | British | Chartered Secretary | 1063820001 | |||||||||
MCMICHAEL, Andrew | Administrateur | 64 Marksbury Avenue Kew TW9 4JF Richmond Surrey | British | Group Treasurer | 77028300002 | |||||||||
TAYLOR, Nicholas Michael | Administrateur | 78 Burnt Hill Road Lower Bourne GU10 3LN Farnham Surrey | British | Treasurer | 120159810001 | |||||||||
TAYLOR, Paul | Administrateur | 2a High Street Ringstead NN14 4DA Kettering Northamptonshire | England | British | Cfo | 105652320001 | ||||||||
TURNER, Paul Gerard | Administrateur | 41 Fallowfield LU3 1UL Luton | British | Accountant | 62616810001 | |||||||||
VENABLES, Paul | Administrateur | 37 Ancastle Green RG9 1TS Henley On Thames Oxfordshire | British | Director | 103911420001 | |||||||||
WILLIAMS, Anthony Robert | Administrateur | 7 Glamis Gardens PE3 9PQ Peterborough Cambridgeshire | British | Chartered Accountant | 18727550001 | |||||||||
WOOLLISCROFT, Dermot Francis | Administrateur | The Ring RG12 1AN Bracknell Ocean House Berkshire United Kingdom | England | British | Head Of Uk Tax | 165808030001 | ||||||||
EXEL NOMINEE NO 2 LIMITED | Administrateur | The Ring RG12 1AN Bracknell Ocean House Berkshire United Kingdom |
| 73807850002 | ||||||||||
EXEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Administrateur | The Ring RG12 1AN Bracknell Ocean House Berkshire United Kingdom |
| 32524900007 |
EXEL FINANCE LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Mortgage | Créé le 19 févr. 1982 Livré le 25 févr. 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from national freight company limited under the terms of the loan agreement dated 15.1.82 and the guarantee dated 19.2.82 to the chargee on any account whatsoever. | |
Brèves mentions L/H land on the north side of rowley road bagington coventry west midlands title no wk 101752 f/h land on north side of moseley street & on the south side of cheapside birmingham title no wm 58889 andf/h land on south side of cheapside aston title no wk 299 f/h land containing 4.1 acresapprox forming part of fosse farm whitnash warwick please see doc M136 and order attached except see doc. M137. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage | Créé le 19 févr. 1982 Livré le 25 févr. 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from national freight consortium PLC under the terms of the loan agreement dated 15.1.82 and the guarantee dated 19.2.82 to the chargee on any account whatsoever. | |
Brèves mentions L/H land on the north side of rowley road bagington coventry west midlands title no wk 101752 f/h land on north side of moseley street on the south side of cheapside birmingham title no wm 58889 and f/h land on south side of cheapside aston title no wk 299 f/h land containing 4.1 acresapprox forming part of fosse farm whitnash warwick please see doc M136 and order attached. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Second debenture | Créé le 19 nov. 1962 Livré le 23 nov. 1962 | Totalement satisfaite | Montant garanti £12000 advanced or to be advanced under an agreement dated 19TH november 1962 and all other monies due or to become due or to becombe due from the company to machenzie industrial all monies secured by a debenture dated 27TH february 1961 | |
Brèves mentions Land & buildings at whitnash warwickshire with all fixtures in the nature of landlords fixtures therein, and also the property charged by the debenture dated 27TH february 1961. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
EXEL FINANCE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0