CLAREMONT GARMENTS (MIDLANDS) LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | CLAREMONT GARMENTS (MIDLANDS) LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Active |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00288471 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CLAREMONT GARMENTS (MIDLANDS) LIMITED ?
Adresse du siège social | The Courtaulds Building 292 Haydn Road NG5 1EB Nottingham England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CLAREMONT GARMENTS (MIDLANDS) LIMITED ?
En retard | Non |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 30 juin 2024 |
Date d'échéance des prochains comptes | 31 mars 2025 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2023 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour CLAREMONT GARMENTS (MIDLANDS) LIMITED ?
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 11 juin 2025 |
---|---|
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 25 juin 2025 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 11 juin 2024 |
En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour CLAREMONT GARMENTS (MIDLANDS) LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |
---|---|---|---|---|
Déclaration de confirmation établie le 11 juin 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Roger Ian Harry Broadberry en tant que secrétaire le 08 mai 2024 | 1 pages | TM02 | ||
Cessation de la nomination de Roger Ian Harry Broadberry en tant que directeur le 08 mai 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2023 | 7 pages | AA | ||
Nomination de Mr Roger Ian Harry Broadberry en tant qu'administrateur le 02 août 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Roger Ian Harry Broadberry en tant que secrétaire le 02 août 2023 | 2 pages | AP03 | ||
Cessation de la nomination de Roger Ian Harry Broadberry en tant que secrétaire le 12 juil. 2023 | 1 pages | TM02 | ||
Cessation de la nomination de Roger Ian Harry Broadberry en tant que directeur le 12 juil. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 11 juin 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2022 | 7 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 11 juin 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2021 | 7 pages | AA | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2020 | 7 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 11 juin 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 11 juin 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2019 | 7 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 11 juin 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2018 | 7 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 11 juin 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2017 | 7 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 11 juin 2017 avec mises à jour | 6 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2016 | 7 pages | AA | ||
Nomination de Mr Roger Ian Harry Broadberry en tant que secrétaire le 01 nov. 2016 | 2 pages | AP03 | ||
Cessation de la nomination de Huit Holdings (Uk) Limited en tant que secrétaire le 31 oct. 2016 | 1 pages | TM02 | ||
Nomination de Mr Roger Ian Harry Broadberry en tant qu'administrateur le 01 nov. 2016 | 2 pages | AP01 | ||
Qui sont les dirigeants de CLAREMONT GARMENTS (MIDLANDS) LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUIT HOLDINGS (UK) LIMITED | Administrateur | 292 Haydn Road NG5 1EB Nottingham The Courtaulds Building Nottinghamshire United Kingdom |
| 136235800001 | ||||||||||
BROADBERRY, Roger Ian Harry | Secrétaire | 292 Haydn Road NG5 1EB Nottingham The Courtaulds Building England | 312012410001 | |||||||||||
BROADBERRY, Roger Ian Harry | Secrétaire | 292 Haydn Road NG5 1EB Nottingham The Courtaulds Building England | 217562070001 | |||||||||||
CATTERMOLE, Carolyn Tracy | Secrétaire | 81 Cranbrook Road Chiswick W4 2LJ London | British | 53026290001 | ||||||||||
CHILD, Peter Francis | Secrétaire | 34 College Road SL6 6AT Maidenhead Berkshire | British | 10634940001 | ||||||||||
CLARKE, Melanie Anne | Secrétaire | 21 Bankside Close CV3 4GD Coventry West Midlands | British | Chartered Secretary | 68681710001 | |||||||||
DRING, Susan Mary | Secrétaire | 1 Ferens Close The Sands DH1 1JX Durham Co Durham | British | 27228120002 | ||||||||||
JAGUN, Ayotola | Secrétaire | 4e Bassett Road W10 6JJ London | British | Chartered Surveyor | 77729230001 | |||||||||
KELLY, Susan Kathleen | Secrétaire | 43 Southview Clifton Road SW19 4QU London | British | Chartered Secretary | 71087960003 | |||||||||
RUBENSTEIN, Howard Justin | Secrétaire | 10 Cyprus Avenue Finchley N3 1ST London | British | Company Secretary And Legal Co | 66642870003 | |||||||||
RUSS, Neil Andrew | Secrétaire | Archdale House 87 Wanlip Road LE7 1PB Syston Leicestershire | British | Financial Controller | 118426120001 | |||||||||
WILSON, Julia Ruth | Secrétaire | 5 Northwood Rise DE6 1BF Ashbourne Derbyshire | British | Financial Controller | 73543180001 | |||||||||
CLAREMONT GARMENTS (MIDLANDS) LIMITED | Secrétaire | Haydn Road NG5 1DH Nottingham P O Box 54 Nottinghamshire United Kingdom | 161205590001 | |||||||||||
HUIT HOLDINGS (UK) LIMITED | Secrétaire | 292 Haydn Road NG5 1EB Nottingham The Courtaulds Building Nottinghamshire United Kingdom | 136235800001 | |||||||||||
BROADBERRY, Roger Ian Harry | Administrateur | 292 Haydn Road NG5 1EB Nottingham The Courtaulds Building England | England | British | Group Financial Accountant | 126443750002 | ||||||||
BROADBERRY, Roger Ian Harry | Administrateur | 292 Haydn Road NG5 1EB Nottingham The Courtaulds Building England | England | British | Financial Accountant | 126443750002 | ||||||||
BUCKLEY, Christopher Paul | Administrateur | Fairways 103 Victoria Road Kirkby In Ashfield NG17 8AQ Nottingham | England | British | Director | 43190720001 | ||||||||
CATTERMOLE, Carolyn Tracy | Administrateur | 81 Cranbrook Road Chiswick W4 2LJ London | British | Solicitor | 53026290001 | |||||||||
CHESWORTH, Brian Wesley | Administrateur | 38 Ripley Road Heage DE56 2HU Belper Derbyshire | United Kingdom | British | Director | 27968910001 | ||||||||
CHILD, Peter Francis | Administrateur | 34 College Road SL6 6AT Maidenhead Berkshire | England | British | Director | 10634940001 | ||||||||
CLARKE, Melanie Anne | Administrateur | 21 Bankside Close CV3 4GD Coventry West Midlands | British | Chartered Secretary | 68681710001 | |||||||||
DONNELLY, David John, Mr. | Administrateur | 292 Haydn Road NG5 1EB Nottingham The Courtaulds Building England | Scotland | British | None | 110847310002 | ||||||||
DRING, Susan Mary | Administrateur | 1 Ferens Close The Sands DH1 1JX Durham Co Durham | British | Chartered Accountant | 27228120002 | |||||||||
DUFFY, Hugh Brian | Administrateur | Highwood Woodland Drive KT24 5AN East Horsley Surrey | British | Chief Executive | 91979290001 | |||||||||
ELLIS, Michael | Administrateur | 3 The Paddocks Peasehill DE5 3QR Ripley Derbyshire | United Kingdom | British | Finance Director | 82849150002 | ||||||||
EMMETT, Andrew James Skene | Administrateur | 10 Highfields KT22 9XA Fetcham Surrey | England | British | Director | 116750170001 | ||||||||
GARRAD, David Albert Moody | Administrateur | Birchwood 17 Clifton Road Matlock Bath DE4 3PW Matlock Derbyshire | British | Director | 11688570001 | |||||||||
GILLIATT, John Mowbray | Administrateur | 9 Banbury Road CV37 7HN Stratford Upon Avon Warwickshire | Scotland | British | Chief Executive | 169894800001 | ||||||||
HAMILTON, Nicholas Ian | Administrateur | South Hill House Smiths Lane, Ditcheat BA4 6PP Shepton Mallet Somerset | British | Company Director | 65558940001 | |||||||||
HANDLEY, Helen Kay | Administrateur | 6 Daniels Lane CR6 9ET Warlingham Surrey | British | Solicitor | 109816110001 | |||||||||
HOLLINGSWORTH, Rex Noel | Administrateur | 4 Hilary Close NG8 2SP Nottingham Nottinghamshire | British | Director | 11688580001 | |||||||||
JACKSON, Keith Antony | Administrateur | 163 Somersall Lane S40 3LZ Chesterfield Derbyshire | British | Director | 46202070001 | |||||||||
JAGUN, Ayotola | Administrateur | 4e Bassett Road W10 6JJ London | British | Chartered Secretary | 77729230001 | |||||||||
JENKINS, Stephen Adrian | Administrateur | Mill Farm House Barkston Road Marston NG32 2HN Grantham Lincolnshire | British | Chartered Accountant | 49738660002 | |||||||||
JENNINGS, Robert | Administrateur | 7 Glaven Close NG19 9RR Mansfield Woodhouse Nottinghamshire | England | British | Director | 99429090001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CLAREMONT GARMENTS (MIDLANDS) LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huit Holdings (Uk) Limited | 12 juin 2016 | 292 Haydn Road NG5 1EB Nottingham The Courtaulds Building Nottinghamshire United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
CLAREMONT GARMENTS (MIDLANDS) LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 13 juin 1997 Livré le 19 juin 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 28 déc. 1989 Livré le 08 janv. 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H property portland st., Kirkby-in-ashfield, notts. Site area over 1 acre. Factory area over 8,000 sq ft. F/h 27, victoria road, pinxton, derbyshire. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 27 juin 1988 Livré le 11 juil. 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge fixed and floating | Créé le 02 juin 1982 Livré le 21 juin 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed charge over all book debts & other debts floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts (excluding those mentioned above) uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0