CLAREMONT GARMENTS (MIDLANDS) LIMITED

CLAREMONT GARMENTS (MIDLANDS) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCLAREMONT GARMENTS (MIDLANDS) LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00288471
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CLAREMONT GARMENTS (MIDLANDS) LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe CLAREMONT GARMENTS (MIDLANDS) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Courtaulds Building
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CLAREMONT GARMENTS (MIDLANDS) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    COLUMBUS TEXTILES LIMITED24 déc. 199324 déc. 1993
    CELESTION TEXTILES LIMITED12 janv. 198712 janv. 1987
    CELESTION WOOD LIMITED31 déc. 198031 déc. 1980
    WOOD BASTOW & COMPANY LIMITED25 mai 193425 mai 1934

    Quels sont les derniers comptes de CLAREMONT GARMENTS (MIDLANDS) LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le30 juin 2024
    Date d'échéance des prochains comptes31 mars 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour CLAREMONT GARMENTS (MIDLANDS) LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au11 juin 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation25 juin 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au11 juin 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour CLAREMONT GARMENTS (MIDLANDS) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de confirmation établie le 11 juin 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Roger Ian Harry Broadberry en tant que secrétaire le 08 mai 2024

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Roger Ian Harry Broadberry en tant que directeur le 08 mai 2024

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2023

    7 pagesAA

    Nomination de Mr Roger Ian Harry Broadberry en tant qu'administrateur le 02 août 2023

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Roger Ian Harry Broadberry en tant que secrétaire le 02 août 2023

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Roger Ian Harry Broadberry en tant que secrétaire le 12 juil. 2023

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Roger Ian Harry Broadberry en tant que directeur le 12 juil. 2023

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 11 juin 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2022

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 11 juin 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2021

    7 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2020

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 11 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 11 juin 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2019

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 11 juin 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2018

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 11 juin 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2017

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 11 juin 2017 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2016

    7 pagesAA

    Nomination de Mr Roger Ian Harry Broadberry en tant que secrétaire le 01 nov. 2016

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Huit Holdings (Uk) Limited en tant que secrétaire le 31 oct. 2016

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Roger Ian Harry Broadberry en tant qu'administrateur le 01 nov. 2016

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de CLAREMONT GARMENTS (MIDLANDS) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HUIT HOLDINGS (UK) LIMITED
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    The Courtaulds Building
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    The Courtaulds Building
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement5785822
    136235800001
    BROADBERRY, Roger Ian Harry
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    The Courtaulds Building
    England
    Secrétaire
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    The Courtaulds Building
    England
    312012410001
    BROADBERRY, Roger Ian Harry
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    The Courtaulds Building
    England
    Secrétaire
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    The Courtaulds Building
    England
    217562070001
    CATTERMOLE, Carolyn Tracy
    81 Cranbrook Road
    Chiswick
    W4 2LJ London
    Secrétaire
    81 Cranbrook Road
    Chiswick
    W4 2LJ London
    British53026290001
    CHILD, Peter Francis
    34 College Road
    SL6 6AT Maidenhead
    Berkshire
    Secrétaire
    34 College Road
    SL6 6AT Maidenhead
    Berkshire
    British10634940001
    CLARKE, Melanie Anne
    21 Bankside Close
    CV3 4GD Coventry
    West Midlands
    Secrétaire
    21 Bankside Close
    CV3 4GD Coventry
    West Midlands
    BritishChartered Secretary68681710001
    DRING, Susan Mary
    1 Ferens Close
    The Sands
    DH1 1JX Durham
    Co Durham
    Secrétaire
    1 Ferens Close
    The Sands
    DH1 1JX Durham
    Co Durham
    British27228120002
    JAGUN, Ayotola
    4e Bassett Road
    W10 6JJ London
    Secrétaire
    4e Bassett Road
    W10 6JJ London
    BritishChartered Surveyor77729230001
    KELLY, Susan Kathleen
    43 Southview
    Clifton Road
    SW19 4QU London
    Secrétaire
    43 Southview
    Clifton Road
    SW19 4QU London
    BritishChartered Secretary71087960003
    RUBENSTEIN, Howard Justin
    10 Cyprus Avenue
    Finchley
    N3 1ST London
    Secrétaire
    10 Cyprus Avenue
    Finchley
    N3 1ST London
    BritishCompany Secretary And Legal Co66642870003
    RUSS, Neil Andrew
    Archdale House
    87 Wanlip Road
    LE7 1PB Syston
    Leicestershire
    Secrétaire
    Archdale House
    87 Wanlip Road
    LE7 1PB Syston
    Leicestershire
    BritishFinancial Controller118426120001
    WILSON, Julia Ruth
    5 Northwood Rise
    DE6 1BF Ashbourne
    Derbyshire
    Secrétaire
    5 Northwood Rise
    DE6 1BF Ashbourne
    Derbyshire
    BritishFinancial Controller73543180001
    CLAREMONT GARMENTS (MIDLANDS) LIMITED
    Haydn Road
    NG5 1DH Nottingham
    P O Box 54
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Haydn Road
    NG5 1DH Nottingham
    P O Box 54
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    161205590001
    HUIT HOLDINGS (UK) LIMITED
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    The Courtaulds Building
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    The Courtaulds Building
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    136235800001
    BROADBERRY, Roger Ian Harry
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    The Courtaulds Building
    England
    Administrateur
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    The Courtaulds Building
    England
    EnglandBritishGroup Financial Accountant126443750002
    BROADBERRY, Roger Ian Harry
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    The Courtaulds Building
    England
    Administrateur
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    The Courtaulds Building
    England
    EnglandBritishFinancial Accountant126443750002
    BUCKLEY, Christopher Paul
    Fairways 103 Victoria Road
    Kirkby In Ashfield
    NG17 8AQ Nottingham
    Administrateur
    Fairways 103 Victoria Road
    Kirkby In Ashfield
    NG17 8AQ Nottingham
    EnglandBritishDirector43190720001
    CATTERMOLE, Carolyn Tracy
    81 Cranbrook Road
    Chiswick
    W4 2LJ London
    Administrateur
    81 Cranbrook Road
    Chiswick
    W4 2LJ London
    BritishSolicitor53026290001
    CHESWORTH, Brian Wesley
    38 Ripley Road
    Heage
    DE56 2HU Belper
    Derbyshire
    Administrateur
    38 Ripley Road
    Heage
    DE56 2HU Belper
    Derbyshire
    United KingdomBritishDirector27968910001
    CHILD, Peter Francis
    34 College Road
    SL6 6AT Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    34 College Road
    SL6 6AT Maidenhead
    Berkshire
    EnglandBritishDirector10634940001
    CLARKE, Melanie Anne
    21 Bankside Close
    CV3 4GD Coventry
    West Midlands
    Administrateur
    21 Bankside Close
    CV3 4GD Coventry
    West Midlands
    BritishChartered Secretary68681710001
    DONNELLY, David John, Mr.
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    The Courtaulds Building
    England
    Administrateur
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    The Courtaulds Building
    England
    ScotlandBritishNone110847310002
    DRING, Susan Mary
    1 Ferens Close
    The Sands
    DH1 1JX Durham
    Co Durham
    Administrateur
    1 Ferens Close
    The Sands
    DH1 1JX Durham
    Co Durham
    BritishChartered Accountant27228120002
    DUFFY, Hugh Brian
    Highwood
    Woodland Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    Administrateur
    Highwood
    Woodland Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    BritishChief Executive91979290001
    ELLIS, Michael
    3 The Paddocks
    Peasehill
    DE5 3QR Ripley
    Derbyshire
    Administrateur
    3 The Paddocks
    Peasehill
    DE5 3QR Ripley
    Derbyshire
    United KingdomBritishFinance Director82849150002
    EMMETT, Andrew James Skene
    10 Highfields
    KT22 9XA Fetcham
    Surrey
    Administrateur
    10 Highfields
    KT22 9XA Fetcham
    Surrey
    EnglandBritishDirector116750170001
    GARRAD, David Albert Moody
    Birchwood 17 Clifton Road
    Matlock Bath
    DE4 3PW Matlock
    Derbyshire
    Administrateur
    Birchwood 17 Clifton Road
    Matlock Bath
    DE4 3PW Matlock
    Derbyshire
    BritishDirector11688570001
    GILLIATT, John Mowbray
    9 Banbury Road
    CV37 7HN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Administrateur
    9 Banbury Road
    CV37 7HN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    ScotlandBritishChief Executive169894800001
    HAMILTON, Nicholas Ian
    South Hill House
    Smiths Lane, Ditcheat
    BA4 6PP Shepton Mallet
    Somerset
    Administrateur
    South Hill House
    Smiths Lane, Ditcheat
    BA4 6PP Shepton Mallet
    Somerset
    BritishCompany Director65558940001
    HANDLEY, Helen Kay
    6 Daniels Lane
    CR6 9ET Warlingham
    Surrey
    Administrateur
    6 Daniels Lane
    CR6 9ET Warlingham
    Surrey
    BritishSolicitor109816110001
    HOLLINGSWORTH, Rex Noel
    4 Hilary Close
    NG8 2SP Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    4 Hilary Close
    NG8 2SP Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishDirector11688580001
    JACKSON, Keith Antony
    163 Somersall Lane
    S40 3LZ Chesterfield
    Derbyshire
    Administrateur
    163 Somersall Lane
    S40 3LZ Chesterfield
    Derbyshire
    BritishDirector46202070001
    JAGUN, Ayotola
    4e Bassett Road
    W10 6JJ London
    Administrateur
    4e Bassett Road
    W10 6JJ London
    BritishChartered Secretary77729230001
    JENKINS, Stephen Adrian
    Mill Farm House Barkston Road
    Marston
    NG32 2HN Grantham
    Lincolnshire
    Administrateur
    Mill Farm House Barkston Road
    Marston
    NG32 2HN Grantham
    Lincolnshire
    BritishChartered Accountant49738660002
    JENNINGS, Robert
    7 Glaven Close
    NG19 9RR Mansfield Woodhouse
    Nottinghamshire
    Administrateur
    7 Glaven Close
    NG19 9RR Mansfield Woodhouse
    Nottinghamshire
    EnglandBritishDirector99429090001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CLAREMONT GARMENTS (MIDLANDS) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    The Courtaulds Building
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    12 juin 2016
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    The Courtaulds Building
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleEngland
    Lieu d'enregistrementUnited Kingdom
    Numéro d'enregistrement05785822
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    CLAREMONT GARMENTS (MIDLANDS) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 13 juin 1997
    Livré le 19 juin 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 juin 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 28 déc. 1989
    Livré le 08 janv. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property portland st., Kirkby-in-ashfield, notts. Site area over 1 acre. Factory area over 8,000 sq ft. F/h 27, victoria road, pinxton, derbyshire.
    Personnes ayant droit
    • Baltic Asset Finance Limited.
    Transactions
    • 08 janv. 1990Enregistrement d'une charge
    • 11 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 27 juin 1988
    Livré le 11 juil. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 juil. 1988Enregistrement d'une charge
    • 01 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge fixed and floating
    Créé le 02 juin 1982
    Livré le 21 juin 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge over all book debts & other debts floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts (excluding those mentioned above) uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 21 juin 1982Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0