JTB REALISATIONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéJTB REALISATIONS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00288766
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de JTB REALISATIONS LIMITED ?

    • Vente au détail de chaussures en magasin spécialisé (47721) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe JTB REALISATIONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de JTB REALISATIONS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    A. JONES & SONS LIMITED04 juin 193404 juin 1934

    Quels sont les derniers comptes de JTB REALISATIONS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour JTB REALISATIONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de biens vacants

    1 pagesBONA

    Déclaration de biens vacants

    1 pagesBONA

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    32 pagesAM10

    Avis de transition de l'administration à la dissolution

    32 pagesAM23

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    28 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    31 pagesAM10

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    3 pagesAM19

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    36 pagesAM10

    Déclaration des affaires avec le formulaire AM02SOA

    12 pagesAM02

    Avis d'approbation réputée des propositions

    3 pagesAM06

    Certificat de changement de nom

    Company name changed A. jones & sons LIMITED\certificate issued on 03/05/17
    2 pagesCERTNM
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    44 pages2.17B

    Changement d'adresse du siège social de Outersole House 1 Wheatfield Way Hinckley Leicestershire LE10 1YG England à 15 Canada Square London E14 5GL le 09 avr. 2017

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2016 au 28 févr. 2017

    1 pagesAA01

    Cessation de la nomination de Simon Edward Cook en tant que directeur le 27 janv. 2017

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr David John Riddiford en tant qu'administrateur le 19 déc. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David Robert Short en tant que directeur le 06 oct. 2016

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 002887660014 en totalité

    1 pagesMR04

    Inscription de la charge 002887660018, créée le 22 sept. 2016

    70 pagesMR01

    Changement d'adresse du siège social de A Jones & Sons Limited Interlink Way West, Interlink Business Park Bardon Coalville Leicestershire LE67 1LD England à Outersole House 1 Wheatfield Way Hinckley Leicestershire LE10 1YG le 08 août 2016

    1 pagesAD01

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Qui sont les dirigeants de JTB REALISATIONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KILLICK, Michael David
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Administrateur
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    WalesBritishCfo75927820002
    RIDDIFORD, David John
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Administrateur
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    EnglandBritishExecutive Chairman220918310001
    JOHNSON, David Edward
    20 Great Footway
    Langton Green
    TN3 0DT Tunbridge Wells
    Kent
    Secrétaire
    20 Great Footway
    Langton Green
    TN3 0DT Tunbridge Wells
    Kent
    British10571470001
    TODD, Jeremy
    West Street
    TN20 6DS Mayfield
    Knowle Way
    East Sussex
    United Kingdom
    Secrétaire
    West Street
    TN20 6DS Mayfield
    Knowle Way
    East Sussex
    United Kingdom
    BritishFinance Director109143970003
    WHITE, Andrew Robert
    18 Maple Road
    Eastbourne
    BN23 6NZ East Sussex
    Secrétaire
    18 Maple Road
    Eastbourne
    BN23 6NZ East Sussex
    British159789980001
    BARTLE, Kenneth
    Mill Hill
    Rattlesden
    IP30 0SQ Bury St Edmunds
    The Smock Mill, Hitchcocks Mill
    Suffolk
    United Kingdom
    Administrateur
    Mill Hill
    Rattlesden
    IP30 0SQ Bury St Edmunds
    The Smock Mill, Hitchcocks Mill
    Suffolk
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector73909180007
    BARTLE, Kenneth
    The Smock Mill Hitchcocks Mill
    Mill Hill Rattlesden
    IP30 0SQ Bury St Edmunds
    Suffolk
    Administrateur
    The Smock Mill Hitchcocks Mill
    Mill Hill Rattlesden
    IP30 0SQ Bury St Edmunds
    Suffolk
    EnglandBritishRetail Consultant73909180007
    BOOT, Terry Michael
    Interlink Way West, Interlink Business Park
    Bardon
    LE67 1LD Coalville
    A Jones & Sons Limited
    Leicestershire
    England
    Administrateur
    Interlink Way West, Interlink Business Park
    Bardon
    LE67 1LD Coalville
    A Jones & Sons Limited
    Leicestershire
    England
    EnglandBritishCfo67041160001
    CHURCH, John George
    The Old Rectory
    Farthingstone
    NN12 8EZ Towcester
    Northamptonshire
    Administrateur
    The Old Rectory
    Farthingstone
    NN12 8EZ Towcester
    Northamptonshire
    United KingdomBritishChartered Accountant12963560001
    CLARK, Lancelot Pease
    Apartment 142
    Archie Street
    SE1 London
    Administrateur
    Apartment 142
    Archie Street
    SE1 London
    BritishManager28161570002
    COOK, Simon Edward
    1 Wheatfield Way
    LE10 1YG Hinckley
    Outersole House
    Leicestershire
    England
    Administrateur
    1 Wheatfield Way
    LE10 1YG Hinckley
    Outersole House
    Leicestershire
    England
    EnglandBritishCpo104673410002
    COORENS, Eric Maria Hendrikus
    Interlink Way West,
    Interlink Business Park
    LE67 1LD Bardon, Coalville
    Macintosh Fashion Uk
    Leicestershire
    United Kingdom
    Administrateur
    Interlink Way West,
    Interlink Business Park
    LE67 1LD Bardon, Coalville
    Macintosh Fashion Uk
    Leicestershire
    United Kingdom
    NetherlandsDutchChief Operating Officer157586370001
    CRAWSHAW, John
    2 Hyde Tynings Close
    BN20 7TQ Eastbourne
    East Sussex
    Administrateur
    2 Hyde Tynings Close
    BN20 7TQ Eastbourne
    East Sussex
    United KingdomBritishCompany Director121560001
    DE MOOR, Frank Karel
    Interlink Way West,
    Interlink Business Park
    LE67 1LD Bardon, Coalville
    Macintosh Fashion Uk
    Leicestershire
    United Kingdom
    Administrateur
    Interlink Way West,
    Interlink Business Park
    LE67 1LD Bardon, Coalville
    Macintosh Fashion Uk
    Leicestershire
    United Kingdom
    BelgiumBelgianChief Executive Office159745220001
    DUNCAN SMITH, Alastair David
    94 Wakehurst Road
    SW11 6BT London
    Administrateur
    94 Wakehurst Road
    SW11 6BT London
    BritishBusiness Manager69076490001
    HUNEN, Peter Therese Antoon
    Interlink Way West,
    Interlink Business Park
    LE67 1LD Bardon, Coalville
    Macintosh Fashion Uk
    Leicestershire
    United Kingdom
    Administrateur
    Interlink Way West,
    Interlink Business Park
    LE67 1LD Bardon, Coalville
    Macintosh Fashion Uk
    Leicestershire
    United Kingdom
    NetherlandsDutchCompany Secretary159744910001
    JELINEK, Vaclav
    2 Avenue Place, Avenue Lane
    BN21 3RB Eastbourne
    East Sussex
    Administrateur
    2 Avenue Place, Avenue Lane
    BN21 3RB Eastbourne
    East Sussex
    BritishRetail Executive109139210002
    JOHNSON, David Edward
    20 Great Footway
    Langton Green
    TN3 0DT Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    20 Great Footway
    Langton Green
    TN3 0DT Tunbridge Wells
    Kent
    BritishChartered Accountant10571470001
    KENNEDY, Iain Manning
    3 Townsend Close
    NN6 9HP Hanging Houghton
    Northamptonshire
    Administrateur
    3 Townsend Close
    NN6 9HP Hanging Houghton
    Northamptonshire
    EnglandBritishCompany Director187882990001
    NOBLE, Alison Jane Bennett
    82 Gayville Road
    SW11 6JP London
    Administrateur
    82 Gayville Road
    SW11 6JP London
    United KingdomBritishRetail Buyer103289830002
    PHILLIPS, Peter John
    Gibraltar Lane
    Cookham Dean
    SL6 9TR Maidenhead
    Gibraltar House
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Gibraltar Lane
    Cookham Dean
    SL6 9TR Maidenhead
    Gibraltar House
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector51075400001
    PHILLIPS, Peter John
    St. Peter Street
    SL7 1NQ Marlow
    The Minnows
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    St. Peter Street
    SL7 1NQ Marlow
    The Minnows
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    BritishCompany Director51075400002
    SHORT, David Robert
    1 Wheatfield Way
    LE10 1YG Hinckley
    Outersole House
    Leicestershire
    England
    Administrateur
    1 Wheatfield Way
    LE10 1YG Hinckley
    Outersole House
    Leicestershire
    England
    EnglandBritishCeo38957690003
    SHORTEN, Paul William
    Kinell Windmill Green
    Stone Cross
    BN24 5DY Pevensey
    East Sussex
    Administrateur
    Kinell Windmill Green
    Stone Cross
    BN24 5DY Pevensey
    East Sussex
    BritishCompany Director33661480001
    STRIJBOS, Theodorus Leonardus
    Interlink Way West,
    Interlink Business Park
    LE67 1LD Bardon, Coalville
    Macintosh Fashion Uk
    Leicestershire
    United Kingdom
    Administrateur
    Interlink Way West,
    Interlink Business Park
    LE67 1LD Bardon, Coalville
    Macintosh Fashion Uk
    Leicestershire
    United Kingdom
    NetherlandsDutchChief Financial Officer157586510001
    TODD, Jeremy
    West Street
    TN20 6DS Mayfield
    Knowle Way
    East Sussex
    United Kingdom
    Administrateur
    West Street
    TN20 6DS Mayfield
    Knowle Way
    East Sussex
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director109143970003
    WALTON JONES, Howard
    Robin Hill Tilley Lane
    Boreham Street
    BN27 4UT Hailsham
    East Sussex
    Administrateur
    Robin Hill Tilley Lane
    Boreham Street
    BN27 4UT Hailsham
    East Sussex
    BritishCompany Director20804560001
    WATKINSON, John Dudley
    Glebe Farm
    Old Weston Road
    PE28 5AG Brington
    Cambs
    Administrateur
    Glebe Farm
    Old Weston Road
    PE28 5AG Brington
    Cambs
    EnglandBritishDirector66949520004
    WHITE, Andrew Robert
    Highgate Drive
    Knighton
    LE2 6HJ Leicester
    31
    Leicestershire
    United Kingdom
    Administrateur
    Highgate Drive
    Knighton
    LE2 6HJ Leicester
    31
    Leicestershire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector146324190001

    JTB REALISATIONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 22 sept. 2016
    Livré le 28 sept. 2016
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Alteri Europe, L.P.
    Transactions
    • 28 sept. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 15 févr. 2016
    Livré le 17 févr. 2016
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Alteri Europe, L.P. (The Security Agent)
    Transactions
    • 17 févr. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 26 oct. 2015
    Livré le 02 nov. 2015
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Alteri Europe L.P. (As Secuirty Agent)
    Transactions
    • 02 nov. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 26 oct. 2015
    Livré le 02 nov. 2015
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Alteri Europe, L.P. (As Security Agent)
    Transactions
    • 02 nov. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 14 nov. 2014
    Livré le 25 nov. 2014
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ing Bank N.V. (The "Security Agent") as Trustee for Each of the Secured Parties
    Transactions
    • 25 nov. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 28 sept. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 14 nov. 2014
    Livré le 25 nov. 2014
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ing Bank N.V., Acting in Its Capacity of Security Agent (The "Secured Party" Which Expression Includes Its Successors and Assigns)
    Transactions
    • 25 nov. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 30 oct. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 15 sept. 2010
    Livré le 18 sept. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 18 sept. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 20 mai 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 09 nov. 2005
    Livré le 16 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 16 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 janv. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 20 déc. 2002
    Livré le 02 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 02 janv. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 déc. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 07 mars 2002
    Livré le 21 mars 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 21 mars 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 déc. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 08 févr. 2002
    Livré le 23 févr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 23 févr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 mars 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental mortgage to a debenture dated 22 february 2001,
    Créé le 16 août 2001
    Livré le 03 sept. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities, whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever, of each obligor to the lender
    Brèves mentions
    By way of first legal mortgage the property being all that l/h premises k/a 53 west street horsham west sussex, all that l/h premises k/a number 30-32 the promenade cheltenham gloucestershire, all that l/h premises k/a 40 high street reigate surrey RH2 9AT, all that l/h premises k/a 103-105 terminus road eastbourne east sussex, together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures) at any time thereon.
    Personnes ayant droit
    • Burdale Financial Limited
    Transactions
    • 03 sept. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 déc. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental debenture to a debenture dated 22 february 2001 made between (amongst others) the chargor and burdale financial limited
    Créé le 10 août 2001
    Livré le 31 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee (all terms as defined)
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge all of its right title and interest in and to the additional collection account and all monies standing to the credit of the additional collection account and the debts represented by them. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Burdale Financial Limited
    Transactions
    • 31 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 déc. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security agreement
    Créé le 22 févr. 2001
    Livré le 07 mars 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to or in connection with the facility agreement (all terms as defined)
    Brèves mentions
    In order to provide continuing security for the payment or performance of the obligation in the agreement the obligor vested possession of the certificates of title to the collateral in the secured party (or its agent) to the intent that the secured party should have a security interest or interests in the collateral in accordance with article 2 (3) of the 1983 law but so that the secured party should not in any circumstances incur any liability or be under any obligation whatsoever in connection with the collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Burdale Financial Limited
    Transactions
    • 07 mars 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 déc. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of debenture made between, amongst others, the company and the chargee
    Créé le 22 févr. 2001
    Livré le 07 mars 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities of each obligor to the chargee (all terms as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Burdale Financial Limited
    Transactions
    • 07 mars 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 déc. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 22 févr. 2001
    Livré le 07 mars 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies and liabilities due or to become due from the company to the chargee under the loan note instrument and in accordance with the terms of an agreement of even date
    Brèves mentions
    Floating charge. Undertaking and all property and assets.
    Personnes ayant droit
    • Church & Co PLC
    Transactions
    • 07 mars 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security
    Créé le 20 avr. 1995
    Livré le 21 avr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £20,000 due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    First floor office premises at 56 hanover street edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • Scottish Amicable Life Assurance Society Limited
    Transactions
    • 21 avr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 févr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    JTB REALISATIONS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    24 mars 2017Administration started
    05 avr. 2019Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Blair Carnegie Nimmo
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    William James Wright
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Stephen John Absolom
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0