SPIRIT GROUP RETAIL (NORTH) LIMITED

SPIRIT GROUP RETAIL (NORTH) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSPIRIT GROUP RETAIL (NORTH) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00302339
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SPIRIT GROUP RETAIL (NORTH) LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe SPIRIT GROUP RETAIL (NORTH) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Resolve Partners Limited 22 York Buildings
    John Adam Street
    WC2N 6JU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SPIRIT GROUP RETAIL (NORTH) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SCOTTISH & NEWCASTLE RETAIL (NORTH) LIMITED03 sept. 199603 sept. 1996
    CLIFTON INNS LIMITED31 déc. 197931 déc. 1979
    CLIFTON INNKEEPERS LIMITED31 déc. 197731 déc. 1977
    CLIFTON TAVERNS LIMITED27 juin 193527 juin 1935

    Quels sont les derniers comptes de SPIRIT GROUP RETAIL (NORTH) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au22 août 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour SPIRIT GROUP RETAIL (NORTH) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    10 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 11 janv. 2018

    9 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de Resolve Partners Limited 48 Warwick Street London W1B 5NL à Resolve Partners Limited 22 York Buildings John Adam Street London WC2N 6JU le 13 sept. 2017

    2 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 01 mars 2017 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT United Kingdom à Resolve Partners Limited 48 Warwick Street London W1B 5NL le 08 févr. 2017

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 12 janv. 2017

    LRESSP

    Nomination de Lindsay Anne Keswick en tant que secrétaire le 25 avr. 2016

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Claire Susan Stewart en tant que secrétaire le 25 avr. 2016

    1 pagesTM02

    Changement d'adresse du siège social de Sunrise House Ninth Avenue Burton upon Trent Staffordshire DE14 3JZ à Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT le 07 mars 2016

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 mars 2016 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 mars 2016

    État du capital au 01 mars 2016

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 22 août 2015

    4 pagesAA

    Cessation de la nomination de Jonathan Robert Langford en tant que directeur le 26 janv. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Daryl Antony Kelly en tant que directeur le 26 janv. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Lucy Jane Bell en tant que directeur le 26 janv. 2016

    1 pagesTM01

    Nomination de Kirk Dyson Davis en tant qu'administrateur le 21 déc. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Henry Jones en tant que secrétaire le 04 déc. 2015

    1 pagesTM02

    Période comptable actuelle raccourcie du 24 août 2016 au 30 avr. 2016

    1 pagesAA01

    Cessation de la nomination de Patrick James Gallagher en tant que directeur le 23 juin 2015

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 mars 2015 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 mars 2015

    État du capital au 02 mars 2015

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 23 août 2014

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 mars 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 mars 2014

    État du capital au 03 mars 2014

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 17 août 2013

    3 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de SPIRIT GROUP RETAIL (NORTH) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KESWICK, Lindsay Anne
    22 York Buildings
    John Adam Street
    WC2N 6JU London
    Resolve Partners Limited
    Secrétaire
    22 York Buildings
    John Adam Street
    WC2N 6JU London
    Resolve Partners Limited
    207523760001
    DAVIS, Kirk Dyson
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector158484730001
    CUTHBERTSON, Colin
    5 Hill Gardens
    LE16 9EB Market Harborough
    Leicestershire
    Secrétaire
    5 Hill Gardens
    LE16 9EB Market Harborough
    Leicestershire
    British26369940001
    HOMER, Neville Rex
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    Secrétaire
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    British895960001
    JONES, Henry
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    180592530001
    KENDALL, Timothy James
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    Secrétaire
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    British117397470002
    RUDD, Susan Clare
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    172445010001
    RUDD, Susan Clare
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    Secrétaire
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    British81789210004
    STEVENS, Mark
    5 Lyon Drive
    Murieston
    EH54 9HF Livingston
    West Lothian
    Secrétaire
    5 Lyon Drive
    Murieston
    EH54 9HF Livingston
    West Lothian
    British80951870001
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    181022270001
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Other130369890001
    WALMSLEY, Derek Kerr
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    Secrétaire
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    British135181230001
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector131551840002
    BELL, Lucy Jane
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector164754670001
    BUBB, Stewart Edmund Conyers
    Clare Cottage
    42 Lammas Lane
    KT10 8PD Esher
    Surrey
    Administrateur
    Clare Cottage
    42 Lammas Lane
    KT10 8PD Esher
    Surrey
    BritishCompany Director36779040001
    CRICHTON, Roger Wells
    Pitsford House West
    Manor Road, Pitsford
    NN6 9AR Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    Pitsford House West
    Manor Road, Pitsford
    NN6 9AR Northampton
    Northamptonshire
    BritishChartered Surveyor67937290001
    CUMMING, Johanna Louise
    18 Prospect Quay
    98 Point Pleasant
    SW18 1PR London
    Administrateur
    18 Prospect Quay
    98 Point Pleasant
    SW18 1PR London
    United KingdomBritishDirector111108910001
    CUTHBERTSON, Colin
    5 Hill Gardens
    LE16 9EB Market Harborough
    Leicestershire
    Administrateur
    5 Hill Gardens
    LE16 9EB Market Harborough
    Leicestershire
    EnglandBritishChartered Accountant26369940001
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant152083750001
    DUTTON, Philip
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector141395280001
    GALLAGHER, Patrick James
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector205366190001
    GODWIN-BRATT, Robert James
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector170184800001
    HOMER, Neville Rex
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    Administrateur
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    BritishCompany Director895960001
    JACOBS, David Michael
    Riverside House
    Hall Cottages Lodden Drive
    RG10 8ND Reading
    Berkshire
    Administrateur
    Riverside House
    Hall Cottages Lodden Drive
    RG10 8ND Reading
    Berkshire
    BritishManaging Director47141160001
    JONES, Karen Elisabeth Dind
    Paddock House
    9 Spencer Park Wandsworth
    SW18 2SX London
    Administrateur
    Paddock House
    9 Spencer Park Wandsworth
    SW18 2SX London
    United KingdomBritishCompany Director47793260007
    KELLY, Daryl Antony
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant86246470001
    KNIGHT, Andrew Ronald
    89 Main Street
    DE13 7ED Alrewas
    Staffordshire
    Administrateur
    89 Main Street
    DE13 7ED Alrewas
    Staffordshire
    BritishCompany Director81555100002
    LANGFORD, Jonathan Robert
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector135408140001
    LESLIE, John Stewart
    Bec House Church End
    HP27 9PD Bledlow
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Bec House Church End
    HP27 9PD Bledlow
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishDirector59934350001
    MARGERRISON, Russell John
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector170590800001
    MCDONALD, Robert James
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    Administrateur
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    BritishDirector42019620001
    PEAREY, Michael John
    The Lodge
    EH32 0RE Aberlady
    East Lothian
    Administrateur
    The Lodge
    EH32 0RE Aberlady
    East Lothian
    BritishCompany Director46305030001
    PRESTON, Neil David
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector63043630002
    RIKLIN, Cornel Carl
    103 Barrow Gate Road
    Chiswick
    W4 4QS London
    Administrateur
    103 Barrow Gate Road
    Chiswick
    W4 4QS London
    EnglandSwissManaging Director78412270001
    RIPPER, Christopher
    Hillroft House
    Main Street Upper Stowe
    NN7 4SH Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    Hillroft House
    Main Street Upper Stowe
    NN7 4SH Northampton
    Northamptonshire
    BritishCommercial Director97847560001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour SPIRIT GROUP RETAIL (NORTH) LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    01 mars 2017La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    SPIRIT GROUP RETAIL (NORTH) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Security agreement
    Créé le 15 déc. 2003
    Livré le 31 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent) as Agent and Trustee for the Financeparties
    Transactions
    • 31 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 déc. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 24 oct. 1986
    Livré le 29 oct. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Units 39 and 40 at weston fawell shopping centre in the borough of nottingham together k/a "the swinging sporran" t/n N1033519 (please see doc for full details).
    Personnes ayant droit
    • Scottish & Newcastle Breweries PLC
    Transactions
    • 29 oct. 1986Enregistrement d'une charge
    • 09 févr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deposit of deeds without written instrument
    Créé le 13 juil. 1960
    Livré le 19 juil. 1960
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due etc
    Brèves mentions
    The portman arms, 21 balcombe street london N.W.1.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale and North of Scotland Bank Limited
    Transactions
    • 19 juil. 1960Enregistrement d'une charge
    • 09 févr. 2004Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 26 oct. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    SPIRIT GROUP RETAIL (NORTH) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    12 janv. 2017Commencement of winding up
    15 avr. 2019Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Ben David Woodthorpe
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London
    practitioner
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London
    Simon Harris
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London
    practitioner
    48 Warwick Street
    W1B 5NL London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0