SPIRIT GROUP RETAIL (NORTH) LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | SPIRIT GROUP RETAIL (NORTH) LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00302339 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SPIRIT GROUP RETAIL (NORTH) LIMITED ?
Adresse du siège social | Resolve Partners Limited 22 York Buildings John Adam Street WC2N 6JU London |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SPIRIT GROUP RETAIL (NORTH) LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 22 août 2015 |
Quels sont les derniers dépôts pour SPIRIT GROUP RETAIL (NORTH) LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 10 pages | LIQ13 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 11 janv. 2018 | 9 pages | LIQ03 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Resolve Partners Limited 48 Warwick Street London W1B 5NL à Resolve Partners Limited 22 York Buildings John Adam Street London WC2N 6JU le 13 sept. 2017 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 mars 2017 avec mises à jour | 6 pages | CS01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT United Kingdom à Resolve Partners Limited 48 Warwick Street London W1B 5NL le 08 févr. 2017 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 3 pages | 4.70 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 1 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Lindsay Anne Keswick en tant que secrétaire le 25 avr. 2016 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Claire Susan Stewart en tant que secrétaire le 25 avr. 2016 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Sunrise House Ninth Avenue Burton upon Trent Staffordshire DE14 3JZ à Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT le 07 mars 2016 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 mars 2016 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 22 août 2015 | 4 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jonathan Robert Langford en tant que directeur le 26 janv. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Daryl Antony Kelly en tant que directeur le 26 janv. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Lucy Jane Bell en tant que directeur le 26 janv. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Kirk Dyson Davis en tant qu'administrateur le 21 déc. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Henry Jones en tant que secrétaire le 04 déc. 2015 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Période comptable actuelle raccourcie du 24 août 2016 au 30 avr. 2016 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Patrick James Gallagher en tant que directeur le 23 juin 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 mars 2015 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 23 août 2014 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 mars 2014 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 17 août 2013 | 3 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de SPIRIT GROUP RETAIL (NORTH) LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESWICK, Lindsay Anne | Secrétaire | 22 York Buildings John Adam Street WC2N 6JU London Resolve Partners Limited | 207523760001 | |||||||
DAVIS, Kirk Dyson | Administrateur | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 158484730001 | ||||
CUTHBERTSON, Colin | Secrétaire | 5 Hill Gardens LE16 9EB Market Harborough Leicestershire | British | 26369940001 | ||||||
HOMER, Neville Rex | Secrétaire | Caberfeidh 12 Forth Street EH39 4HY North Berwick East Lothian | British | 895960001 | ||||||
JONES, Henry | Secrétaire | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 180592530001 | |||||||
KENDALL, Timothy James | Secrétaire | 31 Canterbury Close Erdington B23 7QL Birmingham West Midlands | British | 117397470002 | ||||||
RUDD, Susan Clare | Secrétaire | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 172445010001 | |||||||
RUDD, Susan Clare | Secrétaire | 17 Thacker Drive WS13 6NS Lichfield Staffordshire | British | 81789210004 | ||||||
STEVENS, Mark | Secrétaire | 5 Lyon Drive Murieston EH54 9HF Livingston West Lothian | British | 80951870001 | ||||||
STEWART, Claire Susan | Secrétaire | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 181022270001 | |||||||
STEWART, Claire Susan | Secrétaire | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | Other | 130369890001 | ||||||
WALMSLEY, Derek Kerr | Secrétaire | High Street Pavenham MK43 7NJ Bedford Walnut Barn Bedfordshire | British | 135181230001 | ||||||
BASHFORTH, Edward Michael | Administrateur | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 131551840002 | ||||
BELL, Lucy Jane | Administrateur | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 164754670001 | ||||
BUBB, Stewart Edmund Conyers | Administrateur | Clare Cottage 42 Lammas Lane KT10 8PD Esher Surrey | British | Company Director | 36779040001 | |||||
CRICHTON, Roger Wells | Administrateur | Pitsford House West Manor Road, Pitsford NN6 9AR Northampton Northamptonshire | British | Chartered Surveyor | 67937290001 | |||||
CUMMING, Johanna Louise | Administrateur | 18 Prospect Quay 98 Point Pleasant SW18 1PR London | United Kingdom | British | Director | 111108910001 | ||||
CUTHBERTSON, Colin | Administrateur | 5 Hill Gardens LE16 9EB Market Harborough Leicestershire | England | British | Chartered Accountant | 26369940001 | ||||
DANDO, Stephen Peter | Administrateur | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 152083750001 | ||||
DUTTON, Philip | Administrateur | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 141395280001 | ||||
GALLAGHER, Patrick James | Administrateur | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | England | British | Director | 205366190001 | ||||
GODWIN-BRATT, Robert James | Administrateur | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 170184800001 | ||||
HOMER, Neville Rex | Administrateur | Caberfeidh 12 Forth Street EH39 4HY North Berwick East Lothian | British | Company Director | 895960001 | |||||
JACOBS, David Michael | Administrateur | Riverside House Hall Cottages Lodden Drive RG10 8ND Reading Berkshire | British | Managing Director | 47141160001 | |||||
JONES, Karen Elisabeth Dind | Administrateur | Paddock House 9 Spencer Park Wandsworth SW18 2SX London | United Kingdom | British | Company Director | 47793260007 | ||||
KELLY, Daryl Antony | Administrateur | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 86246470001 | ||||
KNIGHT, Andrew Ronald | Administrateur | 89 Main Street DE13 7ED Alrewas Staffordshire | British | Company Director | 81555100002 | |||||
LANGFORD, Jonathan Robert | Administrateur | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 135408140001 | ||||
LESLIE, John Stewart | Administrateur | Bec House Church End HP27 9PD Bledlow Buckinghamshire | United Kingdom | British | Director | 59934350001 | ||||
MARGERRISON, Russell John | Administrateur | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | England | British | Director | 170590800001 | ||||
MCDONALD, Robert James | Administrateur | 46 Wentworth Drive WS14 9HN Lichfield Staffordshire | British | Director | 42019620001 | |||||
PEAREY, Michael John | Administrateur | The Lodge EH32 0RE Aberlady East Lothian | British | Company Director | 46305030001 | |||||
PRESTON, Neil David | Administrateur | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 63043630002 | ||||
RIKLIN, Cornel Carl | Administrateur | 103 Barrow Gate Road Chiswick W4 4QS London | England | Swiss | Managing Director | 78412270001 | ||||
RIPPER, Christopher | Administrateur | Hillroft House Main Street Upper Stowe NN7 4SH Northampton Northamptonshire | British | Commercial Director | 97847560001 |
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour SPIRIT GROUP RETAIL (NORTH) LIMITED ?
Notifié le | Cessé le | Déclaration |
---|---|---|
01 mars 2017 | La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société. |
SPIRIT GROUP RETAIL (NORTH) LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Security agreement | Créé le 15 déc. 2003 Livré le 31 déc. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage | Créé le 24 oct. 1986 Livré le 29 oct. 1986 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brèves mentions Units 39 and 40 at weston fawell shopping centre in the borough of nottingham together k/a "the swinging sporran" t/n N1033519 (please see doc for full details). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deposit of deeds without written instrument | Créé le 13 juil. 1960 Livré le 19 juil. 1960 | Totalement satisfaite | Montant garanti All moneys due etc | |
Brèves mentions The portman arms, 21 balcombe street london N.W.1. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
SPIRIT GROUP RETAIL (NORTH) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0