HEATH LAMBERT INSURANCE SERVICES LIMITED

HEATH LAMBERT INSURANCE SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHEATH LAMBERT INSURANCE SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00308512
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HEATH LAMBERT INSURANCE SERVICES LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe HEATH LAMBERT INSURANCE SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    133 Houndsditch
    London
    EC3A 7AH
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HEATH LAMBERT INSURANCE SERVICES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HEATH INSURANCE SERVICES LIMITED30 oct. 199630 oct. 1996
    C E HEATH (INSURANCE SERVICES) LIMITED28 nov. 199028 nov. 1990
    B & C INSURANCE BROKERS (UK) LIMITED02 août 198902 août 1989
    B & C INSURANCE BROKERS LIMITED 01 juil. 198801 juil. 1988
    CAYZER STEEL BOWATER (LONDON) LIMITED13 août 198513 août 1985
    TENNANT BUDD LIMITED21 déc. 193521 déc. 1935

    Quels sont les derniers comptes de HEATH LAMBERT INSURANCE SERVICES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour HEATH LAMBERT INSURANCE SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Cessation de la nomination de William David Bloomer en tant que directeur le 10 oct. 2011

    2 pagesTM01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2011

    15 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 févr. 2011

    État du capital au 15 févr. 2011

    • Capital: GBP 8,300,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    5 pagesAA

    Période comptable précédente raccourcie du 31 mars 2010 au 31 déc. 2009

    3 pagesAA01

    Résolutions

    Resolutions
    29 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Déclaration des objets de la société

    1 pagesCC04

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2010

    15 pagesAR01

    Détails de la variation des droits attachés aux actions

    2 pagesSH10

    Nomination de Mr Adrian Colosso en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Michael Bruce en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Comptes établis au 31 mars 2009

    5 pagesAA

    legacy

    8 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    Comptes établis au 31 mars 2008

    6 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    Comptes établis au 31 mars 2007

    6 pagesAA

    legacy

    8 pages363s

    legacy

    pages363(288)

    legacy

    pages363(353)

    Comptes établis au 31 mars 2006

    7 pagesAA

    legacy

    1 pages287

    Qui sont les dirigeants de HEATH LAMBERT INSURANCE SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HL CORPORATE SERVICES LIMITED
    133 Houndsditch
    EC3A 7AH London
    Secrétaire
    133 Houndsditch
    EC3A 7AH London
    43700080007
    COLOSSO, Adrian
    Burnham Road
    Woodham Mortimer
    CM9 6SP Maldon
    Hillside Farm
    Essex
    Administrateur
    Burnham Road
    Woodham Mortimer
    CM9 6SP Maldon
    Hillside Farm
    Essex
    EnglandBritishGroup Chief Executive4555310002
    THOMAS, Robert Nigel
    South West House
    Weston Road
    BA1 2XU Bath
    Avon
    Administrateur
    South West House
    Weston Road
    BA1 2XU Bath
    Avon
    United KindgomBritishAccountant40630840002
    SHARP, Pandora
    Flat 9 Da Vinci Court
    1 Rossetti Road
    SE16 3EA London
    Secrétaire
    Flat 9 Da Vinci Court
    1 Rossetti Road
    SE16 3EA London
    British64972020003
    WILKINSON, Sidney James
    67 Chessfield Park
    Little Chalfont
    HP6 6RU Amersham
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    67 Chessfield Park
    Little Chalfont
    HP6 6RU Amersham
    Buckinghamshire
    British1138390001
    BAREHAM, Robert Edward
    Squirrels
    33 Bidborough Ridge
    TN4 0UT Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    Squirrels
    33 Bidborough Ridge
    TN4 0UT Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritishChartered Accountant8522090001
    BARTLETT, Steven James
    10 Ash Meadow
    Willesborough
    TN24 0LW Ashford
    Kent
    Administrateur
    10 Ash Meadow
    Willesborough
    TN24 0LW Ashford
    Kent
    EnglandBritishInsurance Broker47527700001
    BLOOMER, William David
    Barry Road
    East Dulwich
    SE22 0JS London
    214
    Administrateur
    Barry Road
    East Dulwich
    SE22 0JS London
    214
    United KingdomBritishCompany Solicitor72374560002
    BRUCE, Michael Andrew
    Royston Manor St Peter's Lane
    Clayworth
    DN22 9AA Retford
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Royston Manor St Peter's Lane
    Clayworth
    DN22 9AA Retford
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishGroup Managing Director61928170002
    CONSTABLE, Robert Mark
    9 Mount Road
    GU6 7LT Cranleigh
    Surrey
    Administrateur
    9 Mount Road
    GU6 7LT Cranleigh
    Surrey
    BritishInsurance Broker115305700001
    DRUMMOND, Peter David
    Angel House
    Angel Street
    GU28 0BJ Petworth
    West Sussex
    Administrateur
    Angel House
    Angel Street
    GU28 0BJ Petworth
    West Sussex
    BritishInsurance Broker34676460002
    GARNHAM, Jasper Meredydd
    Harewood Lodge Bulstrode Way
    SL9 7QT Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Harewood Lodge Bulstrode Way
    SL9 7QT Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishInsurance Broker8522110001
    IRONMONGER, Richard Kenneth
    Briar Cottage
    Broadmore Lane
    IP25 6TE Carbrooke
    Norfolk
    Administrateur
    Briar Cottage
    Broadmore Lane
    IP25 6TE Carbrooke
    Norfolk
    BritishInsurance Broker8852330004
    JERVIS, Ian Michael Peter
    1 Hove Park Way
    BN3 6PS Hove
    East Sussex
    Administrateur
    1 Hove Park Way
    BN3 6PS Hove
    East Sussex
    BritishInsurance Broker77237610001
    KAUFMAN, John Banwell
    6 Scotsdale Close
    BR5 1NU Petts Wood
    Kent
    Administrateur
    6 Scotsdale Close
    BR5 1NU Petts Wood
    Kent
    EnglandBritishInsurance Broker147388510001
    KIER, Michael Hector
    23 Belmont Road
    TW2 5DA Twickenham
    Middlesex
    Administrateur
    23 Belmont Road
    TW2 5DA Twickenham
    Middlesex
    DanishLloyds Broker8719670001
    MANSFIELD, Diane Frances
    Barton
    Crossways Park, West Chiltington
    RH20 2QZ Pulborough
    West Sussex
    Administrateur
    Barton
    Crossways Park, West Chiltington
    RH20 2QZ Pulborough
    West Sussex
    BritishChartered Accountant64151360001
    MARGRETT, David Basil
    60 Deansway
    Finchley
    N2 0JE London
    Administrateur
    60 Deansway
    Finchley
    N2 0JE London
    BritishInsurance Broker313150002
    ROWE, Nicholas
    Amberly House
    The Cleave
    OX11 0EL Harwell
    Oxfordshire
    Administrateur
    Amberly House
    The Cleave
    OX11 0EL Harwell
    Oxfordshire
    BritishCompany Secretary33862660001
    RUNCIMAN, Jeffrey Keith
    7 Pinfold Close
    Hale Barns
    WA15 0SA Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    7 Pinfold Close
    Hale Barns
    WA15 0SA Altrincham
    Cheshire
    BritishInsurance Broker10020520001
    SANSOM, Richard James
    12 Birch Mead
    Locksbottom
    BR6 8LT Orpington
    Kent
    Administrateur
    12 Birch Mead
    Locksbottom
    BR6 8LT Orpington
    Kent
    United KingdomBritishChartered Accountant105966060001
    SIMPER, Anthony
    21 Lambourn Way
    Lords Wood
    ME5 8PU Chatham
    Kent
    Administrateur
    21 Lambourn Way
    Lords Wood
    ME5 8PU Chatham
    Kent
    BritishInsurance Broker34987510001
    SMITH, Paul David
    Applegarth
    Faygate Lane, Rusper
    RH12 4RF Horsham
    West Sussex
    Administrateur
    Applegarth
    Faygate Lane, Rusper
    RH12 4RF Horsham
    West Sussex
    EnglandBritishInsurance Broker8522160002
    SPRINGBETT, David John
    Abbey House Huntercombe Lane South
    Taplow
    SL6 0PQ Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    Abbey House Huntercombe Lane South
    Taplow
    SL6 0PQ Maidenhead
    Berkshire
    BritishInsurance Broker12798880001
    SUMMERS, Paul John
    14 Whorlton Road
    SE15 3PD London
    Administrateur
    14 Whorlton Road
    SE15 3PD London
    BritishInsurance Broker28330910003
    WAKELING, Julian David
    18 Lightwater Meadow
    GU18 5XH Lightwater
    Surrey
    Administrateur
    18 Lightwater Meadow
    GU18 5XH Lightwater
    Surrey
    EnglandBritishInsurance Broker34987520001
    WARBURTON, Brian
    Great Mead Standon Green End
    High Cross
    SG11 1BP Ware
    Hertfordshire
    Administrateur
    Great Mead Standon Green End
    High Cross
    SG11 1BP Ware
    Hertfordshire
    BritishInsurance Broker8514310001
    WILKINSON, Ian Michael Colin
    Fuggles Oast Amber Lane
    Chart Sutton
    ME17 3SF Maidstone
    Kent
    Administrateur
    Fuggles Oast Amber Lane
    Chart Sutton
    ME17 3SF Maidstone
    Kent
    BritishInsurance Broker28330920001

    HEATH LAMBERT INSURANCE SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee & debenture
    Créé le 29 févr. 2000
    Livré le 09 mars 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any of the secured parties (as defined) pursuant to all or any of the secured documents (as defined), including the debenture
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 09 mars 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of variation made in addition to and modifying the security and trust deed dated 18 september 1989 ("the principal deed") as modified by a deed of variation dated 1 november 1993 (the "first deed of variation")
    Créé le 23 sept. 1999
    Livré le 01 oct. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    All monies (including brokerage) for the time being standing to the credit of or pursuant to lloyds brokers byelaw (no.5 Of 1988) (see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Lloyds
    Transactions
    • 01 oct. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 juil. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Second guarantee and debenture
    Créé le 03 déc. 1997
    Livré le 22 déc. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the senior finance documents and the debenture as defined therein
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for the Beneficiaries
    Transactions
    • 22 déc. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 mai 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of variation
    Créé le 01 nov. 1993
    Livré le 10 nov. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For varying the terms of the security trust deed dated 18 september 1989
    Brèves mentions
    All monies (including brokerage) for the time being standing to the credit of or pursuant to the byelaw required. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds
    Transactions
    • 10 nov. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 juil. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment
    Créé le 16 mai 1990
    Livré le 31 mai 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All moneys due or owing or from time to time becoming due or owing to the company under or by virtue of a sum of sterling pounds 75,000 placed on call deposit with barclays de zoete wedd on 16-5-90 under deal reference no 495002, in name of barclays bank PLC re b & c insurance brokers (UK) limited.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 31 mai 1990Enregistrement d'une charge
    Security and trust deed
    Créé le 18 sept. 1989
    Livré le 23 sept. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    All monies (including brokerage) for the time being standing to the credit of or pursuant to lloyds brokers byelaw (no. 5 of 1988) (see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Lloyds
    Transactions
    • 23 sept. 1989Enregistrement d'une charge
    • 13 juil. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Trust deed
    Créé le 23 févr. 1983
    Livré le 04 mars 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    Brèves mentions
    All that the company's right title and interest in the monies standing to the credit of the company's "c" account at the date of the trust deed (see doc M135 for further details).
    Personnes ayant droit
    • The Corporation of Lloyds
    Transactions
    • 04 mars 1983Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0