WESSEX TEXTILES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWESSEX TEXTILES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00312129
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WESSEX TEXTILES LIMITED ?

    • fabrication de vêtements de travail (14120) / Industries manufacturières

    Où se situe WESSEX TEXTILES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    3 Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    Derbyshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de WESSEX TEXTILES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WESSEX TEXTILES 1988 LIMITED07 juin 198807 juin 1988
    THOMAS MACK & COMPANY LIMITED26 mars 193626 mars 1936

    Quels sont les derniers comptes de WESSEX TEXTILES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 janv. 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour WESSEX TEXTILES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    4 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 déc. 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 déc. 2012

    État du capital au 28 déc. 2012

    • Capital: GBP 205,000
    SH01

    Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré

    1 pagesAD04

    Comptes pour une société dormante établis au 31 janv. 2012

    7 pagesAA

    Cessation de la nomination de Neill Davis en tant que directeur le 31 juil. 2012

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 déc. 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Diana Wilson le 29 déc. 2011

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr. Simon Ralph Hughes le 04 janv. 2012

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 janv. 2011

    7 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Neill Davis le 06 sept. 2011

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Stuart William Graham le 16 sept. 2011

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 déc. 2010 avec liste complète des actionnaires

    18 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    7 pagesAA

    Nomination de Diana Wilson en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Nomination de Neill Davis en tant qu'administrateur

    4 pagesAP01

    Nomination de Michael Conlon en tant que secrétaire

    3 pagesAP03

    Nomination de David Edwab en tant qu'administrateur

    4 pagesAP01

    Nomination de Stuart William Graham en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Nomination de Douglas Ewert en tant qu'administrateur

    4 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Richard Pearson en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Richard Pearson en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Période comptable actuelle prolongée du 27 déc. 2010 au 31 janv. 2011

    3 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de WESSEX TEXTILES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CONLON, Michael
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    Secrétaire
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    British153966220001
    EDWAB, David
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    Administrateur
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    United StatesAmerican153964010001
    EWERT, Douglas
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    Administrateur
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    United StatesAmerican153963360001
    GRAHAM, Stuart William
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    Administrateur
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    EnglandBritish125975700002
    HUGHES, Simon Ralph
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    Administrateur
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    United KingdomBritish121914600001
    WILSON, Diana
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    Administrateur
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    United StatesAmerican153963440001
    PEARSON, Graham
    21 The Orchards
    Pickmere
    WA16 0LS Knutsford
    Cheshire
    Secrétaire
    21 The Orchards
    Pickmere
    WA16 0LS Knutsford
    Cheshire
    British95884040002
    PEARSON, Richard Barrett
    20 Croft Road
    Edwalton
    NG12 4BW Nottingham
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    20 Croft Road
    Edwalton
    NG12 4BW Nottingham
    Nottinghamshire
    British121732790001
    TRAVIS, Joan Marion
    Kessel
    9 Winston Gardens
    HP4 4NS Berkhamsted
    Herts
    Secrétaire
    Kessel
    9 Winston Gardens
    HP4 4NS Berkhamsted
    Herts
    British21610990001
    TRAVIS, Lesley Anne
    Heatherways Frithsden Copse
    Potten End
    HP4 2RQ Berkhamsted
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Heatherways Frithsden Copse
    Potten End
    HP4 2RQ Berkhamsted
    Hertfordshire
    British49692080001
    CLARK, Felicity Ann Sarah
    2 Newmans Place
    Sunningdale
    SL5 0HN Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    2 Newmans Place
    Sunningdale
    SL5 0HN Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritish117788050001
    DAVIS, Neill
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    Administrateur
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    UsaUnited States153966520002
    FOX, David Mark, Mr.
    By Canal Cottage
    Creech St Michael
    TA3 5QD Taunton
    Somerset
    Administrateur
    By Canal Cottage
    Creech St Michael
    TA3 5QD Taunton
    Somerset
    United KingdomBritish21611010001
    PEARSON, Graham
    21 The Orchards
    Pickmere
    WA16 0LS Knutsford
    Cheshire
    Administrateur
    21 The Orchards
    Pickmere
    WA16 0LS Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish95884040002
    PEARSON, Richard Barrett
    20 Croft Road
    Edwalton
    NG12 4BW Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    20 Croft Road
    Edwalton
    NG12 4BW Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish121732790001
    SHANNON, Edward Anthony
    Barton Beeches
    683 Garstang Road, Barton
    PR3 5DQ Preston
    Lancashire
    Administrateur
    Barton Beeches
    683 Garstang Road, Barton
    PR3 5DQ Preston
    Lancashire
    British113624220002
    THOMAS, Adrian Peter Harrison
    26 Hartley Road
    WA14 4AY Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    26 Hartley Road
    WA14 4AY Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish26500450003
    TRAVIS, Joan Marion
    Kessel
    9 Winston Gardens
    HP4 4NS Berkhamsted
    Herts
    Administrateur
    Kessel
    9 Winston Gardens
    HP4 4NS Berkhamsted
    Herts
    British21610990001
    TRAVIS, Malcolm
    Heatherways Frithsden Copse
    Potten End
    HP4 2RQ Berkhamsted
    Hertfordshire
    Administrateur
    Heatherways Frithsden Copse
    Potten End
    HP4 2RQ Berkhamsted
    Hertfordshire
    EnglandBritish49692020001
    TRAVIS, Roland
    Kessel 9 Winston Gardens
    HP4 3NS Berkhamsted
    Hertfordshire
    Administrateur
    Kessel 9 Winston Gardens
    HP4 3NS Berkhamsted
    Hertfordshire
    British21610980001

    WESSEX TEXTILES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage debenture
    Créé le 15 mai 1998
    Livré le 05 juin 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 05 juin 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 déc. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0