EXCELSIOR HOTELS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | EXCELSIOR HOTELS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00318898 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe EXCELSIOR HOTELS LIMITED ?
| Adresse du siège social | Ship Canal House 8th Flooor 98 King Street M2 4WU Manchester |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de EXCELSIOR HOTELS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2006 |
Quels sont les derniers dépôts pour EXCELSIOR HOTELS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||
Retour de la r éunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 14 pages | LIQ13 | ||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 août 2021 | 5 pages | 4.68 | ||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 févr. 2021 | 5 pages | 4.68 | ||
Changement d'adresse du siège social de Ship Canal House 8th Floor 98 King Street Manchester M2 4WB à Ship Canal House 8th Flooor 98 King Street Manchester M2 4WU le 11 nov. 2020 | 2 pages | AD01 | ||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 août 2020 | 5 pages | 4.68 | ||
Changement d'adresse du siège social de 5th Floor the Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB à Ship Canal House 8th Floor 98 King Street Manchester M2 4WB le 16 mars 2020 | 2 pages | AD01 | ||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 févr. 2020 | 5 pages | 4.68 | ||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 août 2019 | 5 pages | 4.68 | ||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 4 pages | 600 | ||
Démission d'un liquidateur | 3 pages | LIQ06 | ||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 févr. 2019 | 5 pages | 4.68 | ||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 août 2018 | 5 pages | 4.68 | ||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 févr. 2018 | 5 pages | 4.68 | ||
Démission d'un liquidateur | 3 pages | LIQ06 | ||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 août 2017 | 5 pages | 4.68 | ||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 févr. 2017 | 9 pages | 4.68 | ||
Changement d'adresse du siège social de Zolfo Cooper Toronto Square Toronto Street Leeds West Yorkshire LS1 2HJ à 5th Floor the Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB le 01 sept. 2016 | 6 pages | AD01 | ||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 août 2016 | 9 pages | 4.68 | ||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 févr. 2016 | 5 pages | 4.68 | ||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 août 2015 | 5 pages | 4.68 | ||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 févr. 2015 | 9 pages | 4.68 | ||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 août 2014 | 9 pages | 4.68 | ||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 févr. 2014 | 9 pages | 4.68 | ||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 août 2013 | 9 pages | 4.68 | ||
Qui sont les dirigeants de EXCELSIOR HOTELS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARMAN SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Hesketh House 43-45 Portman Square W1H 6HN London | 98359920004 | |||||||
| CAMPBELL, Blair Patrick | Administrateur | 2 120 Goldburst Terrace NW6 3HR London | United Kingdom | New Zealander | 112856760002 | |||||
| NIXON, Edward John | Administrateur | Flat 2 3 Copse Hill SW20 0NA Wimbledon London | United Kingdom | British | 120665260001 | |||||
| EDIS-BATES, Jonathan Geoffrey | Secrétaire | The Croft Chalfont Lane Chorleywood WD3 5PP Rickmansworth Hertfordshire | British | 49678170001 | ||||||
| FRASER, Simon Scott | Secrétaire | Foxtrot 1 Shey Copse GU22 8HS Woking Surrey | British | 39862810001 | ||||||
| MACKENZIE, Lisa Marie | Secrétaire | 70 Vassall Road Kennington SW9 6HY London | British | 78059700001 | ||||||
| MASON, Timothy Charles | Secrétaire | 231 Station Road Knowle B93 0PU Solihull West Midlands | British | 12314170002 | ||||||
| MILLS, John Michael | Secrétaire | 33 Peplins Way AL9 7UR Brookmans Park Hertfordshire | British | 42268710001 | ||||||
| SIMS, Roy John Peter | Secrétaire | 6 Star Hill Drive Churt GU10 2HP Farnham Surrey | British | 12396130001 | ||||||
| SMALL, Jeremy Peter | Secrétaire | Cherry Trees West Heath GU24 0JQ Pirbright Surrey | British | 67168210001 | ||||||
| STEVENS, David John | Secrétaire | 42 Burghley Road Wimbledon SW19 5HN London | British | 56704240001 | ||||||
| TAUTZ, Helen Jane | Secrétaire | 30 South Crescent Prittlewell SS2 6TA Southend On Sea Essex | British | 37564540001 | ||||||
| FORTE NOMINEES LIMITED | Secrétaire | 166 High Holborn WC1V 6TT London | 42198970001 | |||||||
| EDIS-BATES, Jonathan Geoffrey | Administrateur | The Croft Chalfont Lane Chorleywood WD3 5PP Rickmansworth Hertfordshire | England | British | 49678170001 | |||||
| ELTON, James Robert | Administrateur | 27 Elsie Road SE22 8DX London | United Kingdom | British | 55689440001 | |||||
| FERGUSON, Iain Donald | Administrateur | 2 Chalet Close Shootersway Lane HP4 3NR Berkhamsted Hertfordshire | United Kingdom | British | 10297860001 | |||||
| FRASER, Simon Scott | Administrateur | Foxtrot 1 Shey Copse GU22 8HS Woking Surrey | British | 39862810001 | ||||||
| HILL, Nicholas Mark Lalor | Administrateur | 36 Hazlewell Road SW15 6LR London | United Kingdom | British | 76547250001 | |||||
| KANDERS, Alan J | Administrateur | Suite 2a 500 West End Avenue YO23 7DE New York North Yorkshire United States | United States Citizen | 114506230001 | ||||||
| LAMBERT, Bernard Charles Hector | Administrateur | Flat 10 21-23 Palace Gate W8 5LS London | Austria | French | 60956020002 | |||||
| LOVETT, Norman | Administrateur | 25 Balmoral Way Belmont Surrey | British | 49941610001 | ||||||
| MACKENZIE, Lisa Marie | Administrateur | 70 Vassall Road Kennington SW9 6HY London | British | 78059700001 | ||||||
| MAHONEY, Richard Lee | Administrateur | Flat 14,38 Queens Gate SW7 5JN London | American | 78240440004 | ||||||
| MALONEY, David Ossian | Administrateur | 64 Ledborough Lane HP9 2DG Beaconsfield Buckinghamshire | United Kingdom | British | 69071800002 | |||||
| MILLS, John Michael | Administrateur | 33 Peplins Way AL9 7UR Brookmans Park Hertfordshire | British | 42268710001 | ||||||
| RILEY, Robert Earl | Administrateur | 3 Montpelier Walk SW7 6TT London | United States Citizen | 95184480002 | ||||||
| SIMS, Roy John Peter | Administrateur | 6 Star Hill Drive Churt GU10 2HP Farnham Surrey | British | 12396130001 | ||||||
| SMALL, Jeremy Peter | Administrateur | Cherry Trees West Heath GU24 0JQ Pirbright Surrey | England | British | 67168210001 | |||||
| STEVENS, David John | Administrateur | 42 Burghley Road Wimbledon SW19 5HN London | British | 56704240001 | ||||||
| TAUTZ, Helen Jane | Administrateur | 30 South Crescent Prittlewell SS2 6TA Southend On Sea Essex | United Kingdom | British | 37564540001 | |||||
| FORTE (UK) LIMITED | Administrateur | 166 High Holborn WC1V 6TT London | 42204690001 |
EXCELSIOR HOTELS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Subordination agreement | Créé le 22 nov. 2005 Livré le 05 déc. 2005 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the borrower to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The company has undertaken to the chargee that if any obligor makes any payment in cash or in kind on account of, or for the purchase or other acquisition of, all or any part of the junior liabilities; or any junior creditor receives all or any amount in cash or in kind of the junior liabilities, in each case the junior creditors concerned shall hold the same upon trust for the security agent for aplication in or towards payment of all the senior liabilities,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage of shares | Créé le 15 avr. 2003 Livré le 01 mai 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All present and future obligations due or to become due from any obligor to the chargee (the "security agent") as agent and trustee for itself and each of the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All the shares and all related rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Portuguese public deed executed outside the UK and comprising of property situated there | Créé le 05 juil. 2002 Livré le 06 août 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from any obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The shares and the right to all dividends. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture between inter alia grand hotels (m) intermediate holding company I limited, the company and the other chargors named therein (the chargors) and cibc world markets PLC (the security agent) as agent and trustee for itself and each of the secured creditors | Créé le 11 juil. 2001 Livré le 26 juil. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti Any and all present and future obligations and liabilities of any obligor to the secured creditors (or any of them) under each or any of the senior finance documents, the senior mezzanine finance documents and the junior mezzanine finance documents (all terms as defined) | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 30 juil. 1931 Acquis le 29 sept. 1936 Livré le 20 oct. 1936 | Totalement satisfaite | Montant garanti £4,000 (owing) | |
Brèves mentions 7, the esplanade, scarborough. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage | Créé le 15 juin 1923 Acquis le 29 sept. 1936 Livré le 20 oct. 1936 | Totalement satisfaite | Montant garanti £15,000 (owing) | |
Brèves mentions The royal crescent hotel, filey and goodwill. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage | Créé le 15 juin 1923 Acquis le 29 sept. 1936 Livré le 20 oct. 1936 | Totalement satisfaite | Montant garanti £27000 (owing) | |
Brèves mentions The crown hotel, scarborough and goodwill. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
EXCELSIOR HOTELS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0