EXCELSIOR HOTELS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéEXCELSIOR HOTELS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00318898
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de EXCELSIOR HOTELS LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe EXCELSIOR HOTELS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Ship Canal House 8th Flooor
    98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de EXCELSIOR HOTELS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2006

    Quels sont les derniers dépôts pour EXCELSIOR HOTELS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    14 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 août 2021

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 févr. 2021

    5 pages4.68

    Changement d'adresse du siège social de Ship Canal House 8th Floor 98 King Street Manchester M2 4WB à Ship Canal House 8th Flooor 98 King Street Manchester M2 4WU le 11 nov. 2020

    2 pagesAD01

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 août 2020

    5 pages4.68

    Changement d'adresse du siège social de 5th Floor the Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB à Ship Canal House 8th Floor 98 King Street Manchester M2 4WB le 16 mars 2020

    2 pagesAD01

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 févr. 2020

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 août 2019

    5 pages4.68

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    4 pages600

    Démission d'un liquidateur

    3 pagesLIQ06

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 févr. 2019

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 août 2018

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 févr. 2018

    5 pages4.68

    Démission d'un liquidateur

    3 pagesLIQ06

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 août 2017

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 févr. 2017

    9 pages4.68

    Changement d'adresse du siège social de Zolfo Cooper Toronto Square Toronto Street Leeds West Yorkshire LS1 2HJ à 5th Floor the Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB le 01 sept. 2016

    6 pagesAD01

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 août 2016

    9 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 févr. 2016

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 août 2015

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 févr. 2015

    9 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 août 2014

    9 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 févr. 2014

    9 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 13 août 2013

    9 pages4.68

    Qui sont les dirigeants de EXCELSIOR HOTELS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    STARMAN SECRETARIES LIMITED
    Hesketh House
    43-45 Portman Square
    W1H 6HN London
    Secrétaire
    Hesketh House
    43-45 Portman Square
    W1H 6HN London
    98359920004
    CAMPBELL, Blair Patrick
    2
    120 Goldburst Terrace
    NW6 3HR London
    Administrateur
    2
    120 Goldburst Terrace
    NW6 3HR London
    United KingdomNew Zealander112856760002
    NIXON, Edward John
    Flat 2
    3 Copse Hill
    SW20 0NA Wimbledon
    London
    Administrateur
    Flat 2
    3 Copse Hill
    SW20 0NA Wimbledon
    London
    United KingdomBritish120665260001
    EDIS-BATES, Jonathan Geoffrey
    The Croft
    Chalfont Lane Chorleywood
    WD3 5PP Rickmansworth
    Hertfordshire
    Secrétaire
    The Croft
    Chalfont Lane Chorleywood
    WD3 5PP Rickmansworth
    Hertfordshire
    British49678170001
    FRASER, Simon Scott
    Foxtrot 1 Shey Copse
    GU22 8HS Woking
    Surrey
    Secrétaire
    Foxtrot 1 Shey Copse
    GU22 8HS Woking
    Surrey
    British39862810001
    MACKENZIE, Lisa Marie
    70 Vassall Road
    Kennington
    SW9 6HY London
    Secrétaire
    70 Vassall Road
    Kennington
    SW9 6HY London
    British78059700001
    MASON, Timothy Charles
    231 Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    Secrétaire
    231 Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    British12314170002
    MILLS, John Michael
    33 Peplins Way
    AL9 7UR Brookmans Park
    Hertfordshire
    Secrétaire
    33 Peplins Way
    AL9 7UR Brookmans Park
    Hertfordshire
    British42268710001
    SIMS, Roy John Peter
    6 Star Hill Drive
    Churt
    GU10 2HP Farnham
    Surrey
    Secrétaire
    6 Star Hill Drive
    Churt
    GU10 2HP Farnham
    Surrey
    British12396130001
    SMALL, Jeremy Peter
    Cherry Trees
    West Heath
    GU24 0JQ Pirbright
    Surrey
    Secrétaire
    Cherry Trees
    West Heath
    GU24 0JQ Pirbright
    Surrey
    British67168210001
    STEVENS, David John
    42 Burghley Road
    Wimbledon
    SW19 5HN London
    Secrétaire
    42 Burghley Road
    Wimbledon
    SW19 5HN London
    British56704240001
    TAUTZ, Helen Jane
    30 South Crescent
    Prittlewell
    SS2 6TA Southend On Sea
    Essex
    Secrétaire
    30 South Crescent
    Prittlewell
    SS2 6TA Southend On Sea
    Essex
    British37564540001
    FORTE NOMINEES LIMITED
    166 High Holborn
    WC1V 6TT London
    Secrétaire
    166 High Holborn
    WC1V 6TT London
    42198970001
    EDIS-BATES, Jonathan Geoffrey
    The Croft
    Chalfont Lane Chorleywood
    WD3 5PP Rickmansworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    The Croft
    Chalfont Lane Chorleywood
    WD3 5PP Rickmansworth
    Hertfordshire
    EnglandBritish49678170001
    ELTON, James Robert
    27 Elsie Road
    SE22 8DX London
    Administrateur
    27 Elsie Road
    SE22 8DX London
    United KingdomBritish55689440001
    FERGUSON, Iain Donald
    2 Chalet Close
    Shootersway Lane
    HP4 3NR Berkhamsted
    Hertfordshire
    Administrateur
    2 Chalet Close
    Shootersway Lane
    HP4 3NR Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritish10297860001
    FRASER, Simon Scott
    Foxtrot 1 Shey Copse
    GU22 8HS Woking
    Surrey
    Administrateur
    Foxtrot 1 Shey Copse
    GU22 8HS Woking
    Surrey
    British39862810001
    HILL, Nicholas Mark Lalor
    36 Hazlewell Road
    SW15 6LR London
    Administrateur
    36 Hazlewell Road
    SW15 6LR London
    United KingdomBritish76547250001
    KANDERS, Alan J
    Suite 2a
    500 West End Avenue
    YO23 7DE New York
    North Yorkshire
    United States
    Administrateur
    Suite 2a
    500 West End Avenue
    YO23 7DE New York
    North Yorkshire
    United States
    United States Citizen114506230001
    LAMBERT, Bernard Charles Hector
    Flat 10
    21-23 Palace Gate
    W8 5LS London
    Administrateur
    Flat 10
    21-23 Palace Gate
    W8 5LS London
    AustriaFrench60956020002
    LOVETT, Norman
    25 Balmoral Way
    Belmont
    Surrey
    Administrateur
    25 Balmoral Way
    Belmont
    Surrey
    British49941610001
    MACKENZIE, Lisa Marie
    70 Vassall Road
    Kennington
    SW9 6HY London
    Administrateur
    70 Vassall Road
    Kennington
    SW9 6HY London
    British78059700001
    MAHONEY, Richard Lee
    Flat 14,38 Queens Gate
    SW7 5JN London
    Administrateur
    Flat 14,38 Queens Gate
    SW7 5JN London
    American78240440004
    MALONEY, David Ossian
    64 Ledborough Lane
    HP9 2DG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    64 Ledborough Lane
    HP9 2DG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish69071800002
    MILLS, John Michael
    33 Peplins Way
    AL9 7UR Brookmans Park
    Hertfordshire
    Administrateur
    33 Peplins Way
    AL9 7UR Brookmans Park
    Hertfordshire
    British42268710001
    RILEY, Robert Earl
    3 Montpelier Walk
    SW7 6TT London
    Administrateur
    3 Montpelier Walk
    SW7 6TT London
    United States Citizen95184480002
    SIMS, Roy John Peter
    6 Star Hill Drive
    Churt
    GU10 2HP Farnham
    Surrey
    Administrateur
    6 Star Hill Drive
    Churt
    GU10 2HP Farnham
    Surrey
    British12396130001
    SMALL, Jeremy Peter
    Cherry Trees
    West Heath
    GU24 0JQ Pirbright
    Surrey
    Administrateur
    Cherry Trees
    West Heath
    GU24 0JQ Pirbright
    Surrey
    EnglandBritish67168210001
    STEVENS, David John
    42 Burghley Road
    Wimbledon
    SW19 5HN London
    Administrateur
    42 Burghley Road
    Wimbledon
    SW19 5HN London
    British56704240001
    TAUTZ, Helen Jane
    30 South Crescent
    Prittlewell
    SS2 6TA Southend On Sea
    Essex
    Administrateur
    30 South Crescent
    Prittlewell
    SS2 6TA Southend On Sea
    Essex
    United KingdomBritish37564540001
    FORTE (UK) LIMITED
    166 High Holborn
    WC1V 6TT London
    Administrateur
    166 High Holborn
    WC1V 6TT London
    42204690001

    EXCELSIOR HOTELS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Subordination agreement
    Créé le 22 nov. 2005
    Livré le 05 déc. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the borrower to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The company has undertaken to the chargee that if any obligor makes any payment in cash or in kind on account of, or for the purchase or other acquisition of, all or any part of the junior liabilities; or any junior creditor receives all or any amount in cash or in kind of the junior liabilities, in each case the junior creditors concerned shall hold the same upon trust for the security agent for aplication in or towards payment of all the senior liabilities,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank (Portugal) S.A.
    Transactions
    • 05 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage of shares
    Créé le 15 avr. 2003
    Livré le 01 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations due or to become due from any obligor to the chargee (the "security agent") as agent and trustee for itself and each of the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the shares and all related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Cibc World Markets PLC
    Transactions
    • 01 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 févr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Portuguese public deed executed outside the UK and comprising of property situated there
    Créé le 05 juil. 2002
    Livré le 06 août 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The shares and the right to all dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Cibc World Markets PLC (The Security Agent)
    Transactions
    • 06 août 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 févr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture between inter alia grand hotels (m) intermediate holding company I limited, the company and the other chargors named therein (the chargors) and cibc world markets PLC (the security agent) as agent and trustee for itself and each of the secured creditors
    Créé le 11 juil. 2001
    Livré le 26 juil. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Any and all present and future obligations and liabilities of any obligor to the secured creditors (or any of them) under each or any of the senior finance documents, the senior mezzanine finance documents and the junior mezzanine finance documents (all terms as defined)
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Cibc World Markets PLC
    Transactions
    • 26 juil. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 févr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A registered charge
    Créé le 30 juil. 1931
    Acquis le 29 sept. 1936
    Livré le 20 oct. 1936
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £4,000 (owing)
    Brèves mentions
    7, the esplanade, scarborough.
    Personnes ayant droit
    • B.E. Ross.
    • W.M. Walker
    • A.D. Walker
    Transactions
    • 20 oct. 1936Enregistrement d'une charge
    • 22 juin 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 15 juin 1923
    Acquis le 29 sept. 1936
    Livré le 20 oct. 1936
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £15,000 (owing)
    Brèves mentions
    The royal crescent hotel, filey and goodwill.
    Personnes ayant droit
    • A.D. Walker.
    • W.M. Walker
    • B.E. Ross.
    Transactions
    • 20 oct. 1936Enregistrement d'une charge
    • 22 juin 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 15 juin 1923
    Acquis le 29 sept. 1936
    Livré le 20 oct. 1936
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £27000 (owing)
    Brèves mentions
    The crown hotel, scarborough and goodwill.
    Personnes ayant droit
    • W.M. Walker
    • B.E. Ross.
    • A.D. Walker
    Transactions
    • 20 oct. 1936Enregistrement d'une charge
    • 22 juin 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    EXCELSIOR HOTELS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    16 mars 2022Due to be dissolved on
    14 févr. 2008Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Charles Peter Holder
    Kroll Limited
    Wellington Plaza
    LS1 4DL 31 Wellington Street
    Leeds
    practitioner
    Kroll Limited
    Wellington Plaza
    LS1 4DL 31 Wellington Street
    Leeds
    Stuart Charles Edward Mackellar
    Wellington Plaza 31 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    practitioner
    Wellington Plaza 31 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Alastair Paul Beveridge
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    practitioner
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Catherine Williamson
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    United Kingdom
    practitioner
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    United Kingdom

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0