CLAREMONT GARMENTS (HOLDINGS) LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | CLAREMONT GARMENTS (HOLDINGS) LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Active |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00320013 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CLAREMONT GARMENTS (HOLDINGS) LIMITED ?
Adresse du siège social | The Courtaulds Building 292 Haydn Road NG5 1EB Nottingham England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CLAREMONT GARMENTS (HOLDINGS) LIMITED ?
En retard | Non |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 30 juin 2024 |
Date d'échéance des prochains comptes | 31 mars 2025 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2023 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour CLAREMONT GARMENTS (HOLDINGS) LIMITED ?
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 15 juin 2025 |
---|---|
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 29 juin 2025 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 15 juin 2024 |
En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour CLAREMONT GARMENTS (HOLDINGS) LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |
---|---|---|---|---|
Déclaration de confirmation établie le 15 juin 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Roger Ian Harry Broadberry en tant que secrétaire le 08 mai 2024 | 1 pages | TM02 | ||
Cessation de la nomination de Roger Ian Harry Broadberry en tant que directeur le 08 mai 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2023 | 7 pages | AA | ||
Nomination de Mr Roger Ian Harry Broadberry en tant qu'administrateur le 02 août 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Roger Ian Harry Broadberry en tant que secrétaire le 02 août 2023 | 2 pages | AP03 | ||
Cessation de la nomination de Roger Ian Harry Broadberry en tant que secrétaire le 12 juil. 2023 | 1 pages | TM02 | ||
Cessation de la nomination de Roger Ian Harry Broadberry en tant que directeur le 12 juil. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 15 juin 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2022 | 7 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 15 juin 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2021 | 7 pages | AA | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2020 | 6 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 15 juin 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 15 juin 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2019 | 7 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 15 juin 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2018 | 7 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 15 juin 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2017 | 7 pages | AA | ||
Notification de Huit Holdings (Uk) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016 | 2 pages | PSC02 | ||
Déclaration de confirmation établie le 15 juin 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2016 | 7 pages | AA | ||
Nomination de Mr Roger Ian Harry Broadberry en tant que secrétaire le 01 nov. 2016 | 2 pages | AP03 | ||
Cessation de la nomination de Huit Holdings (Uk) Limited en tant que secrétaire le 31 oct. 2016 | 1 pages | TM02 | ||
Qui sont les dirigeants de CLAREMONT GARMENTS (HOLDINGS) LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUIT HOLDINGS (UK) LIMITED | Administrateur | 292 Haydn Road NG5 1EB Nottingham The Courtaulds Building Nottinghamshire United Kingdom |
| 136235800001 | ||||||||||
BROADBERRY, Roger Ian Harry | Secrétaire | 292 Haydn Road NG5 1EB Nottingham The Courtaulds Building England | 312009970001 | |||||||||||
BROADBERRY, Roger Ian Harry | Secrétaire | 292 Haydn Road NG5 1EB Nottingham The Courtaulds Building England | 217559920001 | |||||||||||
CATTERMOLE, Carolyn Tracy | Secrétaire | 81 Cranbrook Road Chiswick W4 2LJ London | British | 53026290001 | ||||||||||
CLARKE, Melanie Anne | Secrétaire | 21 Bankside Close CV3 4GD Coventry West Midlands | British | Chartered Secretary | 68681710001 | |||||||||
DRING, Susan Mary | Secrétaire | 1 Ferens Close The Sands DH1 1JX Durham Co Durham | British | 27228120002 | ||||||||||
JAGUN, Ayotola | Secrétaire | 4e Bassett Road W10 6JJ London | British | Chartered Secretary | 77729230001 | |||||||||
KELLY, Susan Kathleen | Secrétaire | 43 Southview Clifton Road SW19 4QU London | British | Chartered Secretary | 71087960003 | |||||||||
MCWILLIAMS, Michael Joseph | Secrétaire | Scotland Head House Winlaton NE21 6PL Blaydon Tyne And Wear | British | 38800080001 | ||||||||||
RUBENSTEIN, Howard Justin | Secrétaire | 10 Cyprus Avenue Finchley N3 1ST London | British | Company Secretary And Legal Co | 66642870003 | |||||||||
RUSS, Neil Andrew | Secrétaire | Archdale House 87 Wanlip Road LE7 1PB Syston Leicestershire | British | Financial Controller | 118426120001 | |||||||||
WILSON, Julia Ruth | Secrétaire | 5 Northwood Rise DE6 1BF Ashbourne Derbyshire | British | Financial Controller | 73543180001 | |||||||||
HUIT HOLDINGS (UK) LIMITED | Secrétaire | 292 Haydn Road NG5 1EB Nottingham The Courtaulds Building Nottinghamshire United Kingdom |
| 136235800001 | ||||||||||
BROADBERRY, Roger Ian Harry | Administrateur | 292 Haydn Road NG5 1EB Nottingham The Courtaulds Building England | England | British | Group Financial Accountant | 126443750002 | ||||||||
BROADBERRY, Roger Ian Harry | Administrateur | 292 Haydn Road NG5 1EB Nottingham The Courtaulds Building England | England | British | Financial Accountant | 126443750002 | ||||||||
CATTERMOLE, Carolyn Tracy | Administrateur | 81 Cranbrook Road Chiswick W4 2LJ London | British | Solicitor | 53026290001 | |||||||||
CLARKE, Melanie Anne | Administrateur | 21 Bankside Close CV3 4GD Coventry West Midlands | British | Chartered Secretary | 68681710001 | |||||||||
DONNELLY, David John, Mr. | Administrateur | 292 Haydn Road NG5 1EB Nottingham The Courtaulds Building England | Scotland | British | None | 110847310002 | ||||||||
DUFFY, Hugh Brian | Administrateur | Highwood Woodland Drive KT24 5AN East Horsley Surrey | British | Chief Executive | 91979290001 | |||||||||
ELLIS, Michael | Administrateur | 3 The Paddocks Peasehill DE5 3QR Ripley Derbyshire | United Kingdom | British | Finance Director | 82849150002 | ||||||||
ENDERS, Bruce | Administrateur | 44 Grange Road Chiswick W4 4DD London | American | Director | 55128440004 | |||||||||
GILLIATT, John Mowbray | Administrateur | 9 Banbury Road CV37 7HN Stratford Upon Avon Warwickshire | Scotland | British | Management Consultant | 169894800001 | ||||||||
HAMILTON, Nicholas Ian | Administrateur | South Hill House Smiths Lane, Ditcheat BA4 6PP Shepton Mallet Somerset | British | Director | 65558940001 | |||||||||
HANDLEY, Helen Kay | Administrateur | 6 Daniels Lane CR6 9ET Warlingham Surrey | British | Solicitor | 109816110001 | |||||||||
HANKINSON, David Roger Lindon | Administrateur | The Brambles Loudwater Lane WD3 4HY Rickmansworth Hertfordshire | British | Company Director | 34175410001 | |||||||||
JAGUN, Ayotola | Administrateur | 4e Bassett Road W10 6JJ London | British | Chartered Secretary | 77729230001 | |||||||||
JENKINS, Stephen Adrian | Administrateur | Mill Farm House Barkston Road Marston NG32 2HN Grantham Lincolnshire | British | Chartered Accountant | 49738660002 | |||||||||
KELLY, Susan Kathleen | Administrateur | 43 Southview Clifton Road SW19 4QU London | England | British | Chartered Secretary | 71087960003 | ||||||||
LLEWELLYN, Stephen Michael | Administrateur | Portman Close W1H 6BS London 22-25 England | United Kingdom | British | Chief Executive Officer | 146726750001 | ||||||||
MCGARVEY, David | Administrateur | 3 Loudwater Ridge Loudwater WD3 4AR Rickmansworth Hertfordshire | British | Director | 9220530004 | |||||||||
MCWILLIAMS, Michael Joseph | Administrateur | Scotland Head House Winlaton NE21 6PL Blaydon Tyne And Wear | British | Accountant | 38800080001 | |||||||||
MOODY, Michael John | Administrateur | 106 Providence Square Jacobs Island SE1 2EA London | British | Managing Director | 77698880002 | |||||||||
PITSILLOS, Marios | Administrateur | 17 Meadowsweet Hill Bingham NG13 8TS Nottingham Nottinghamshire | British | Chartered Accountant | 64722090002 | |||||||||
POLEG, Eliaz | Administrateur | 20 Tedworth Square SW3 4DY London | French And Israeli | Ceo | 82549490001 | |||||||||
PRICE, David | Administrateur | The Dower House Woodlands Hall Knitsley DH8 9EY Consett County Durham | British | Technical Director | 68001150001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CLAREMONT GARMENTS (HOLDINGS) LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huit Holdings (Uk) Limited | 06 avr. 2016 | 292 Haydn Road NG5 1EB Nottingham The Courtaulds Building Nottinghamshire United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
CLAREMONT GARMENTS (HOLDINGS) LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 13 juin 1997 Livré le 19 juin 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge over securities | Créé le 07 janv. 1993 Livré le 15 janv. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions By way of fixed first charge all stocks shares bonds and securities of any kind whatsoever (see relevant form 395 for full details). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Share charge | Créé le 07 janv. 1993 Livré le 15 janv. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this charge. | |
Brèves mentions As a first charge:-(1) all the issued share capital of claremont garments limited (2)all dividends,distributions and other income paid or payable on or derived from the securities. (See relevant form 395 for full details). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 06 juil. 1992 Livré le 21 juil. 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a sterling guarantee facility letter dated 18 june 1992 and this charge. | |
Brèves mentions See relevant form 395 for full details.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 22 juil. 1991 Livré le 31 juil. 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions (See form 395 document m 366C for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 22 juil. 1991 Livré le 24 juil. 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Letter of offset | Créé le 22 juil. 1991 Livré le 24 juil. 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and dee m cohen limited | |
Brèves mentions All sums which are now or which may at any time hereafter be at the credit of any account or accounts in the books of the bank of scotland in the name of the company (see 395 for details). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage of deposited monies | Créé le 10 avr. 1990 Livré le 27 avr. 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 1/7/69 | |
Brèves mentions A book debt in the sum of £521,250 owing by midland bank PLC to ellis & goldstein (holdings) PLC together with all interest thereon being the amount standing to the credit of ellis & goldstein (holdings) PLC in an account with the midland bank PLC known as ellis & goldstein (holdings) PLC security deposit account or such other sum as shall for the time being be standing to the credit of the said account. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed | Créé le 30 janv. 1979 Livré le 16 févr. 1979 | Totalement satisfaite | Montant garanti For further securing £ 500000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under terms of a debenture dated 1-7-1969 | |
Brèves mentions A) £ 54065.47 of 6% funding loan 1993 b) land lying to the west of norham rd.north,north shields tyne & wear t/nos.TY49850 & TY36279. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 25 juin 1974 Livré le 01 juil. 1974 | Totalement satisfaite | Montant garanti For further securing all monies due or to become due from the company to the chargee secured by a debenture dated 1ST july 1969. | |
Brèves mentions F/H land approx 29 sq meters situate on the west chirton industrial estate, tynemouth northumberland and being part of the track leading to north backwell farm. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 01 juil. 1969 Livré le 11 juil. 1969 | Totalement satisfaite | Montant garanti For securing all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 1 july 1969. | |
Brèves mentions 23-27 (odd) spalding street and land and building on east side of spalding street leicester. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 01 juil. 1969 Livré le 11 juil. 1969 | Totalement satisfaite | Montant garanti For securing all incomes due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 12 july 1969. | |
Brèves mentions Land & buildings on N.E. side of dane road hargate kent. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 01 juil. 1969 Livré le 11 juil. 1969 | Totalement satisfaite | Montant garanti For securing all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 1 july 1969 | |
Brèves mentions Dumarsel house west chirton factory estate north shields. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 01 juil. 1969 Livré le 11 juil. 1969 | Totalement satisfaite | Montant garanti For securing all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 1 july 1969. | |
Brèves mentions 40/48 guildford street ruton. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0