CLAREMONT GARMENTS (HOLDINGS) LIMITED

CLAREMONT GARMENTS (HOLDINGS) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCLAREMONT GARMENTS (HOLDINGS) LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00320013
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CLAREMONT GARMENTS (HOLDINGS) LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe CLAREMONT GARMENTS (HOLDINGS) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Courtaulds Building
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CLAREMONT GARMENTS (HOLDINGS) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CLAREMONT GARMENTS LIMITED01 mars 199101 mars 1991
    ELLIS & GOLDSTEIN (HOLDINGS) PLC27 oct. 193627 oct. 1936

    Quels sont les derniers comptes de CLAREMONT GARMENTS (HOLDINGS) LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le30 juin 2024
    Date d'échéance des prochains comptes31 mars 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour CLAREMONT GARMENTS (HOLDINGS) LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au15 juin 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation29 juin 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au15 juin 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour CLAREMONT GARMENTS (HOLDINGS) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de confirmation établie le 15 juin 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    XD5QB4Q8

    Cessation de la nomination de Roger Ian Harry Broadberry en tant que secrétaire le 08 mai 2024

    1 pagesTM02
    XD3MYV7T

    Cessation de la nomination de Roger Ian Harry Broadberry en tant que directeur le 08 mai 2024

    1 pagesTM01
    XD3MYU6Y

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2023

    7 pagesAA
    ACZNPHRU

    Nomination de Mr Roger Ian Harry Broadberry en tant qu'administrateur le 02 août 2023

    2 pagesAP01
    XC94XMAQ

    Nomination de Mr Roger Ian Harry Broadberry en tant que secrétaire le 02 août 2023

    2 pagesAP03
    XC94X4UJ

    Cessation de la nomination de Roger Ian Harry Broadberry en tant que secrétaire le 12 juil. 2023

    1 pagesTM02
    XC7PLKXN

    Cessation de la nomination de Roger Ian Harry Broadberry en tant que directeur le 12 juil. 2023

    1 pagesTM01
    XC7PLKF6

    Déclaration de confirmation établie le 15 juin 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    XC71LTIP

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2022

    7 pagesAA
    AC0EQ6GJ

    Déclaration de confirmation établie le 15 juin 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    XB6NE8OH

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2021

    7 pagesAA
    AB0YGP2R

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2020

    6 pagesAA
    AA7RTBTD

    Déclaration de confirmation établie le 15 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    XA7L18BS

    Déclaration de confirmation établie le 15 juin 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X982PS2A

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2019

    7 pagesAA
    A91VSEVF

    Déclaration de confirmation établie le 15 juin 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X88BFO4J

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2018

    7 pagesAA
    A829O2ZT

    Déclaration de confirmation établie le 15 juin 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X78CBVJV

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2017

    7 pagesAA
    A72RXCJ7

    Notification de Huit Holdings (Uk) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    2 pagesPSC02
    X69G516X

    Déclaration de confirmation établie le 15 juin 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01
    X69G5CAY

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2016

    7 pagesAA
    A63CCDX6

    Nomination de Mr Roger Ian Harry Broadberry en tant que secrétaire le 01 nov. 2016

    2 pagesAP03
    X5IV3S09

    Cessation de la nomination de Huit Holdings (Uk) Limited en tant que secrétaire le 31 oct. 2016

    1 pagesTM02
    X5IV3R9L

    Qui sont les dirigeants de CLAREMONT GARMENTS (HOLDINGS) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HUIT HOLDINGS (UK) LIMITED
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    The Courtaulds Building
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    The Courtaulds Building
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement5785822
    136235800001
    BROADBERRY, Roger Ian Harry
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    The Courtaulds Building
    England
    Secrétaire
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    The Courtaulds Building
    England
    312009970001
    BROADBERRY, Roger Ian Harry
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    The Courtaulds Building
    England
    Secrétaire
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    The Courtaulds Building
    England
    217559920001
    CATTERMOLE, Carolyn Tracy
    81 Cranbrook Road
    Chiswick
    W4 2LJ London
    Secrétaire
    81 Cranbrook Road
    Chiswick
    W4 2LJ London
    British53026290001
    CLARKE, Melanie Anne
    21 Bankside Close
    CV3 4GD Coventry
    West Midlands
    Secrétaire
    21 Bankside Close
    CV3 4GD Coventry
    West Midlands
    BritishChartered Secretary68681710001
    DRING, Susan Mary
    1 Ferens Close
    The Sands
    DH1 1JX Durham
    Co Durham
    Secrétaire
    1 Ferens Close
    The Sands
    DH1 1JX Durham
    Co Durham
    British27228120002
    JAGUN, Ayotola
    4e Bassett Road
    W10 6JJ London
    Secrétaire
    4e Bassett Road
    W10 6JJ London
    BritishChartered Secretary77729230001
    KELLY, Susan Kathleen
    43 Southview
    Clifton Road
    SW19 4QU London
    Secrétaire
    43 Southview
    Clifton Road
    SW19 4QU London
    BritishChartered Secretary71087960003
    MCWILLIAMS, Michael Joseph
    Scotland Head House
    Winlaton
    NE21 6PL Blaydon
    Tyne And Wear
    Secrétaire
    Scotland Head House
    Winlaton
    NE21 6PL Blaydon
    Tyne And Wear
    British38800080001
    RUBENSTEIN, Howard Justin
    10 Cyprus Avenue
    Finchley
    N3 1ST London
    Secrétaire
    10 Cyprus Avenue
    Finchley
    N3 1ST London
    BritishCompany Secretary And Legal Co66642870003
    RUSS, Neil Andrew
    Archdale House
    87 Wanlip Road
    LE7 1PB Syston
    Leicestershire
    Secrétaire
    Archdale House
    87 Wanlip Road
    LE7 1PB Syston
    Leicestershire
    BritishFinancial Controller118426120001
    WILSON, Julia Ruth
    5 Northwood Rise
    DE6 1BF Ashbourne
    Derbyshire
    Secrétaire
    5 Northwood Rise
    DE6 1BF Ashbourne
    Derbyshire
    BritishFinancial Controller73543180001
    HUIT HOLDINGS (UK) LIMITED
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    The Courtaulds Building
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    The Courtaulds Building
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement5785822
    136235800001
    BROADBERRY, Roger Ian Harry
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    The Courtaulds Building
    England
    Administrateur
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    The Courtaulds Building
    England
    EnglandBritishGroup Financial Accountant126443750002
    BROADBERRY, Roger Ian Harry
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    The Courtaulds Building
    England
    Administrateur
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    The Courtaulds Building
    England
    EnglandBritishFinancial Accountant126443750002
    CATTERMOLE, Carolyn Tracy
    81 Cranbrook Road
    Chiswick
    W4 2LJ London
    Administrateur
    81 Cranbrook Road
    Chiswick
    W4 2LJ London
    BritishSolicitor53026290001
    CLARKE, Melanie Anne
    21 Bankside Close
    CV3 4GD Coventry
    West Midlands
    Administrateur
    21 Bankside Close
    CV3 4GD Coventry
    West Midlands
    BritishChartered Secretary68681710001
    DONNELLY, David John, Mr.
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    The Courtaulds Building
    England
    Administrateur
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    The Courtaulds Building
    England
    ScotlandBritishNone110847310002
    DUFFY, Hugh Brian
    Highwood
    Woodland Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    Administrateur
    Highwood
    Woodland Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    BritishChief Executive91979290001
    ELLIS, Michael
    3 The Paddocks
    Peasehill
    DE5 3QR Ripley
    Derbyshire
    Administrateur
    3 The Paddocks
    Peasehill
    DE5 3QR Ripley
    Derbyshire
    United KingdomBritishFinance Director82849150002
    ENDERS, Bruce
    44 Grange Road
    Chiswick
    W4 4DD London
    Administrateur
    44 Grange Road
    Chiswick
    W4 4DD London
    AmericanDirector55128440004
    GILLIATT, John Mowbray
    9 Banbury Road
    CV37 7HN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Administrateur
    9 Banbury Road
    CV37 7HN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    ScotlandBritishManagement Consultant169894800001
    HAMILTON, Nicholas Ian
    South Hill House
    Smiths Lane, Ditcheat
    BA4 6PP Shepton Mallet
    Somerset
    Administrateur
    South Hill House
    Smiths Lane, Ditcheat
    BA4 6PP Shepton Mallet
    Somerset
    BritishDirector65558940001
    HANDLEY, Helen Kay
    6 Daniels Lane
    CR6 9ET Warlingham
    Surrey
    Administrateur
    6 Daniels Lane
    CR6 9ET Warlingham
    Surrey
    BritishSolicitor109816110001
    HANKINSON, David Roger Lindon
    The Brambles Loudwater Lane
    WD3 4HY Rickmansworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    The Brambles Loudwater Lane
    WD3 4HY Rickmansworth
    Hertfordshire
    BritishCompany Director34175410001
    JAGUN, Ayotola
    4e Bassett Road
    W10 6JJ London
    Administrateur
    4e Bassett Road
    W10 6JJ London
    BritishChartered Secretary77729230001
    JENKINS, Stephen Adrian
    Mill Farm House Barkston Road
    Marston
    NG32 2HN Grantham
    Lincolnshire
    Administrateur
    Mill Farm House Barkston Road
    Marston
    NG32 2HN Grantham
    Lincolnshire
    BritishChartered Accountant49738660002
    KELLY, Susan Kathleen
    43 Southview
    Clifton Road
    SW19 4QU London
    Administrateur
    43 Southview
    Clifton Road
    SW19 4QU London
    EnglandBritishChartered Secretary71087960003
    LLEWELLYN, Stephen Michael
    Portman Close
    W1H 6BS London
    22-25
    England
    Administrateur
    Portman Close
    W1H 6BS London
    22-25
    England
    United KingdomBritishChief Executive Officer146726750001
    MCGARVEY, David
    3 Loudwater Ridge
    Loudwater
    WD3 4AR Rickmansworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    3 Loudwater Ridge
    Loudwater
    WD3 4AR Rickmansworth
    Hertfordshire
    BritishDirector9220530004
    MCWILLIAMS, Michael Joseph
    Scotland Head House
    Winlaton
    NE21 6PL Blaydon
    Tyne And Wear
    Administrateur
    Scotland Head House
    Winlaton
    NE21 6PL Blaydon
    Tyne And Wear
    BritishAccountant38800080001
    MOODY, Michael John
    106 Providence Square
    Jacobs Island
    SE1 2EA London
    Administrateur
    106 Providence Square
    Jacobs Island
    SE1 2EA London
    BritishManaging Director77698880002
    PITSILLOS, Marios
    17 Meadowsweet Hill
    Bingham
    NG13 8TS Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    17 Meadowsweet Hill
    Bingham
    NG13 8TS Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishChartered Accountant64722090002
    POLEG, Eliaz
    20 Tedworth Square
    SW3 4DY London
    Administrateur
    20 Tedworth Square
    SW3 4DY London
    French And IsraeliCeo82549490001
    PRICE, David
    The Dower House
    Woodlands Hall Knitsley
    DH8 9EY Consett
    County Durham
    Administrateur
    The Dower House
    Woodlands Hall Knitsley
    DH8 9EY Consett
    County Durham
    BritishTechnical Director68001150001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CLAREMONT GARMENTS (HOLDINGS) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    The Courtaulds Building
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    292 Haydn Road
    NG5 1EB Nottingham
    The Courtaulds Building
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleEngland
    Lieu d'enregistrementUnited Kingdom
    Numéro d'enregistrement05785822
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    CLAREMONT GARMENTS (HOLDINGS) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 13 juin 1997
    Livré le 19 juin 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 juin 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over securities
    Créé le 07 janv. 1993
    Livré le 15 janv. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of fixed first charge all stocks shares bonds and securities of any kind whatsoever (see relevant form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 janv. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Share charge
    Créé le 07 janv. 1993
    Livré le 15 janv. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this charge.
    Brèves mentions
    As a first charge:-(1) all the issued share capital of claremont garments limited (2)all dividends,distributions and other income paid or payable on or derived from the securities. (See relevant form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • N.M.Rothschild Limited
    Transactions
    • 15 janv. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 06 juil. 1992
    Livré le 21 juil. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a sterling guarantee facility letter dated 18 june 1992 and this charge.
    Brèves mentions
    See relevant form 395 for full details.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • N.M Rothschild & Sons Limited
    Transactions
    • 21 juil. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A registered charge
    Créé le 22 juil. 1991
    Livré le 31 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (See form 395 document m 366C for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 31 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 01 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 22 juil. 1991
    Livré le 24 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 24 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 01 avr. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of offset
    Créé le 22 juil. 1991
    Livré le 24 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and dee m cohen limited
    Brèves mentions
    All sums which are now or which may at any time hereafter be at the credit of any account or accounts in the books of the bank of scotland in the name of the company (see 395 for details).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 24 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 11 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage of deposited monies
    Créé le 10 avr. 1990
    Livré le 27 avr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 1/7/69
    Brèves mentions
    A book debt in the sum of £521,250 owing by midland bank PLC to ellis & goldstein (holdings) PLC together with all interest thereon being the amount standing to the credit of ellis & goldstein (holdings) PLC in an account with the midland bank PLC known as ellis & goldstein (holdings) PLC security deposit account or such other sum as shall for the time being be standing to the credit of the said account.
    Personnes ayant droit
    • Hill Samuel Life Assurance Limited
    Transactions
    • 27 avr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 18 août 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed
    Créé le 30 janv. 1979
    Livré le 16 févr. 1979
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For further securing £ 500000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under terms of a debenture dated 1-7-1969
    Brèves mentions
    A) £ 54065.47 of 6% funding loan 1993 b) land lying to the west of norham rd.north,north shields tyne & wear t/nos.TY49850 & TY36279.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 16 févr. 1979Enregistrement d'une charge
    • 25 juil. 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 25 juin 1974
    Livré le 01 juil. 1974
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For further securing all monies due or to become due from the company to the chargee secured by a debenture dated 1ST july 1969.
    Brèves mentions
    F/H land approx 29 sq meters situate on the west chirton industrial estate, tynemouth northumberland and being part of the track leading to north backwell farm.
    Personnes ayant droit
    • Hill Samuel Life Assurance Limited
    Transactions
    • 01 juil. 1974Enregistrement d'une charge
    • 25 juil. 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 juil. 1969
    Livré le 11 juil. 1969
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For securing all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 1 july 1969.
    Brèves mentions
    23-27 (odd) spalding street and land and building on east side of spalding street leicester.
    Personnes ayant droit
    • Nolle Lowndes Annutities Limited
    Transactions
    • 11 juil. 1969Enregistrement d'une charge
    • 25 juil. 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 juil. 1969
    Livré le 11 juil. 1969
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For securing all incomes due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 12 july 1969.
    Brèves mentions
    Land & buildings on N.E. side of dane road hargate kent.
    Personnes ayant droit
    • Nolle Lowndes Annutities Limited
    Transactions
    • 11 juil. 1969Enregistrement d'une charge
    • 25 juil. 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 juil. 1969
    Livré le 11 juil. 1969
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For securing all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 1 july 1969
    Brèves mentions
    Dumarsel house west chirton factory estate north shields.
    Personnes ayant droit
    • Nolle Lowndes Annuities Limited
    Transactions
    • 11 juil. 1969Enregistrement d'une charge
    • 25 juil. 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 juil. 1969
    Livré le 11 juil. 1969
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For securing all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a debenture dated 1 july 1969.
    Brèves mentions
    40/48 guildford street ruton.
    Personnes ayant droit
    • Nolle Lowndes Annuities Limited
    Transactions
    • 11 juil. 1969Enregistrement d'une charge
    • 25 juil. 1991Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0