NBP DEVELOPMENTS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | NBP DEVELOPMENTS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00322509 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe NBP DEVELOPMENTS LIMITED ?
| Adresse du siège social | 30 Finsbury Square EC2P 2YU London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de NBP DEVELOPMENTS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2015 |
Quels sont les derniers dépôts pour NBP DEVELOPMENTS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 9 pages | LIQ13 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de No 1 Dorset Street Southampton Hampshire SO15 2DP à 30 Finsbury Square London EC2P 2YU le 04 mai 2017 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Pixham End Dorking Surrey RH4 1QA à No 1 Dorset Street Southampton Hampshire SO15 2DP le 03 janv. 2017 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 3 pages | 4.70 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 2 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Mr David Rowley Rose en tant qu'administrateur le 14 nov. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Pierre Alain Biscay en tant que directeur le 14 nov. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Graham Stephen Long en tant que directeur le 14 nov. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Steven Blackwell en tant que directeur le 14 nov. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Clair Louise Marshall en tant qu'administrateur le 14 nov. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 3 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 1 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015 | 6 pages | AA | ||||||||||
État du capital au 30 sept. 2016
| 3 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Yang Song en tant que directeur le 23 oct. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr David Steven Blackwell en tant qu'administrateur le 23 oct. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Graham Stephen Long en tant qu'administrateur le 16 sept. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Robert Groves en tant que directeur le 21 août 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Secretariat Friends Life 2nd Floor, One New Change London England EC4M 9EF England à St Helen's 1 Undershaft London EC3P 3DQ | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de NBP DEVELOPMENTS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRIENDS LIFE SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire | Pixham End RH4 1QA Dorking Surrey |
| 154737640001 | ||||||||||
| MARSHALL, Clair Louise | Administrateur | YO90 1WR York Wellington Row United Kingdom | United Kingdom | British | 200178890001 | |||||||||
| ROSE, David Rowley | Administrateur | 1 Undershaft EC3P 3DQ London St Helen's United Kingdom | United Kingdom | British | 89567200001 | |||||||||
| DRISCOLL, Caroline Mary | Secrétaire | Flat 3, 16 Kidbrooke Grove Blackheath SE3 0LF London | British | 35886380001 | ||||||||||
| HERBERT, Anthony James | Secrétaire | 21 Tite Street SW3 4JT London | British | 29028830004 | ||||||||||
| RICHARDSON, Ian David Lea | Secrétaire | Gatehouse Farm Dinedor SE1 3RF Hereford | British | 73820300001 | ||||||||||
| SMALL, Jeremy Peter | Secrétaire | Pixham End RH4 1QA Dorking Surrey | British | 67168210001 | ||||||||||
| WALLWORK, Janet Irwin | Secrétaire | 18 Blenheim Gardens KT2 7BW Kingston Upon Thames Surrey | British | 32917080003 | ||||||||||
| WEBSTER, John Dudley | Secrétaire | 10 Merrydown Way BR7 5RS Chislehurst Kent | British | 457110001 | ||||||||||
| AWFORD, Robert Francis | Administrateur | Pixham End RH4 1QA Dorking Surrey | United Kingdom | British | 89525200002 | |||||||||
| BISCAY, Pierre Alain | Administrateur | Pixham End RH4 1QA Dorking Surrey | United Kingdom | French | 191345190001 | |||||||||
| BLACKWELL, David Steven | Administrateur | EC2R 8EJ London No. 1 Poultry United Kingdom | United Kingdom | British | 202271880001 | |||||||||
| FAULKNER, Anthony | Administrateur | 7 Weston Close Upton Grey RG25 2RX Basingstoke Hampshire | British | 457090001 | ||||||||||
| GALLOWAY, Richard William | Administrateur | Shandon Dormans Park RH19 2NQ East Grinstead West Sussex | British | 8013540002 | ||||||||||
| GROVES, Robert | Administrateur | Pixham End RH4 1QA Dorking Surrey | United Kingdom | British | 191386770001 | |||||||||
| KIPLING, Michael Robert | Administrateur | Pixham End RH4 1QA Dorking Surrey | England | British | 89585620002 | |||||||||
| LONG, Graham Stephen | Administrateur | Pixham End RH4 1QA Dorking Surrey | United Kingdom | British | 201016770001 | |||||||||
| NICHOLLS, John Michael | Administrateur | 25 Starling Lane Cuffley EN6 4JX Potters Bar Hertfordshire | England | United Kingdom | 457100001 | |||||||||
| PARRIS, Stephen Michael | Administrateur | 81 Wentworth Drive MK41 8QD Bedford Bedfordshire | England | British | 28404670001 | |||||||||
| PINNOCK, Richard Mark | Administrateur | 16 Chaucer Road MK40 2AJ Bedford Bedfordshire | British | 100959840001 | ||||||||||
| SMITH, Stephen Paul | Administrateur | Yester Road BR7 5HN Chislehurst 65 Kent | England | British | 148183670001 | |||||||||
| SONG, Yang | Administrateur | Pixham End RH4 1QA Dorking Surrey | United Kingdom | British | 191346160001 | |||||||||
| TAN, Jin-Wee | Administrateur | Pixham End RH4 1QA Dorking Surrey | United Kingdom | British | 155013280001 | |||||||||
| VERSEY, Mark Richard Beavis | Administrateur | Pixham End RH4 1QA Dorking Surrey | United Kingdom | British | 154710020001 | |||||||||
| WEBSTER, John Dudley | Administrateur | 10 Merrydown Way BR7 5RS Chislehurst Kent | British | 457110001 | ||||||||||
| YATES, Stephen Richard | Administrateur | Pixham End RH4 1QA Dorking Surrey | British | 44988640001 | ||||||||||
| YATES, Stephen Richard | Administrateur | 37 Colebrooke Avenue W13 8JZ London | British | 44988640001 |
NBP DEVELOPMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Créé le 28 juil. 1983 Livré le 05 août 1983 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H land founded by maylands avenue hemel hempstead hertfordshire. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 28 juil. 1983 Livré le 05 août 1983 | Totalement satisfaite | Montant garanti Sterling pounds 1,250,000 | |
Brèves mentions F/H land bounded by maylands avenue on the westerley boundary, maxted road, on the northerly boundary, maxted close on the easterly boundary and land beloning to hodale limited on the southerly boundary hemel hempstead, herts. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security which was presented for registration at the register of sasines on 21/1/82 | Créé le 21 janv. 1982 Livré le 09 févr. 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 116 dundas st edinburgh scotland. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
NBP DEVELOPMENTS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0