KELLER DORMANT LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | KELLER DORMANT LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00323483 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe KELLER DORMANT LIMITED ?
| Adresse du siège social | Keller Limited Oxford Road Ryton On Dunsmore CV8 3EG Coventry |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de KELLER DORMANT LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2019 |
Quels sont les derniers dépôts pour KELLER DORMANT LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 3 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 23 nov. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019 | 7 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Robert Malcolm Thompson en tant qu'administrateur le 13 févr. 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Joseph Christopher Hubback en tant que directeur le 13 févr. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 26 nov. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes modifiés pour une société dormante jusqu'au 31 déc. 2018 | 7 pages | AAMD | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018 | 2 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr William Marston Reid en tant qu'administrateur le 04 mars 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de James Emile De Waele en tant que directeur le 04 mars 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Joseph Christopher Hubback en tant qu'administrateur le 04 mars 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr William Marston Reid en tant que secrétaire le 04 mars 2019 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Roger Bryan Barratt en tant que secrétaire le 04 mars 2019 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Roger Bryan Barratt en tant que directeur le 04 mars 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 27 nov. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 27 nov. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 nov. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 27 nov. 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014 | 7 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de KELLER DORMANT LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REID, William Marston | Secrétaire | Oxford Road Ryton On Dunsmore CV8 3EG Coventry Keller Limited | 256080810001 | |||||||
| REID, William Marston | Administrateur | Oxford Road Ryton On Dunsmore CV8 3EG Coventry Keller Limited | England | British | 236804500001 | |||||
| THOMPSON, Robert Malcolm | Administrateur | Oxford Road Ryton On Dunsmore CV8 3EG Coventry Keller Limited | United Kingdom | British | 267238290001 | |||||
| BARRATT, Roger Bryan | Secrétaire | Oxford Road Ryton On Dunsmore CV8 3EG Coventry Keller Limited United Kingdom | British | 79815620001 | ||||||
| WHITEHOUSE, Kevan | Secrétaire | Ridgeacre 23 Pilkington Avenue B72 1LA Sutton Coldfield West Midlands | British | 50711120002 | ||||||
| BARRATT, Roger Bryan | Administrateur | Oxford Road Ryton On Dunsmore CV8 3EG Coventry Keller Limited United Kingdom | United Kingdom | British | 79815620001 | |||||
| BELL, Alan Lyness, Dr | Administrateur | Wharfe Cottage 1 Wharfe Grove LS22 6HA Wetherby West Yorkshire | England | British | 112730510001 | |||||
| DE WAELE, James Emile | Administrateur | Oxford Road Ryton On Dunsmore CV8 3EG Coventry Keller Limited United Kingdom | United Kingdom | British | 92495900001 | |||||
| HUBBACK, Joseph Christopher | Administrateur | Oxford Road Ryton On Dunsmore CV8 3EG Coventry Keller Limited | England | British | 253834200001 | |||||
| MARTIN, Michael William Colin | Administrateur | Laudshill 12 Boat Horse Lane Crick NN6 7TH Northampton Northamptonshire | British | 20930730002 | ||||||
| WEST, John Michael, Dr | Administrateur | 20 Woodland Gardens N10 3UA London | British | 9389810001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur KELLER DORMANT LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keller Limited | 06 avr. 2016 | Ryton-On-Dunsmore CV8 3EG Coventry Oxford Road West Midlands England & Wales | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
KELLER DORMANT LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental deed relating to a guarantee and debenture | Créé le 14 janv. 1994 Livré le 01 févr. 1994 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facilities agreement dated 1ST may 1990 (as defined) | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Supplemental deed relating to a guarantee and debenture | Créé le 14 janv. 1994 Livré le 01 févr. 1994 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facilities agreement dated 1ST may 1990 (as defined) | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 06 juil. 1990 Livré le 17 juil. 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Guarantee & debenture | Créé le 01 mai 1990 Livré le 11 mai 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the facilities agreement dated 1/5/90 | |
Brèves mentions (See doc M22 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 21 nov. 1980 Livré le 21 nov. 1980 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Land in gun lane, strood, kent. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 21 nov. 1980 Livré le 21 nov. 1980 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H property situate at strood, rochester, kent. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Guarantee & debenture | Créé le 14 nov. 1980 Livré le 21 nov. 1980 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital & buildigns & fixtures & fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Guarantee and debenture | Créé le 22 août 1980 Livré le 01 sept. 1980 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0