KELLER DORMANT LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéKELLER DORMANT LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00323483
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de KELLER DORMANT LIMITED ?

    • Autres travaux de construction spécialisés n.d.a. (43999) / Construction

    Où se situe KELLER DORMANT LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Keller Limited Oxford Road
    Ryton On Dunsmore
    CV8 3EG Coventry
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de KELLER DORMANT LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    KELLER COLCRETE LIMITED04 mai 199004 mai 1990
    GKN COLCRETE LIMITED02 juin 198602 juin 1986
    COLCRETE LIMITED25 janv. 193725 janv. 1937

    Quels sont les derniers comptes de KELLER DORMANT LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour KELLER DORMANT LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name22 janv. 2021

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Déclaration de confirmation établie le 23 nov. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019

    7 pagesAA

    Nomination de Robert Malcolm Thompson en tant qu'administrateur le 13 févr. 2020

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Joseph Christopher Hubback en tant que directeur le 13 févr. 2020

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 26 nov. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes modifiés pour une société dormante jusqu'au 31 déc. 2018

    7 pagesAAMD

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    2 pagesAA

    Nomination de Mr William Marston Reid en tant qu'administrateur le 04 mars 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de James Emile De Waele en tant que directeur le 04 mars 2019

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Joseph Christopher Hubback en tant qu'administrateur le 04 mars 2019

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr William Marston Reid en tant que secrétaire le 04 mars 2019

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Roger Bryan Barratt en tant que secrétaire le 04 mars 2019

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Roger Bryan Barratt en tant que directeur le 04 mars 2019

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 27 nov. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 27 nov. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 nov. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 nov. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital22 déc. 2015

    État du capital au 22 déc. 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    7 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de KELLER DORMANT LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    REID, William Marston
    Oxford Road
    Ryton On Dunsmore
    CV8 3EG Coventry
    Keller Limited
    Secrétaire
    Oxford Road
    Ryton On Dunsmore
    CV8 3EG Coventry
    Keller Limited
    256080810001
    REID, William Marston
    Oxford Road
    Ryton On Dunsmore
    CV8 3EG Coventry
    Keller Limited
    Administrateur
    Oxford Road
    Ryton On Dunsmore
    CV8 3EG Coventry
    Keller Limited
    EnglandBritish236804500001
    THOMPSON, Robert Malcolm
    Oxford Road
    Ryton On Dunsmore
    CV8 3EG Coventry
    Keller Limited
    Administrateur
    Oxford Road
    Ryton On Dunsmore
    CV8 3EG Coventry
    Keller Limited
    United KingdomBritish267238290001
    BARRATT, Roger Bryan
    Oxford Road
    Ryton On Dunsmore
    CV8 3EG Coventry
    Keller Limited
    United Kingdom
    Secrétaire
    Oxford Road
    Ryton On Dunsmore
    CV8 3EG Coventry
    Keller Limited
    United Kingdom
    British79815620001
    WHITEHOUSE, Kevan
    Ridgeacre 23 Pilkington Avenue
    B72 1LA Sutton Coldfield
    West Midlands
    Secrétaire
    Ridgeacre 23 Pilkington Avenue
    B72 1LA Sutton Coldfield
    West Midlands
    British50711120002
    BARRATT, Roger Bryan
    Oxford Road
    Ryton On Dunsmore
    CV8 3EG Coventry
    Keller Limited
    United Kingdom
    Administrateur
    Oxford Road
    Ryton On Dunsmore
    CV8 3EG Coventry
    Keller Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritish79815620001
    BELL, Alan Lyness, Dr
    Wharfe Cottage 1 Wharfe Grove
    LS22 6HA Wetherby
    West Yorkshire
    Administrateur
    Wharfe Cottage 1 Wharfe Grove
    LS22 6HA Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish112730510001
    DE WAELE, James Emile
    Oxford Road
    Ryton On Dunsmore
    CV8 3EG Coventry
    Keller Limited
    United Kingdom
    Administrateur
    Oxford Road
    Ryton On Dunsmore
    CV8 3EG Coventry
    Keller Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritish92495900001
    HUBBACK, Joseph Christopher
    Oxford Road
    Ryton On Dunsmore
    CV8 3EG Coventry
    Keller Limited
    Administrateur
    Oxford Road
    Ryton On Dunsmore
    CV8 3EG Coventry
    Keller Limited
    EnglandBritish253834200001
    MARTIN, Michael William Colin
    Laudshill 12 Boat Horse Lane
    Crick
    NN6 7TH Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    Laudshill 12 Boat Horse Lane
    Crick
    NN6 7TH Northampton
    Northamptonshire
    British20930730002
    WEST, John Michael, Dr
    20 Woodland Gardens
    N10 3UA London
    Administrateur
    20 Woodland Gardens
    N10 3UA London
    British9389810001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur KELLER DORMANT LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Ryton-On-Dunsmore
    CV8 3EG Coventry
    Oxford Road
    West Midlands
    England & Wales
    06 avr. 2016
    Ryton-On-Dunsmore
    CV8 3EG Coventry
    Oxford Road
    West Midlands
    England & Wales
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement00485692
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    KELLER DORMANT LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Supplemental deed relating to a guarantee and debenture
    Créé le 14 janv. 1994
    Livré le 01 févr. 1994
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facilities agreement dated 1ST may 1990 (as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,as Agent and Trustee for the Banks,Theoverdraft Banks and the Swap Counterparty (Eachas Defined)
    Transactions
    • 01 févr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    Supplemental deed relating to a guarantee and debenture
    Créé le 14 janv. 1994
    Livré le 01 févr. 1994
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facilities agreement dated 1ST may 1990 (as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,as Agent and Trustee for the Banks,Theoverdraft Banks and the Swap Counterparty (Eachas Defined)
    Transactions
    • 01 févr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 06 juil. 1990
    Livré le 17 juil. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Any of the Principal Creditors(As Defined)
    • Bond Support Advisers LTD.(As Trustee)
    Transactions
    • 17 juil. 1990Enregistrement d'une charge
    • 05 nov. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 01 mai 1990
    Livré le 11 mai 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the facilities agreement dated 1/5/90
    Brèves mentions
    (See doc M22 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trustee for the Banks, the Overdraft Banks and the Swap Counter Party.
    Transactions
    • 11 mai 1990Enregistrement d'une charge
    • 07 mai 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 21 nov. 1980
    Livré le 21 nov. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land in gun lane, strood, kent.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 nov. 1980Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 21 nov. 1980
    Livré le 21 nov. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property situate at strood, rochester, kent.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 nov. 1980Enregistrement d'une charge
    Guarantee & debenture
    Créé le 14 nov. 1980
    Livré le 21 nov. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital & buildigns & fixtures & fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 nov. 1980Enregistrement d'une charge
    Guarantee and debenture
    Créé le 22 août 1980
    Livré le 01 sept. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 01 sept. 1980Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0