COVIDIEN UK LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCOVIDIEN UK LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00323648
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de COVIDIEN UK LIMITED ?

    • fabrication de bonneterie (14310) / Industries manufacturières

    Où se situe COVIDIEN UK LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Building 9 Croxley Park
    Hatters Lane
    WD18 8WW Watford
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de COVIDIEN UK LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TYCO HEALTHCARE UK LIMITED01 sept. 199901 sept. 1999
    KENDALL COMPANY(U.K)LIMITED(THE)29 janv. 193729 janv. 1937

    Quels sont les derniers comptes de COVIDIEN UK LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au26 avr. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour COVIDIEN UK LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Davilynn Ann Erickson le 14 juin 2019

    2 pagesCH01

    Statuts

    10 pagesMA

    Déclaration de confirmation établie le 03 janv. 2020 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    capital

    Résolution de suppression des droits de préemption

    RES11
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 400 Capabilty Green 400 Capabilty Green Luton Bedfordshire LU1 3AE England à Building 9 Hatters Lane Watford WD18 8WW

    1 pagesAD02

    Comptes annuels établis au 26 avr. 2019

    20 pagesAA

    État du capital après une attribution d'actions au 27 déc. 2019

    • Capital: GBP 36,050,001
    4 pagesSH01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 27 déc. 2019

    • Capital: GBP 1
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    4 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Nomination de Mrs Davilynn Ann Erickson en tant qu'administrateur le 01 avr. 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Mark Justin Elsey en tant que directeur le 01 avr. 2019

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 03 janv. 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 27 avr. 2018

    20 pagesAA

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 31 juil. 2018

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 03 janv. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 28 avr. 2017

    19 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de COVIDIEN UK LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PASCUCCI, Joanne
    Croxley Park
    Hatters Lane
    WD18 8WW Watford
    Building 9
    United Kingdom
    Secrétaire
    Croxley Park
    Hatters Lane
    WD18 8WW Watford
    Building 9
    United Kingdom
    BritishSenior Corporate Secretary140471420001
    ERICKSON, Davilynn Ann
    Croxley Park
    Hatters Lane
    WD18 8WW Watford
    Building 9
    United Kingdom
    Administrateur
    Croxley Park
    Hatters Lane
    WD18 8WW Watford
    Building 9
    United Kingdom
    EnglandAmericanFinance261950830001
    FIELDING, Jacqueline
    Croxley Park
    Hatters Lane
    WD18 8WW Watford
    Building 9
    United Kingdom
    Administrateur
    Croxley Park
    Hatters Lane
    WD18 8WW Watford
    Building 9
    United Kingdom
    EnglandEnglishVice President (Director)218205980001
    WEST, David Roy
    Grensell Close
    Eversley
    RG27 0QQ Hook
    11
    Hampshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Grensell Close
    Eversley
    RG27 0QQ Hook
    11
    Hampshire
    United Kingdom
    British10831940003
    BLEBTA, Colin
    11 Bishops Close
    BH7 7AB Bournemouth
    Dorset
    Administrateur
    11 Bishops Close
    BH7 7AB Bournemouth
    Dorset
    EnglandBritishAccountant93805030001
    COSTANTINO, Marco
    Parkway
    Whiteley
    PO15 7NY Fareham
    4500
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Parkway
    Whiteley
    PO15 7NY Fareham
    4500
    Hampshire
    United Kingdom
    ItalyItalianLawyer183802780001
    ELSEY, Mark Justin
    Croxley Park
    Hatters Lane
    WD18 8WW Watford
    Building 9
    United Kingdom
    Administrateur
    Croxley Park
    Hatters Lane
    WD18 8WW Watford
    Building 9
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director166448770001
    FORD, Thomas Peter Langmaid, Mr.
    Parkway
    Whiteley
    PO15 7NY Fareham
    4500
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Parkway
    Whiteley
    PO15 7NY Fareham
    4500
    Hampshire
    United Kingdom
    LuxembourgBritishLawyer162617380001
    IGLESIAS FERNANDEZ, Luis
    154 Fareham Road
    PO13 0FN Gosport
    Hampshire
    Administrateur
    154 Fareham Road
    PO13 0FN Gosport
    Hampshire
    SpanishPresident Emea113619160001
    LLOYD DAVIES, John
    45 Dukes Wood
    RG45 6NF Crowthorne
    Berkshire
    Administrateur
    45 Dukes Wood
    RG45 6NF Crowthorne
    Berkshire
    BritishDirector Of Operations70365130001
    MILLET LOPEZ, Oriol
    Spring Lane
    Colden Common
    SO21 1SD Winchester
    32
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Spring Lane
    Colden Common
    SO21 1SD Winchester
    32
    Hampshire
    United Kingdom
    SpanishAccountant117789870002
    REYNOLDS, Debra Margaret
    Croxley Park
    Hatters Lane
    WD18 8WW Watford
    Building 9
    United Kingdom
    Administrateur
    Croxley Park
    Hatters Lane
    WD18 8WW Watford
    Building 9
    United Kingdom
    EnglandBritishFinancial Controller136069300001
    SETTEVIK, Tomas
    Bratenalleen 24-26
    Oslo
    0487
    Norway
    Administrateur
    Bratenalleen 24-26
    Oslo
    0487
    Norway
    NorwegianManaging Director72515790001
    SKEET, Barry John
    Tulip Tree House
    Mill Lane
    PO9 1RX Havant
    Hampshire
    Administrateur
    Tulip Tree House
    Mill Lane
    PO9 1RX Havant
    Hampshire
    EnglandBritishManaging Director80634300001
    STEFANI, Michelangelo Federico
    Croxley Park
    Hatters Lane
    WD18 8WW Watford
    Building 9
    United Kingdom
    Administrateur
    Croxley Park
    Hatters Lane
    WD18 8WW Watford
    Building 9
    United Kingdom
    LuxembourgItalianLawyer148209500001
    SWINDELLS, Leslie Harvey
    66 High Oaks Close
    Locks Heath
    SO31 6SX Southampton
    Hampshire
    Administrateur
    66 High Oaks Close
    Locks Heath
    SO31 6SX Southampton
    Hampshire
    BritishAccountant57274820001
    WEST, David Roy
    Grensell Close
    Eversley
    RG27 0QQ Hook
    11
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Grensell Close
    Eversley
    RG27 0QQ Hook
    11
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant10831940003

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur COVIDIEN UK LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Hatters Lane
    WD18 8WW Watford
    Building 9 Croxley Park
    Hertfordshire
    06 avr. 2016
    Hatters Lane
    WD18 8WW Watford
    Building 9 Croxley Park
    Hertfordshire
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement02285007
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    COVIDIEN UK LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Letter of charge and set-off
    Créé le 10 août 1992
    Livré le 25 août 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The sum(s) from time to time standing to the credit of account(s) 01145028.170.00 maintained with the bank and the sum(s) from time to time standing to the credit of any blocked deposit accounts which may hereafter be opened.
    Personnes ayant droit
    • Credit Lyonnais
    Transactions
    • 25 août 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 sept. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over book debts & stocks
    Créé le 13 févr. 1991
    Livré le 22 févr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All book debts & other debts due or owing to the company. Floating security all the company's stock in trade from time to time.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 22 févr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 19 sept. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 12 juil. 1989
    Livré le 28 juil. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the stock, raw materials and work-in-progress, book and other debts.
    Personnes ayant droit
    • Banque Bruxelles Lambert S.A.
    Transactions
    • 28 juil. 1989Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 31 oct. 1988
    Livré le 05 nov. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or cdk U.K. limited to the chargee for and on behalf of the participating banks under the terms of a standby letter of credit application referred to in a credit agreement dated 31/10/88
    Brèves mentions
    Site bt.463-5 Pool industrial estate, redruth cornwall and 10.73 acres at haundmills industrial estate, haundmills, basingstoke (see form 395 for full details).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Manufacturers Hanover Trust Company for and on Behalf of the Participating Banks
    Transactions
    • 05 nov. 1988Enregistrement d'une charge
    • 07 janv. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0