CAVENDISH-WOODHOUSE (HOLDINGS) LIMITED

CAVENDISH-WOODHOUSE (HOLDINGS) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCAVENDISH-WOODHOUSE (HOLDINGS) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00323690
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CAVENDISH-WOODHOUSE (HOLDINGS) LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe CAVENDISH-WOODHOUSE (HOLDINGS) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Old Brewhouse 49-51 Brewhouse Hill
    Wheathampstead
    AL4 8AN St Albans
    Hertfordshire
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de CAVENDISH-WOODHOUSE (HOLDINGS) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour CAVENDISH-WOODHOUSE (HOLDINGS) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    18 pagesLIQ14

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 16 sept. 2021

    17 pagesLIQ03

    Modification des coordonnées du secrétaire Mrs Stephanie Carole Maffey le 22 déc. 2020

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Jonathan Hemmings le 22 déc. 2020

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Christopher Thomas Holdsworth le 22 déc. 2020

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de Stag House Old London Road Hertford Hertfordshire SG13 7LA United Kingdom à The Old Brewhouse 49-51 Brewhouse Hill Wheathampstead St Albans Hertfordshire AL4 8AN le 22 déc. 2020

    1 pagesAD01

    Modification des détails de City & Provincial (Equity Partners) Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 19 oct. 2020

    2 pagesPSC05

    Modification des coordonnées du secrétaire Mrs Stephanie Carole Maffey le 19 oct. 2020

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Jonathan Hemmings le 19 oct. 2020

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Christopher Thomas Holdsworth le 19 oct. 2020

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de The Old Brewhouse 49-51 Brewhouse Hill Wheathampstead St Albans Hertfordshire AL4 8AN à Stag House Old London Road Hertford Hertfordshire SG13 7LA le 19 oct. 2020

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de C/O Aston Rose 1st Floor 4 Tenterden Street London W1S 1TE England à The Old Brewhouse 49-51 Brewhouse Hill Wheathampstead St Albans Hertfordshire AL4 8AN le 07 oct. 2020

    2 pagesAD01

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    4 pagesNDISC

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Déclaration des affaires

    8 pagesLIQ02

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 17 sept. 2020

    LRESEX

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2019

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 29 déc. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mrs Stephanie Carole Maffey le 19 août 2019

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Jonathan Hemmings le 19 août 2019

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Christopher Thomas Holdsworth le 19 août 2019

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de C/O Aston Rose St Albans House 57-59 Haymarket London SW1Y 4QX England à C/O Aston Rose 1st Floor 4 Tenterden Street London W1S 1TE le 19 août 2019

    1 pagesAD01

    Modification des détails de City & Provincial (Equity Partners) Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 19 août 2019

    2 pagesPSC05

    Déclaration de confirmation établie le 29 déc. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de CAVENDISH-WOODHOUSE (HOLDINGS) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MAFFEY, Stephanie Carole
    49-51 Brewhouse Hill
    Wheathampstead
    AL4 8AN St Albans
    The Old Brewhouse
    Hertfordshire
    England
    Secrétaire
    49-51 Brewhouse Hill
    Wheathampstead
    AL4 8AN St Albans
    The Old Brewhouse
    Hertfordshire
    England
    BritishCompany Secretary19259680002
    HEMMINGS, David Jonathan
    49-51 Brewhouse Hill
    Wheathampstead
    AL4 8AN St Albans
    The Old Brewhouse
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    49-51 Brewhouse Hill
    Wheathampstead
    AL4 8AN St Albans
    The Old Brewhouse
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritishCompany Director55142860003
    HOLDSWORTH, Christopher Thomas
    49-51 Brewhouse Hill
    Wheathampstead
    AL4 8AN St Albans
    The Old Brewhouse
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    49-51 Brewhouse Hill
    Wheathampstead
    AL4 8AN St Albans
    The Old Brewhouse
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritishCompany Director48547330001
    BRAINE, Anthony
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    Secrétaire
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    British32809000002
    HARROP, Donald
    1 Fullerton Terrace
    Collingham
    LS22 5AT Wetherby
    West Yorkshire
    Secrétaire
    1 Fullerton Terrace
    Collingham
    LS22 5AT Wetherby
    West Yorkshire
    BritishCertified Accountant69330001
    NEVILLE, Richard John
    3 Kings Road
    Bramhope
    LS16 9JW Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    3 Kings Road
    Bramhope
    LS16 9JW Leeds
    West Yorkshire
    British30413580001
    ADAM, Shenol
    13 Beech Drive
    N2 9NX London
    Administrateur
    13 Beech Drive
    N2 9NX London
    BritishCompany Director2068480001
    BARNES, Eric Malcolm
    148 Chapel Lane
    Ravenshead
    NG15 9DJ Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    148 Chapel Lane
    Ravenshead
    NG15 9DJ Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishCompany Director20256100002
    BARZYCKI, Sarah Morrell
    Sandown Road
    KT10 9TT Esher
    27
    Surrey
    Administrateur
    Sandown Road
    KT10 9TT Esher
    27
    Surrey
    United KingdomBritishHead Of Finance58016770004
    BELL, Lucinda Margaret
    6 Priory Gardens
    Chiswick
    W4 1TT London
    Administrateur
    6 Priory Gardens
    Chiswick
    W4 1TT London
    EnglandBritishChartered Accountant32809050004
    BOWDEN, Robert Edward
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    Administrateur
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    United KingdomBritishChartered Surveyor152497530001
    BRAINE, Anthony
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    Administrateur
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    United KingdomBritishChartered Secretary32809000002
    BURY, David Gordon
    The Viking Wing
    Thurland Castle Tunstall
    LA6 2QR Lancaster
    Lancashire
    Administrateur
    The Viking Wing
    Thurland Castle Tunstall
    LA6 2QR Lancaster
    Lancashire
    United KingdomBritishCompany Director114282510002
    CLARKE, Peter Courtenay
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    Administrateur
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    United KingdomBritishChartered Secretary78691990003
    DOUBBLE, David John Meredith
    28 Belvedere Close
    TW11 0NT Teddington
    Middlesex
    Administrateur
    28 Belvedere Close
    TW11 0NT Teddington
    Middlesex
    United KingdomBritishCompany Director6606840001
    FORSHAW, Christopher Michael John
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    Administrateur
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director1898090001
    GUNSTON, Michael Ian
    Larchmont
    Hambledon Road, Denmead
    PO7 6HB Waterlooville
    Hampshire
    Administrateur
    Larchmont
    Hambledon Road, Denmead
    PO7 6HB Waterlooville
    Hampshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor3079890002
    HARROP, Donald
    1 Fullerton Terrace
    Collingham
    LS22 5AT Wetherby
    West Yorkshire
    Administrateur
    1 Fullerton Terrace
    Collingham
    LS22 5AT Wetherby
    West Yorkshire
    BritishCertified Accountant69330001
    HESTER, Stephen Alan Michael
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    Administrateur
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    BritishChief Executive51688320001
    HINCHLEY, David
    20 Leconfield Garth
    Follifoot
    HG3 1NF Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    20 Leconfield Garth
    Follifoot
    HG3 1NF Harrogate
    North Yorkshire
    BritishManagement Accountant21091680001
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    Administrateur
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritishCompany Director82020730004
    METLISS, Cyril
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    Administrateur
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    BritishChartered Accountant3079600001
    MORRIS, David
    4 Greenmount Drive
    Greenmount
    BL8 4HA Bury
    Lancashire
    Administrateur
    4 Greenmount Drive
    Greenmount
    BL8 4HA Bury
    Lancashire
    BritishCompany Secretary3442030001
    PELTZ, Daniel
    9 Cavendish Avenue
    St Johns Wood
    NW8 9JD London
    Administrateur
    9 Cavendish Avenue
    St Johns Wood
    NW8 9JD London
    United KingdomBritishDirector34366280004
    RITBLAT, John, Sir
    The Doric Villa 20 York Terrace East
    Regents Park
    NW1 4PT London
    Administrateur
    The Doric Villa 20 York Terrace East
    Regents Park
    NW1 4PT London
    EnglandBritishChairman And Managing Director41694870001
    RITBLAT, Nicholas Simon Jonathan
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    Administrateur
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    United KingdomBritishCompany Director35758050004
    RITBLAT, Nicholas Simon Jonathan
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    Administrateur
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    United KingdomBritishCompany Director35758050004
    ROBERTS, Graham Charles
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    Administrateur
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    EnglandBritishChartered Accountant79807180002
    ROBERTS, Timothy Andrew
    Lorne House
    Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Lorne House
    Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Surveyor63986410003
    THOMAS, Richard
    Wescoe Lodge
    Weeton
    LS21 2PY Otley
    North Yorkshire
    Administrateur
    Wescoe Lodge
    Weeton
    LS21 2PY Otley
    North Yorkshire
    EnglandBritishChartered Surveyor67723470001
    TYLER, David Alan
    6 Ernle Road
    Wimbledon
    SW20 0HJ London
    Administrateur
    6 Ernle Road
    Wimbledon
    SW20 0HJ London
    BritishCompany Director51860290001
    TYLER, David Alan
    6 Ernle Road
    Wimbledon
    SW20 0HJ London
    Administrateur
    6 Ernle Road
    Wimbledon
    SW20 0HJ London
    BritishAccountant51860290001
    WEBB, Nigel Mark
    Beech Lodge
    53 Crouch Hall Lane Redbourn
    AL3 7EU St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    Beech Lodge
    53 Crouch Hall Lane Redbourn
    AL3 7EU St Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Surveyor58059360001
    WEIGH, Peter Langford
    191 Windlehurst Road
    High Lane
    SK6 8AG Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    191 Windlehurst Road
    High Lane
    SK6 8AG Stockport
    Cheshire
    BritishChartered Accountant318550002
    WESTON SMITH, John Harry
    10 Eldon Grove
    Hampstead
    NW3 5PT London
    Administrateur
    10 Eldon Grove
    Hampstead
    NW3 5PT London
    EnglandBritishChartered Secretary13547380001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CAVENDISH-WOODHOUSE (HOLDINGS) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    City & Provincial (Equity Partners) Ltd
    Old London Road
    SG13 7LA Hertford
    Stag House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Old London Road
    SG13 7LA Hertford
    Stag House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland & Wales
    Numéro d'enregistrement03986381
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    CAVENDISH-WOODHOUSE (HOLDINGS) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of assignment of rents
    Créé le 13 mars 2012
    Livré le 21 mars 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The rents. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 21 mars 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 19 févr. 2015L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    Debenture
    Créé le 13 mars 2012
    Livré le 21 mars 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 21 mars 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 19 févr. 2015L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    Legal charge
    Créé le 31 août 2010
    Livré le 02 sept. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The property k/a 679-681 green lane dagenham t/no. EGL44022 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 02 sept. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 19 févr. 2015L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    Legal charge
    Créé le 31 août 2010
    Livré le 02 sept. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The property k/a 153-155 high street staines middlesex t/no. SY332889 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 02 sept. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 19 févr. 2015L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 14TH april 1998
    Créé le 31 mars 1998
    Livré le 28 avr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations monies and liabilities due or owing by bl universal PLC (the obligant) to the chargee in terms of a trust deed dated 31ST march 1998 constituting and securing £100,000,000 6 3/4% first mortgage debenture bonds due 2011 and £200,000,000 6 3/4% first mortgage debenture bonds due 2020
    Brèves mentions
    Units 1 1B and 3 howgate centre 93/97 high street falkirk.
    Personnes ayant droit
    • Royal Exchange Trust Company Limited
    Transactions
    • 28 avr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mai 2002Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 03 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 14TH april 1998
    Créé le 31 mars 1998
    Livré le 28 avr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations monies and liabilities due or owing by bl universal PLC (the obligant) to the chargee in terms of a trust deed dated 31ST march 1998 constituting and securing £100,000,000 6 3/4% first mortgage debenture bonds due 2011 and £200,000,000 6 3/4% first mortgage debenture bonds due 2020
    Brèves mentions
    122/126 sauchiehall street glasgow.
    Personnes ayant droit
    • Royal Exchange Trust Company Limited
    Transactions
    • 28 avr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 févr. 2006Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 03 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Indenture of mortgage
    Créé le 31 mars 1998
    Livré le 16 avr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the trust deed dated 31ST march 1998 between bl universal PLC the company and others and the trustee
    Brèves mentions
    Cavendish house grafton street parish of st andrew city of dublin comprising 28 and 29 grafton street (formerly the rear of 30 grafton street) 9 and 10 lemon street and the rere of 7 south anne street under the terms of an indenture of lease dated 9TH august 1979. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Royal Exchange Trust Company Limited(As Trustee for the Holders of the Bonds)
    Transactions
    • 16 avr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Trust deed dated 31ST march 1998 constituting and securing £100,000,000 6 3/4 per cent. First mortgage debenture bonds due 2011 and £200,000,000 6 3/4 per cent. First mortgage debenture bonds due 2020 (with authority to issue further first mortgage debenture bonds or notes) between bl universal PLC, the company and others and royal exchange trust company
    Créé le 31 mars 1998
    Livré le 16 avr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The payment of the principal of, premium (if any) and interest on thr bonds, and any further bonds and all other monies covenanted to be paid by bl universal PLC to the trustee under or pursuant to the trust deed
    Brèves mentions
    Various properties as specified in schedule to form 395 relative to the deed. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Royal Exchange Trust Company Limited(As Trustee for the Holders of the Bonds)
    Transactions
    • 16 avr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mai 2002Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 02 déc. 2005Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 03 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of release and substitution
    Créé le 07 avr. 1986
    Livré le 09 avr. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Sterling pounds 945,177 and all other monies due or to become due from the times furnishing co. (Properties) limited to the chargee under the terms of a principal trust deed dated 17.2.55 and deeds supplemental thereto.
    Brèves mentions
    289, high street lincoln t/no ll 11869. 288 high street lincoln 28 and 30 and part of 26 college street, rotherham, w yorks.
    Personnes ayant droit
    • Alliance Assurance Company Limited
    Transactions
    • 09 avr. 1986Enregistrement d'une charge
    • 21 févr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 13 sept. 1956
    Acquis le 18 avr. 1957
    Livré le 26 avr. 1957
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Sterling pounds 30,000 (owing)
    Brèves mentions
    Talbot house, talbot st, nottingham.
    Personnes ayant droit
    • Co-Op. Insurance Socy LTD.
    Transactions
    • 26 avr. 1957Enregistrement d'une charge
    • 21 févr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 08 oct. 1955
    Acquis le 01 févr. 1965
    Livré le 17 févr. 1965
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Sterling pounds 35,000
    Brèves mentions
    348, 348A, 350, 352 and 354, high st, gateshead, co, durham.
    Personnes ayant droit
    • Legal and General Assurance Society Limited
    Transactions
    • 17 févr. 1965Enregistrement d'une charge
    • 21 févr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Bond and disposition in security LTD and presented at the register of sasines on 25/07/1961
    Créé le 01 déc. 1954
    Acquis le 19 mai 1961
    Livré le 15 août 1961
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Sterling pounds 3,101.10 (owing)
    Brèves mentions
    67/69 bridge street airdrie scotland.
    Personnes ayant droit
    • Standard Property Investment Company LTD
    Transactions
    • 15 août 1961Enregistrement d'une charge
    • 21 févr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Bond and disposition in security
    Créé le 06 août 1953
    Acquis le 19 déc. 1956
    Livré le 09 janv. 1957
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Sterling pounds 42,500 (owing)
    Brèves mentions
    61/69 jamaica street and 8/10 howard street, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • Guardian Assurance Co. LTD
    Transactions
    • 09 janv. 1957Enregistrement d'une charge
    • 21 févr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Bond and disposition in security
    Créé le 06 août 1953
    Acquis le 19 déc. 1956
    Livré le 09 janv. 1957
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Sterling pounds 42,500 (owing)
    Brèves mentions
    71/87 jamaica street and 308 clyde street, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • Guardian Assurance Co. LTD
    Transactions
    • 09 janv. 1957Enregistrement d'une charge
    • 21 févr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Bond and deposition in security
    Créé le 29 avr. 1953
    Acquis le 19 déc. 1956
    Livré le 09 janv. 1957
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Sterling pounds 8-032-10-0 (owing)
    Brèves mentions
    25 and 29 hamilton street greenock.
    Personnes ayant droit
    • Guardian Assurance Co. LTD
    Transactions
    • 09 janv. 1957Enregistrement d'une charge
    • 21 févr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 23 janv. 1952
    Acquis le 22 janv. 1966
    Livré le 04 févr. 1966
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Sterling pounds 13,000
    Brèves mentions
    65 westgate road newcastle upon tyne.
    Personnes ayant droit
    • Atlas Assurance Company LTD
    Transactions
    • 04 févr. 1966Enregistrement d'une charge
    • 21 févr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 23 oct. 1951
    Acquis le 28 mars 1960
    Livré le 31 mars 1960
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Sterling pounds 2000 (owing)
    Brèves mentions
    85 boothferry road, goole, yorks.
    Personnes ayant droit
    • Miss D. Parker
    Transactions
    • 31 mars 1960Enregistrement d'une charge
    • 21 févr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 19 juin 1951
    Acquis le 20 mars 1963
    Livré le 08 avr. 1963
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Sterling pounds 3,400
    Brèves mentions
    7 market place peterborough.
    Personnes ayant droit
    • Atlas Assurance Company Limited
    Transactions
    • 08 avr. 1963Enregistrement d'une charge
    • 21 févr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Bond & disposition in security.presented for registration at the register of sasines on the 13 june 1951
    Créé le 17 mai 1951
    Livré le 22 juin 1951
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Sterling pounds 15000
    Brèves mentions
    75 & 77, murraygate, dundee, county of angus, scotland.
    Personnes ayant droit
    • Adas Assurance Company LTD
    Transactions
    • 22 juin 1951Enregistrement d'une charge
    • 21 févr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 30 mars 1951
    Acquis le 11 févr. 1957
    Livré le 01 mars 1957
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Sterling pounds 3,800 (owing)
    Brèves mentions
    143-5 cleethorpe road grimsby.
    Personnes ayant droit
    • The Legal and General Assurance Society LTD.
    Transactions
    • 01 mars 1957Enregistrement d'une charge
    • 21 févr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 20 févr. 1951
    Livré le 21 févr. 1951
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Sterling pounds 25 000
    Brèves mentions
    Nos 8, 10, & 12 lee high road, lewisham london.
    Personnes ayant droit
    • Union Pension Trust LTD
    Transactions
    • 21 févr. 1951Enregistrement d'une charge
    • 21 févr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Bond and disposition in security
    Créé le 30 juin 1950
    Acquis le 10 août 1956
    Livré le 20 août 1956
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Sterling pounds 2,600 (owing)
    Brèves mentions
    16 bonnar street, dunfermline.
    Personnes ayant droit
    • G.F. Cowan
    • J.F. Dunlop
    Transactions
    • 20 août 1956Enregistrement d'une charge
    • 21 févr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 31 janv. 1950
    Acquis le 31 janv. 1957
    Livré le 04 févr. 1957
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Sterling pounds 2650 (owing)
    Brèves mentions
    158, hessle road, kingston-upon, hull, yorks.
    Personnes ayant droit
    • The Southwell Diocesan Board of Finance
    Transactions
    • 04 févr. 1957Enregistrement d'une charge
    • 21 févr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 16 juil. 1949
    Acquis le 29 sept. 1956
    Livré le 02 oct. 1956
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Sterling pounds 3,000 (owing)
    Brèves mentions
    386 hessle road, kingston-upon-hull, yorks.
    Personnes ayant droit
    • The Southwell Diocesan Board of Finance
    Transactions
    • 02 oct. 1956Enregistrement d'une charge
    • 21 févr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Bond and disposition in security
    Créé le 20 mai 1949
    Acquis le 05 oct. 1956
    Livré le 22 oct. 1956
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Sterling pounds 35,000 (owing)
    Brèves mentions
    50-60, union street, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • Standard Property Invest. Co. LTD
    Transactions
    • 22 oct. 1956Enregistrement d'une charge
    • 21 févr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    CAVENDISH-WOODHOUSE (HOLDINGS) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    17 sept. 2020Commencement of winding up
    30 juin 2022Due to be dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Hayley Maddison
    The Old Brewhouse 49-51 Brewhouse Hill
    Wheathampstead
    AL4 8AN St Albans
    Hertfordshire
    practitioner
    The Old Brewhouse 49-51 Brewhouse Hill
    Wheathampstead
    AL4 8AN St Albans
    Hertfordshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0