DAVID BROWN SPECIAL PRODUCTS LIMITED

DAVID BROWN SPECIAL PRODUCTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDAVID BROWN SPECIAL PRODUCTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 00325111
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DAVID BROWN SPECIAL PRODUCTS LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe DAVID BROWN SPECIAL PRODUCTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Green Road
    Penistone
    S36 6BJ Sheffield
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de DAVID BROWN SPECIAL PRODUCTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    DAVID BROWN KEIGHLEY LIMITED29 juin 198829 juin 1988
    DAVID BROWN GEAR INDUSTRIES (INTERNATIONAL) LIMITED08 mars 193708 mars 1937

    Quels sont les derniers comptes de DAVID BROWN SPECIAL PRODUCTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour DAVID BROWN SPECIAL PRODUCTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 mai 2012 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 juin 2012

    État du capital au 15 juin 2012

    • Capital: GBP 12,539
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Patrick Joseph O'leary le 13 mai 2012

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mark Edward Shanahan le 13 mai 2012

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Kevin Lucius Lilly le 13 mai 2012

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Balkar Sohal le 13 mai 2012

    2 pagesCH01

    Nomination de Mark Edward Shanahan en tant qu'administrateur le 22 déc. 2011

    3 pagesAP01

    Nomination de Mr Balkar Sohal en tant qu'administrateur le 22 déc. 2011

    3 pagesAP01

    Nomination de Patrick Joseph O'leary en tant qu'administrateur le 22 déc. 2011

    3 pagesAP01

    Nomination de Kevin Lucius Lilly en tant qu'administrateur le 22 déc. 2011

    3 pagesAP01

    Retrait de la demande de radiation de la société

    2 pagesDS02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    4 pagesAA

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 mai 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 mai 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2008

    4 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages287

    legacy

    2 pages288a

    Qui sont les dirigeants de DAVID BROWN SPECIAL PRODUCTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BROWN, Thomas James
    57 Randolph Road
    G11 7JJ Glasgow
    Secrétaire
    57 Randolph Road
    G11 7JJ Glasgow
    BritishCompany Secretary60773560001
    DOWIE, Allan Cameron
    Arkaig Place
    Newton Mearns
    G77 5PH Glasgow
    7
    Administrateur
    Arkaig Place
    Newton Mearns
    G77 5PH Glasgow
    7
    United KingdomBritishFinance Director132053460001
    LILLY, Kevin Lucius
    Ballantyne
    Corporate Place Charlotte
    North Carolina
    13515
    28277
    Usa
    Administrateur
    Ballantyne
    Corporate Place Charlotte
    North Carolina
    13515
    28277
    Usa
    UsaAmericanDirector165775730001
    O'LEARY, Patrick Joseph
    Ballantyne
    Corporate Place Charlotte
    North Carolina
    13515
    28277
    Usa
    Administrateur
    Ballantyne
    Corporate Place Charlotte
    North Carolina
    13515
    28277
    Usa
    United StatesAmericanDirector61807850002
    SHANAHAN, Mark Edward
    City Place
    Beehive Ring Road
    RH6 0PA Gatwick
    The Beehive
    West Sussex
    England
    Administrateur
    City Place
    Beehive Ring Road
    RH6 0PA Gatwick
    The Beehive
    West Sussex
    England
    United KingdomBritishDirector165707440001
    SOHAL, Balkar
    Beehive Ring Road
    London Gatwick Airport
    RH6 0PA Gatwick
    The Beehive
    West Sussex
    England
    Administrateur
    Beehive Ring Road
    London Gatwick Airport
    RH6 0PA Gatwick
    The Beehive
    West Sussex
    England
    EnglandEnglishChartered Accoutant161546310001
    AINSCOUGH, Paul Wayne
    22 Carrbrook Drive
    Atherton
    M46 9HT Manchester
    Lancashire
    Secrétaire
    22 Carrbrook Drive
    Atherton
    M46 9HT Manchester
    Lancashire
    British1876370001
    ASHMAN, Linda Margaret
    Blue Fields
    421 Huddersfield Road, Shelley
    HD8 8NE Woodhouse Huddersfield
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Blue Fields
    421 Huddersfield Road, Shelley
    HD8 8NE Woodhouse Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishSolicitor & Company Secretary86730910001
    PEPPER, Teresa Christina
    20 Blakefield Drive
    Worsley
    M28 7DW Manchester
    Lancashire
    Secrétaire
    20 Blakefield Drive
    Worsley
    M28 7DW Manchester
    Lancashire
    BritishFinance Director63024230001
    TULLEY, Karen Ann
    Knottside Farm
    The Knott, Pateley Bridge
    HG3 5DQ Harrogate
    North Yorkshire
    Secrétaire
    Knottside Farm
    The Knott, Pateley Bridge
    HG3 5DQ Harrogate
    North Yorkshire
    BritishSolicitor59112980002
    AINSCOUGH, Paul Wayne
    Apartment 301 Valley Mill
    Cottonfields Eagley Brook
    BL7 9DY Bolton
    Lancashire
    Administrateur
    Apartment 301 Valley Mill
    Cottonfields Eagley Brook
    BL7 9DY Bolton
    Lancashire
    EnglandBritishFinance Director1876370002
    AINSCOUGH, Paul Wayne
    22 Carrbrook Drive
    Atherton
    M46 9HT Manchester
    Lancashire
    Administrateur
    22 Carrbrook Drive
    Atherton
    M46 9HT Manchester
    Lancashire
    BritishFinance Director1876370001
    BROADHEAD, Anthony David
    19 Goldcrest Court
    Netherton
    HD4 7LN Huddersfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    19 Goldcrest Court
    Netherton
    HD4 7LN Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishOperations Director12354680001
    BROWN, Christopher John
    The Grange Bent Lane
    Sutton In Craven
    BD20 7AL Keighley
    West Yorkshire
    Administrateur
    The Grange Bent Lane
    Sutton In Craven
    BD20 7AL Keighley
    West Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director1698880001
    CLARK, William
    Wellcroft 10 Shepley Road
    Stocksmoor
    HD4 6XW Huddersfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    Wellcroft 10 Shepley Road
    Stocksmoor
    HD4 6XW Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishCompany Director12354650001
    COOK, Christopher David
    Beauchamp House
    Church Road
    CV35 8AN Sherbourne
    Warwickshire
    Administrateur
    Beauchamp House
    Church Road
    CV35 8AN Sherbourne
    Warwickshire
    United KingdomBritishCompany Director1698890001
    ELSBORG, Anton Cecil
    Woodstock
    Thorpe Lane
    LS20 8LE Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    Woodstock
    Thorpe Lane
    LS20 8LE Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishGroup Finance Director93041580001
    HOLLAND, Mark Harry
    219 Huddersfield Road
    Thongsbridge
    HD9 3TT Holmfirth
    West Yorkshire
    Administrateur
    219 Huddersfield Road
    Thongsbridge
    HD9 3TT Holmfirth
    West Yorkshire
    United KingdomBritishAccountant98168130001
    MADGE, John Gordon
    23 Greenway
    Honley
    HD7 2BZ Huddersfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    23 Greenway
    Honley
    HD7 2BZ Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishManaging Director1866470001
    NAYLOR, Clive Derick
    1 Albany Drive
    HD5 9UR Huddersfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    1 Albany Drive
    HD5 9UR Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishSales Director12354660001
    PENNING, Graham Michael
    36 Riley Park
    Kirkburton
    HD8 0SA Huddersfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    36 Riley Park
    Kirkburton
    HD8 0SA Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritishVice President Of Engineering12354670001
    PENNING, Graham Michael
    36 Riley Park
    Kirkburton
    HD8 0SA Huddersfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    36 Riley Park
    Kirkburton
    HD8 0SA Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritishOperations Director12354670001
    PEPPER, Teresa Christina
    20 Blakefield Drive
    Worsley
    M28 7DW Manchester
    Lancashire
    Administrateur
    20 Blakefield Drive
    Worsley
    M28 7DW Manchester
    Lancashire
    BritishFinance Director63024230001
    PRIDEAUX, Christopher Clive
    21a Primrose Lane
    Kirkburton
    HD8 0QY Huddersfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    21a Primrose Lane
    Kirkburton
    HD8 0QY Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector64753680001
    WHITAKER, Richard Brian
    48 Ryefields
    Scholes Holmfirth
    HD7 1XF Huddersfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    48 Ryefields
    Scholes Holmfirth
    HD7 1XF Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishCompany Director70342650001

    DAVID BROWN SPECIAL PRODUCTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee and debenture
    Créé le 24 sept. 1992
    Livré le 07 oct. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums and liabilities (without limitation) due or to become due from the company and the obligors (as defined in the debenture) to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    See form 395 ref m*90. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 07 oct. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 août 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debentrue
    Créé le 24 janv. 1990
    Livré le 06 févr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the senior credit agreement dated 24.1.90 and the other financing documents.
    Brèves mentions
    (See 395 ref M90 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Bankers Trust Companyor Each Bank (As Defined)Asogent and Trustee for Itself the Aranger and F
    Transactions
    • 06 févr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 30 nov. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 24 janv. 1990
    Livré le 05 févr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or each obligor (as defined) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the financing documents (as defined) and this charge.
    Brèves mentions
    Second shares, dividends, licences & copyrights (for further details see form 395 and continuation sheets relevant to this charge).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • First Britannia Mezzanine Capital B.V.Londers (As Defined)as Agent and Trustee for Itself and Each of The
    Transactions
    • 05 févr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 30 nov. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 27 juin 1989
    Livré le 04 juil. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 juil. 1989Enregistrement d'une charge
    Single debenture
    Créé le 27 juin 1989
    Livré le 30 juin 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 30 juin 1989Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 08 mai 1989
    Livré le 15 mai 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 mai 1989Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0