DAVID BROWN SPECIAL PRODUCTS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | DAVID BROWN SPECIAL PRODUCTS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 00325111 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe DAVID BROWN SPECIAL PRODUCTS LIMITED ?
Adresse du siège social | Green Road Penistone S36 6BJ Sheffield |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de DAVID BROWN SPECIAL PRODUCTS LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2010 |
Quels sont les derniers dépôts pour DAVID BROWN SPECIAL PRODUCTS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 15 mai 2012 avec liste complète des actionnaires | 8 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Patrick Joseph O'leary le 13 mai 2012 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mark Edward Shanahan le 13 mai 2012 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Kevin Lucius Lilly le 13 mai 2012 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Balkar Sohal le 13 mai 2012 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Nomination de Mark Edward Shanahan en tant qu'administrateur le 22 déc. 2011 | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Balkar Sohal en tant qu'administrateur le 22 déc. 2011 | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Patrick Joseph O'leary en tant qu'administrateur le 22 déc. 2011 | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Kevin Lucius Lilly en tant qu'administrateur le 22 déc. 2011 | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Retrait de la demande de radiation de la société | 2 pages | DS02 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010 | 4 pages | AA | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 15 mai 2011 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 15 mai 2010 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2008 | 4 pages | AA | ||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
legacy | 1 pages | 287 | ||||||||||
legacy | 2 pages | 288a | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de DAVID BROWN SPECIAL PRODUCTS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROWN, Thomas James | Secrétaire | 57 Randolph Road G11 7JJ Glasgow | British | Company Secretary | 60773560001 | |||||
DOWIE, Allan Cameron | Administrateur | Arkaig Place Newton Mearns G77 5PH Glasgow 7 | United Kingdom | British | Finance Director | 132053460001 | ||||
LILLY, Kevin Lucius | Administrateur | Ballantyne Corporate Place Charlotte North Carolina 13515 28277 Usa | Usa | American | Director | 165775730001 | ||||
O'LEARY, Patrick Joseph | Administrateur | Ballantyne Corporate Place Charlotte North Carolina 13515 28277 Usa | United States | American | Director | 61807850002 | ||||
SHANAHAN, Mark Edward | Administrateur | City Place Beehive Ring Road RH6 0PA Gatwick The Beehive West Sussex England | United Kingdom | British | Director | 165707440001 | ||||
SOHAL, Balkar | Administrateur | Beehive Ring Road London Gatwick Airport RH6 0PA Gatwick The Beehive West Sussex England | England | English | Chartered Accoutant | 161546310001 | ||||
AINSCOUGH, Paul Wayne | Secrétaire | 22 Carrbrook Drive Atherton M46 9HT Manchester Lancashire | British | 1876370001 | ||||||
ASHMAN, Linda Margaret | Secrétaire | Blue Fields 421 Huddersfield Road, Shelley HD8 8NE Woodhouse Huddersfield West Yorkshire | British | Solicitor & Company Secretary | 86730910001 | |||||
PEPPER, Teresa Christina | Secrétaire | 20 Blakefield Drive Worsley M28 7DW Manchester Lancashire | British | Finance Director | 63024230001 | |||||
TULLEY, Karen Ann | Secrétaire | Knottside Farm The Knott, Pateley Bridge HG3 5DQ Harrogate North Yorkshire | British | Solicitor | 59112980002 | |||||
AINSCOUGH, Paul Wayne | Administrateur | Apartment 301 Valley Mill Cottonfields Eagley Brook BL7 9DY Bolton Lancashire | England | British | Finance Director | 1876370002 | ||||
AINSCOUGH, Paul Wayne | Administrateur | 22 Carrbrook Drive Atherton M46 9HT Manchester Lancashire | British | Finance Director | 1876370001 | |||||
BROADHEAD, Anthony David | Administrateur | 19 Goldcrest Court Netherton HD4 7LN Huddersfield West Yorkshire | British | Operations Director | 12354680001 | |||||
BROWN, Christopher John | Administrateur | The Grange Bent Lane Sutton In Craven BD20 7AL Keighley West Yorkshire | England | British | Company Director | 1698880001 | ||||
CLARK, William | Administrateur | Wellcroft 10 Shepley Road Stocksmoor HD4 6XW Huddersfield West Yorkshire | British | Company Director | 12354650001 | |||||
COOK, Christopher David | Administrateur | Beauchamp House Church Road CV35 8AN Sherbourne Warwickshire | United Kingdom | British | Company Director | 1698890001 | ||||
ELSBORG, Anton Cecil | Administrateur | Woodstock Thorpe Lane LS20 8LE Leeds West Yorkshire | England | British | Group Finance Director | 93041580001 | ||||
HOLLAND, Mark Harry | Administrateur | 219 Huddersfield Road Thongsbridge HD9 3TT Holmfirth West Yorkshire | United Kingdom | British | Accountant | 98168130001 | ||||
MADGE, John Gordon | Administrateur | 23 Greenway Honley HD7 2BZ Huddersfield West Yorkshire | British | Managing Director | 1866470001 | |||||
NAYLOR, Clive Derick | Administrateur | 1 Albany Drive HD5 9UR Huddersfield West Yorkshire | British | Sales Director | 12354660001 | |||||
PENNING, Graham Michael | Administrateur | 36 Riley Park Kirkburton HD8 0SA Huddersfield West Yorkshire | England | British | Vice President Of Engineering | 12354670001 | ||||
PENNING, Graham Michael | Administrateur | 36 Riley Park Kirkburton HD8 0SA Huddersfield West Yorkshire | England | British | Operations Director | 12354670001 | ||||
PEPPER, Teresa Christina | Administrateur | 20 Blakefield Drive Worsley M28 7DW Manchester Lancashire | British | Finance Director | 63024230001 | |||||
PRIDEAUX, Christopher Clive | Administrateur | 21a Primrose Lane Kirkburton HD8 0QY Huddersfield West Yorkshire | England | British | Director | 64753680001 | ||||
WHITAKER, Richard Brian | Administrateur | 48 Ryefields Scholes Holmfirth HD7 1XF Huddersfield West Yorkshire | British | Company Director | 70342650001 |
DAVID BROWN SPECIAL PRODUCTS LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Guarantee and debenture | Créé le 24 sept. 1992 Livré le 07 oct. 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums and liabilities (without limitation) due or to become due from the company and the obligors (as defined in the debenture) to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions See form 395 ref m*90. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee & debentrue | Créé le 24 janv. 1990 Livré le 06 févr. 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the senior credit agreement dated 24.1.90 and the other financing documents. | |
Brèves mentions (See 395 ref M90 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee and debenture | Créé le 24 janv. 1990 Livré le 05 févr. 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or each obligor (as defined) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the financing documents (as defined) and this charge. | |
Brèves mentions Second shares, dividends, licences & copyrights (for further details see form 395 and continuation sheets relevant to this charge).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture | Créé le 27 juin 1989 Livré le 04 juil. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Single debenture | Créé le 27 juin 1989 Livré le 30 juin 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 08 mai 1989 Livré le 15 mai 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0