DANKS HOLDINGS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | DANKS HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 00328871 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe DANKS HOLDINGS LIMITED ?
| Adresse du siège social | Nottingham Road Loughborough LE11 1EX Leicestershire England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de DANKS HOLDINGS LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour DANKS HOLDINGS LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 02 oct. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 16 oct. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 02 oct. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour DANKS HOLDINGS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cessation de la nomination de Stephanie Woodmass en tant que directeur le 04 déc. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Elaine Kathryn Ames en tant qu'administrateur le 04 déc. 2025 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Nicolas Robert Louis Pitrat en tant que directeur le 04 déc. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Richard Alexander Hiley en tant qu'administrateur le 04 déc. 2025 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Statuts | 30 pages | MA | ||||||||||
Statuts | 30 pages | MA | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 3 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Inscription de la charge 003288710002, créée le 28 oct. 2025 | 17 pages | MR01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 02 oct. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2024 | 2 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Richard French en tant que secrétaire le 12 sept. 2025 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Nomination de Mr Richard Anthony Lister French en tant qu'administrateur le 12 sept. 2025 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Benjamin Peter Thexton Hewitson en tant que directeur le 12 sept. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Benjamin Peter Thexton Hewitson en tant que secrétaire le 12 sept. 2025 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2023 | 2 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 02 oct. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Christian Bernard Lordereau en tant que directeur le 10 nov. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 02 oct. 2023 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2022 | 2 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de . Nottingham Road Loughborough Leicestershire United Kingdom à Nottingham Road Loughborough Leicestershire LE11 1EX le 24 mai 2023 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination de Miss Stephanie Woodmass en tant qu'administrateur le 05 avr. 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Christopher David Abbott en tant que directeur le 02 mars 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Brush Group Nottingham Road Loughborough Leicestershire LE11 1EX United Kingdom à . Nottingham Road Loughborough Leicestershire le 05 janv. 2023 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Modification des détails de Brush Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 07 oct. 2022 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Notification de Brush Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 07 oct. 2022 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de DANKS HOLDINGS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRENCH, Richard | Secrétaire | Loughborough LE11 1EX Leicestershire Nottingham Road England | 340189690001 | |||||||
| AMES, Elaine Kathryn | Administrateur | Loughborough LE11 1EX Leicestershire Nottingham Road England | England | British | 341085900001 | |||||
| FRENCH, Richard Anthony Lister | Administrateur | Loughborough LE11 1EX Leicestershire Nottingham Road England | England | British | 322614190001 | |||||
| HILEY, Richard Alexander | Administrateur | Loughborough LE11 1EX Leicestershire Nottingham Road England | England | British | 343465300001 | |||||
| BARNES, Garry Elliot, Mr. | Secrétaire | Arden Road B49 6HN Alcester Precision House Warwicks | British | 261469100001 | ||||||
| CRAWFORD, Jonathon Colin Fyfe | Secrétaire | Excelsior Road LE65 1BU Ashby-De-La-Zouch Power House England | 216388040001 | |||||||
| HEWITSON, Benjamin Peter Thexton | Secrétaire | Loughborough LE11 1EX Leicestershire Nottingham Road England | 284593610001 | |||||||
| PORTER, Michael James Robert | Secrétaire | Apartment 14 Ryburn Barkisland Mill Beestonley Lane Barkisland HX4 0HF Halifax West Yorkshire | British | 22243580004 | ||||||
| VENTRELLA, Antonio | Secrétaire | 21 Lady Byron Lane Knowle B93 9AT Solihull West Midlands | British,Italian | 102751250001 | ||||||
| WESTLEY, Adam David Christopher | Secrétaire | The Colmore Building 20 Colmore Circus B4 6AT Birmingham 11th Floor | 182816210001 | |||||||
| ABBOTT, Christopher David | Administrateur | Nottingham Road Loughborough . Leicestershire United Kingdom | England | British | 284593720002 | |||||
| BAMFORD, Neil | Administrateur | Mires Farm Back O'The Heights Rishworth HX6 4RF Sowerby Bridge West Yorkshire | British | 10167540002 | ||||||
| BAMFORD, Neil | Administrateur | Mires Farm Back O'The Heights Rishworth HX6 4RF Sowerby Bridge West Yorkshire | British | 10167540002 | ||||||
| BARNES, Garry Elliot, Mr. | Administrateur | Excelsior Road LE65 1BU Ashby-De-La-Zouch Power House England | England | British | 261469100001 | |||||
| BEESTON, Robert Geoffrey | Administrateur | Battledown Manor Greenway Lane, Charlton Kings GL52 6PN Cheltenham Gloucestershire | United Kingdom | British | 89006940001 | |||||
| BILES, John Anthony | Administrateur | The Old Manor Cliftons Lane RH2 9RA Reigate Surrey | England | British | 143968860002 | |||||
| BIRD, Derek Kenneth | Administrateur | 74 Bradmore Way CR5 1PB Coulsdon Surrey | United Kingdom | British | 46344650001 | |||||
| BOWERS, Eric John | Administrateur | The Viewlands Longridge Dunston ST18 9AL Stafford Staffordshire | British | 57549940001 | ||||||
| BROOKES, Michael | Administrateur | Woodpeckers Stoke Row RG9 5PL Henley On Thames Oxfordshire | British | 41998410001 | ||||||
| COOPER, Alan George | Administrateur | 110 Westhall Road CR6 9HD Warlingham Surrey | British | 9663280001 | ||||||
| HEIDEN, Paul | Administrateur | Falcon Works PO BOX 7713 Meadow Lane LE11 1ZF Loughborough Leicestershire | British | 46366470004 | ||||||
| HEWITSON, Benjamin Peter Thexton | Administrateur | Loughborough LE11 1EX Leicestershire Nottingham Road England | United Kingdom | British | 214973510001 | |||||
| HILL, Geoffrey John | Administrateur | 48 Wergs Road Tettenhall WV6 8TD Wolverhampton West Midlands | British | 31122300001 | ||||||
| JAMESON, Barry | Administrateur | Cherry Cottage 2 Beechwood Lane Culcheth WA3 4HJ Warrington Lancashire | United Kingdom | British | 13452550001 | |||||
| JONES, John Richard | Administrateur | 1515 Oak Hollow 18380 Milford Mi Usa | American | 31122310002 | ||||||
| LORDEREAU, Christian Bernard | Administrateur | Loughborough LE11 1EX Leicestershire Nottingham Road England | United Kingdom | French,British | 284575870001 | |||||
| MARTIN, Geoffrey Peter | Administrateur | Arden Road B49 6HN Alcester Precision House Warwicks | United Kingdom | British | 70138900002 | |||||
| MORGAN, Geoffrey Damien | Administrateur | Excelsior Road LE65 1BU Ashby-De-La-Zouch Power House England | England | British | 137426690001 | |||||
| NORTH, William Arthur | Administrateur | Hall Farm Mamble DY14 9JY Kidderminster Worcestershire | British | 31122320001 | ||||||
| PECKHAM, Simon Antony | Administrateur | Arden Road B49 6HN Alcester Precision House Warwicks | United Kingdom | British | 105740640001 | |||||
| PELCZER, Jeremy David | Administrateur | Jemila Mill Lane TA11 7BQ Charlton Mackrell Somerset | British | 109256680001 | ||||||
| PITRAT, Nicolas Robert Louis | Administrateur | Loughborough LE11 1EX Leicestershire Nottingham Road England | England | British,French | 284563830001 | |||||
| PORTER, Michael James Robert | Administrateur | Apartment 14 Ryburn Barkisland Mill Beestonley Lane Barkisland HX4 0HF Halifax West Yorkshire | British | 22243580004 | ||||||
| RICHARDS, Matthew John | Administrateur | Excelsior Road LE65 1BU Ashby-De-La-Zouch Power House England | United Kingdom | British | 252554440001 | |||||
| WOODMASS, Stephanie | Administrateur | Loughborough LE11 1EX Leicestershire Nottingham Road England | England | British | 307761210001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur DANKS HOLDINGS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brush Group Limited | 07 oct. 2022 | Nottingham Road LE11 1EX Loughborough Brush Group Leicestershire United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Brush Electrical Machines Limited | 03 déc. 2019 | Excelsior Road LE65 1BU Ashby-De-La-Zouch Power House England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Brush Holdings Limited | 25 avr. 2016 | The Colmore Building 20 Colmore Circus Queensway B4 6AT Birmingham 11th Floor United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0